Buscador CIF Logo

Actos BORME Cemengal Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cemengal Sa

Actos BORME Cemengal Sa - A80540461

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Cemengal Sa con CIF A80540461

馃敊 Perfil de Cemengal Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Cemengal Sa

04 de Octubre de 2023
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 41489 , F 17, S 8, H M 124346, I/A 42 (27.09.23).

31 de Marzo de 2023
Nombramientos. Auditor: AUDRIA SL. Datos registrales. T 41489 , F 16, S 8, H M 124346, I/A 41 (24.03.23).

08 de Septiembre de 2021
Reelecciones. Consejero: DEL FRATE DARIO;GONZALEZ GALLEGO ANTONIO. Presidente: GONZALEZ GALLEGO ANTONIO.Consejero: GONZALEZ MATEO ALEJANDRO;GONZALEZ MATEO PATRICIA. Con.Delegado: GONZALEZ GALLEGO ANTONIO.Consejero: GONZALEZ HERRERA JUAN ANDRES;VERA RUIZ-CASTELLANOS AURELIO. Secretario: GONZALEZ HERRERA JUANANDRES. Datos registrales. T 41489 , F 16, S 8, H M 124346, I/A 40 ( 1.09.21).

08 de Abril de 2021
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CUBEGA SISTEMAS DE FILTROS DIVISION DOS SA. P茅rdida del caracter deunipersonalidad. Datos registrales. T 41489 , F 15, S 8, H M 124346, I/A 39 (30.03.21).

25 de Marzo de 2021
Modificaciones estatutarias. 4. Modificaci贸n de los art铆culos 4潞 y 11潞 de los estatutos sociales y refundici贸n de los mismos.. Datosregistrales. T 31018 , F 40, S 8, H M 124346, I/A 37 (17.03.21).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BLECUA LEGAL SLP. Representan: JIMENEZ RUIZ-GALVEZ MARIA ALMUDENA.Nombramientos. Secretario: GONZALEZ HERRERA JUAN ANDRES. Datos registrales. T 41489 , F 15, S 8, H M 124346, I/A 38(17.03.21).

05 de Agosto de 2019
Reelecciones. Auditor: AUDRIA SL. Datos registrales. T 31018 , F 40, S 8, H M 124346, I/A 36 (29.07.19).

02 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Auditor: AUDRIA SL. Datos registrales. T 31018 , F 40, S 8, H M 124346, I/A 35 (23.11.16).

13 de Octubre de 2016
Nombramientos. Consejero: GONZALEZ HERRERA JUAN ANDRES;VERA RUIZ-CASTELLANOS AURELIO. Otros conceptos:Rectificaci贸n de inscripci贸n 24陋 en cuanto al nombre completo del Consejero alli reelegido Don Aurelio Vera Ruiz con DNI 00395.575-Ksiendo el nombre correcto Don Arurlio Vera Ruiz-Castellanos. Datos registrales. T 31018 , F 40, S 8, H M 124346, I/A 34 ( 4.10.16).

04 de Octubre de 2016
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 31018 , F 39, S 8, H M 124346, I/A 33 (26.09.16).

26 de Septiembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GONZALEZ GALLEGO ANTONIO. Consejero: GONZALEZ MATEO PATRICIA;GONZALEZMATEO ALEJANDRO. SecreNoConsj: BLECUA LEGAL SLP. Representan: JIMENEZ RUIZ-GALVEZ MARIA ALMUDENA.Nombramientos. SecreNoConsj: BLECUA LEGAL SLP. Representan: JIMENEZ RUIZ-GALVEZ MARIA ALMUDENA. Consejero:

16 de Marzo de 2016
Ceses/Dimisiones. Secretario: GONZALEZ HERRERA JUAN ANDRES. Nombramientos. SecreNoConsj: BLECUA LEGAL SLP.Representan: JIMENEZ RUIZ-GALVEZ MARIA ALMUDENA. Consejero: GONZALEZ MATEO PATRICIA;GONZALEZ MATEOALEJANDRO. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datosregistrales. T 31018 , F 37, S 8, H M 124346, I/A 31 ( 4.03.16).

29 de Octubre de 2015
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 37.863,90 Euros. Desembolsado: 37.863,90 Euros. Resultante Suscrito: 248.218,14 Euros.Resultante Desembolsado: 248.218,14 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5潞. Capital.-. Datosregistrales. T 31018 , F 36, S 8, H M 124346, I/A 30 (21.10.15).

06 de Febrero de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: BETTONI GIUSEPPE. Datos registrales. T 31018 , F 36, S 8, H M 124346, I/A 29 (29.01.15).

11 de Marzo de 2014
Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 31018 , F 36, S 8, H M 124346, I/A 28(28.02.14).

13 de Junio de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMAGNI ROBERTO. Datos registrales. T 31018 , F 36, S 8, H M 124346, I/A 27 ( 5.06.13).

14 de Febrero de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 16140 , F 159, S 8, H M 124346, I/A 26 (7.02.13).

26 de Octubre de 2012
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HERRERA JUAN ANDRES. Datos registrales. T 16140 , F 158, S 8, H M 124346, I/A 25(16.10.12).

16 de Junio de 2011
Nombramientos. Consejero: DEL FRATE DARIO. Reelecciones. Consejero: GONZALEZ GALLEGO ANTONIO;GONZALEZHERRERA JUAN ANDRES;VERA RUIZ AURELIO;CAMAGNI ROBERTO;BETTONI GIUSEPPE. Presidente: GONZALEZ GALLEGOANTONIO. Secretario: GONZALEZ HERRERA JUAN ANDRES. Con.Delegado: GONZALEZ GALLEGO ANTONIO. Datos registrales.T 16140 , F 158, S 8, H M 124346, I/A 24 ( 3.06.11).

19 de Abril de 2010
Nombramientos. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 16140 , F 157, S 8, H M124346, I/A 23 ( 5.04.10).

20 de Mayo de 2009
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HERRERA JUAN ANDRES. Datos registrales. T 16140 , F 157, S 8, H M 124346, I/A 22( 8.05.09).

07 de Abril de 2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 16140 , F 157, S 8, H M 124346, I/A 21 (27.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n