Actos BORME de Cementos Tudela Veguin Sa
29 de Diciembre de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3936 , F 150, S 8, H AS 43144, I/A23 (21.12.23).
22 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3936 , F 150, S 8, H AS 43144, I/A22 (14.12.22).
22 de Julio de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: PAREDES CASTA脩ON JAVIER. Apo.Sol.: PAREDES CASTA脩ON JAVIER. Apo.Manc.: GONZALEZVIDAL JOSE CANDIDO. Apo.Sol.: GONZALEZ VIDAL JOSE CANDIDO. Apo.Manc.: MARTINEZ MIER EMILIO. Apo.Sol.: MARTINEZMIER EMILIO. Apo.Manc.: MENENDEZ DIAZ IVAN LUIS. Apo.Sol.: MENENDEZ DIAZ IVAN LUIS. Apo.Manc.: SASTRE FERNANDEZSANTIAGO. Apo.Sol.: SASTRE FERNANDEZ SANTIAGO. Nombramientos. Apo.Sol.: SASTRE FERNANDEZSANTIAGO;MENENDEZ DIAZ IVAN LUIS;PAREDES CASTA脩ON JAVIER;MARTINEZ MIER EMILIO;SERRANO CORTINA JORGE.Apo.Manc.: SASTRE FERNANDEZ SANTIAGO;MENENDEZ DIAZ IVAN LUIS;PAREDES CASTA脩ON JAVIER;MARTINEZ MIEREMILIO;SERRANO CORTINA JORGE. Datos registrales. T 3936 , F 149, S 8, H AS 43144, I/A 21 (13.07.22).
05 de Noviembre de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3936 , F 149, S 8, H AS 43144, I/A20 (27.10.21).
08 de Enero de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3936 , F 149, S 8, H AS 43144, I/A19 (29.12.20).
18 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: SASTRE FERNANDEZ SANTIAGO;SANCHEZ LAVANDERA JAIME;PAREDES CASTA脩ONJAVIER;MARTINEZ MIER EMILIO;GONZALEZ VIDAL JOSE CANDIDO. Apo.Manc.: SASTRE FERNANDEZ SANTIAGO;SANCHEZLAVANDERA JAIME;PAREDES CASTA脩ON JAVIER;MARTINEZ MIER EMILIO;GONZALEZ VIDAL JOSE CANDIDO.Nombramientos. Apo.Sol.: SASTRE FERNANDEZ SANTIAGO;MENENDEZ DIAZ IVAN LUIS;PAREDES CASTA脩ONJAVIER;MARTINEZ MIER EMILIO;GONZALEZ VIDAL JOSE CANDIDO. Apo.Manc.: SASTRE FERNANDEZ SANTIAGO;MENENDEZDIAZ IVAN LUIS;PAREDES CASTA脩ON JAVIER;MARTINEZ MIER EMILIO;GONZALEZ VIDAL JOSE CANDIDO. Datos registrales.T 3936 , F 148, S 8, H AS 43144, I/A 18 (11.11.19).
09 de Septiembre de 2019Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3936 , F 148, S 8, H AS 43144, I/A17 (27.08.19).
30 de Julio de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3936 , F 148, S 8, H AS 43144, I/A16 (23.07.18).
20 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: MORALES PLAZA JOSE IGNACIO. SecreNoConsj: GONZALEZ APARICIO JESUS.Nombramientos. Consejero: VAZQUEZ DE LAPUERTA FERNANDO. SecreNoConsj: GONZALEZ MENENDEZ IGNACIO.Reelecciones. Consejero: MASAVEU HERRERO FERNANDO MARIA;FERNANDEZ FERNANDEZ FELIPE;ROZA FRESNOVICTOR;PELAEZ GONZALEZ JULIO;SANCHEZ RODRIGUEZ ALVARO. Datos registrales. T 3936 , F 148, S 8, H AS 43144, I/A 15(12.04.18).
02 de Febrero de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3936 , F 148, S 8, H AS 43144, I/A14 (24.01.18).
19 de Diciembre de 2016Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3936 , F 147, S 8, H AS 43144, I/A13 ( 9.12.16).
03 de Diciembre de 2015Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3936 , F 147, S 8, H AS 43144, I/A12 (24.11.15).
25 de Agosto de 2015Otros conceptos: Modificaci贸n y refundici贸n de Estatutos. Datos registrales. T 3936 , F 139, S 8, H AS 43144, I/A 11 (17.08.15).
12 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3936 , F 139, S 8, H AS 43144, I/A10 ( 3.12.14).
01 de Septiembre de 2014Modificaciones estatutarias. 29. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 3936 , F 139, S 8, H AS 43144, I/A 9(20.08.14).
27 de Julio de 2012Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: MASAVEU INDUSTRIA SL. Datos registrales. T 3936 , F 138, S 8,H AS 43144, I/A 8 (17.07.12).
26 de Julio de 2012Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CORPORACION MASAVEU SA. Datos registrales. T 3936 , F 129, S 8, H AS43144, I/A 1 (25.11.11).
20 de Febrero de 2012Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3936 , F 138, S 8, H AS 43144,I/A 7 ( 8.02.12).
24 de Enero de 2012Nombramientos. Apoderado: MASAVEU HERRERO FERNANDO MARIA. Datos registrales. T 3936 , F 137, S 8, H AS 43144, I/A 5(12.01.12).
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ CHIRINO LUIS. Datos registrales. T 3936 , F 138, S 8, H AS 43144, I/A 6 (12.01.12).
09 de Diciembre de 2011Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 7.11.11. Objeto social: Fabricaci贸n, comercializaci贸n y transporte, con medios propios oajenos detoda clase de cementos, cales, yesos y escayolas, sus componentes y derivados, as铆 como de los materiales en que entrenaquellos como base. La fabricaci贸n y comercializacion de hormig贸n preparado, desde planta spropias o ajen. Domicilio: C/ARGUELLES 25 (OVIEDO). Capital suscrito: 10.500.000,00 Euros. Desembolsado: 10.500.000,00 Euros. Nombramientos.Consejero: MASAVEU HERRERO FERNANDO MARIA;FERNANDEZ FERNANDEZ FELIPE;ROZA FRESNO VICTOR;PELAEZGONZALEZ JULIO;SANCHEZ RODRIGUEZ ALVARO;MORALES PLAZA JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 3936 , F 129, S 8, HAS 43144, I/A 1 (25.11.11).
Nombramientos. SecreNoConsj: GONZALEZ APARICIO JESUS. Presidente: MASAVEU HERRERO FERNANDO MARIA. Datosregistrales. T 3936 , F 136, S 8, H AS 43144, I/A 2 (25.11.11).
Nombramientos. Apoderado: PELAEZ GONZALEZ JULIO. Datos registrales. T 3936 , F 136, S 8, H AS 43144, I/A 3 (25.11.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: SASTRE FERNANDEZ SANTIAGO;SANCHEZ LAVANDERA JAIME;PAREDES CASTA脩ONJAVIER;MARTINEZ MIER EMILIO;GONZALEZ VIDAL JOSE CANDIDO. Apo.Manc.: SASTRE FERNANDEZ SANTIAGO;SANCHEZLAVANDERA JAIME;PAREDES CASTA脩ON JAVIER;MARTINEZ MIER EMILIO;GONZALEZ VIDAL JOSE CANDIDO. Datosregistrales. T 3936 , F 137, S 8, H AS 43144, I/A 4 (25.11.11).