Actos BORME de Central De Compras Y Servicios Profesionales Sa
01 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA FILLOL JUAN. Nombramientos. SecreNoConsj: CASAS CASALS ANA CATALINA.Datos registrales. T 30463 , F 159, S 8, H M 75612, I/A 27 (25.01.23).
01 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: MENENDEZ TORRALBA CRISTINA. Apoderado: MENENDEZ TORRALBA CRISTINA. Datos registrales.T 30463 , F 158, S 8, H M 75612, I/A 26 (24.11.22).
30 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO. Datos registrales. T 30463 , F 151, S 8, H M 75612, I/A 22(23.03.22).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO;MARTIN ALONSO RAFAEL;TRAUTWEIN ANDREAS;FRANZENFRAU ANNEGRET. Presidente: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO. Con.Delegado: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO.Nombramientos. Consejero: EHLIS GUNTHER ALEJANDRO. Presidente: EHLIS GUNTHER ALEJANDRO. Consejero: TRAUTWEINANDREAS;EHLIS PIRRETAS IGNACIO;FRANZEN ANNEGRET. Datos registrales. T 30463 , F 151, S 8, H M 75612, I/A 23(23.03.22).
17 de Febrero de 2021Nombramientos. Con.Delegado: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO. Datos registrales. T 30463 , F 150, S 8, H M 75612, I/A 21 (9.02.21).
09 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO;MARTIN ALFONSO RAFAEL;TRAUTWEIN ANDREAS;ADORFHANS-JURGEN. Presidente: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO. Con.Delegado: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO.Nombramientos. Consejero: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO;MARTIN ALONSO RAFAEL;TRAUTWEIN ANDREAS;FRANZENFRAU ANNEGRET. Presidente: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO. Datos registrales. T 30463 , F 150, S 8, H M 75612, I/A 20 (2.10.20).
17 de Mayo de 2019Nombramientos. Apoderado: MENENDEZ TORRALBA CRISTINA. Datos registrales. T 30463 , F 148, S 8, H M 75612, I/A 19 (9.05.19).
02 de Febrero de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: CARRERAS TORRES MANUEL. Nombramientos. Apoderado: MARTIN ALFONSO RAFAEL. Datosregistrales. T 30463 , F 147, S 8, H M 75612, I/A 18 (25.01.17).
12 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO. Presidente: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO. Con.Delegado:MENENDEZ MENENDEZ BALBINO. Consejero: MARTIN ALFONSO RAFAEL;TRAUTWEIN ANDREAS;ADORF HANS-JURGEN.Nombramientos. Consejero: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO;MARTIN ALFONSO RAFAEL;TRAUTWEIN ANDREAS;ADORFHANS-JURGEN. Presidente: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO. Con.Delegado: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO.Modificaciones estatutarias. 21. Duración.- . Datos registrales. T 30463 , F 146, S 8, H M 75612, I/A 17 ( 4.08.15).
27 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: BAUR PETER FRANZ. Nombramientos. Consejero: ADORF HANS-JURGEN. Datos registrales. T30463 , F 146, S 8, H M 75612, I/A 16 (17.10.14).
26 de Febrero de 2013Revocaciones. Apoderado: MARTIN ALFONSO RAFAEL;CARRERAS TORRES MANUEL. Datos registrales. T 4594 , F 225, S 8, HM 75612, I/A 14 (19.02.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: CARRERAS TORRES MANUEL;MENENDEZ TORRALBA CRISTINA. Datos registrales. T 4594 , F 225,S 8, H M 75612, I/A 15 (19.02.13).
11 de Octubre de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO. Nombramientos. Consejero: MENENDEZ MENENDEZBALBINO. Presidente: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO. Con.Delegado: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO. Consejero: MARTINALFONSO RAFAEL;TRAUTWEIN ANDREAS;FRANZ BAUR PETER. SecreNoConsj: GARCIA FILLOL JUAN. Ampliación de capital.Suscrito: 100.703,56 Euros. Desembolsado: 100.703,56 Euros. Resultante Suscrito: 401.203,56 Euros. Resultante Desembolsado:401.203,56 Euros. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo deadministración. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 1º, 2º, 7º, 8º, 12º, 13º, 15º, 16º, 17º, 18º, Y 19º, Y SE AÑADEN LOS ARTICULOS20º, 21º, 22º Y 23º. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE REALIZA UNA REFUNDICION DE LA TOTALIDAD DE LOSESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 4594 , F 220, S 8, H M 75612, I/A 13 ( 2.10.12).
24 de Febrero de 2010Reelecciones. Adm. Unico: MENENDEZ MENENDEZ BALBINO. Datos registrales. T 4594 , F 220, S 8, H M 75612, I/A 12(15.02.10).