Buscador CIF Logo

Actos BORME Centrales Electricas Ruiperez Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Centrales Electricas Ruiperez Sa

Actos BORME Centrales Electricas Ruiperez Sa - A78320249

Tenemos registrados 16 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Centrales Electricas Ruiperez Sa con CIF A78320249

馃敊 Perfil de Centrales Electricas Ruiperez Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Centrales Electricas Ruiperez Sa

13 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: NAVARRO HOMET ABEL;NAVARRO SANCHEZ SICILIA ALMUDENA;GONZALEZ RUIZIVAN;RODRIGUEZ LOSADA AGUADO PILAR;NAVARRO IGLESIAS JULIAN. Presidente: NAVARRO IGLESIAS JULIAN. Secretario:GONZALEZ RUIZ IVAN. Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ MARQUEZ HUMBERTO;ANTIGUEDAD JIMENEZ JOSEMARIA;VALIENTE Y SAEZ DEL BURGO JORGE;MONTALVO GARRIDO ANGEL;MARQUIEGUI RODRIGUEZ JOSEMARIA;GONZALEZ MARTIN MIGUEL ANGEL;FERNANDEZ-MURO ALVAREZ JESUS. Apo.Sol.: QUIROGA FERNANDEZ LADREDAJUAN FRANCISCO;MARQUIEGUI RODRIGUEZ JOSE MARIA. Apoderado: MANCHON RODRIGUEZ LUIS ANGEL.Nombramientos. Liquidador: RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA GEMA. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T33136 , F 179, S 8, H M 43351, I/A 36 ( 4.12.19).

05 de Julio de 2017
Revocaciones. Apoderado: DE CASTRO DEL AMO MARIANO. Datos registrales. T 33136 , F 179, S 8, H M 43351, I/A 35(28.06.17).

23 de Junio de 2017
Revocaciones. Auditor: MUFERMA CONSULTORES Y AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: HORWATH AUDITORESESPA脩A SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 33136 , F 178, S 8, H M 43351, I/A 32 (15.06.17).

Nombramientos. Apoderado: MANCHON RODRIGUEZ LUIS ANGEL. Datos registrales. T 33136 , F 178, S 8, H M 43351, I/A 33(15.06.17).

Ceses/Dimisiones. Secretario: MU脩OZ CORDEU GONZALO. Consejero: MU脩OZ CORDEU GONZALO. Nombramientos.Secretario: GONZALEZ RUIZ IVAN. Datos registrales. T 33136 , F 179, S 8, H M 43351, I/A 34 (15.06.17).

08 de Febrero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: NAVARRO IGLESIAS JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: NAVARRO HOMET ABEL.Reelecciones. Consejero: NAVARRO SANCHEZ SICILIA ALMUDENA;GONZALEZ RUIZ IVAN. Secretario: MU脩OZ CORDEUGONZALO. Consejero: MU脩OZ CORDEU GONZALO;RODRIGUEZ LOSADA AGUADO PILAR;NAVARRO IGLESIAS JULIAN.Presidente: NAVARRO IGLESIAS JULIAN. Datos registrales. T 33136 , F 177, S 8, H M 43351, I/A 31 ( 1.02.16).

26 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Auditor: MUFERMA CONSULTORES Y AUDITORES SLP. Datos registrales. T 33136 , F 177, S 8, H M 43351, I/A30 (18.11.15).

25 de Noviembre de 2015
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.000.006,28 Euros. Resultante Suscrito: 999.994,24 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 33136 , F 176, S 8, H M 43351, I/A 29 (17.11.15).

23 de Julio de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: QUIROGA FERNANDEZ LADREDA JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 33136 , F 175, S 8, H M43351, I/A 27 (15.07.15).

Nombramientos. Apo.Sol.: MARQUIEGUI RODRIGUEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 33136 , F 176, S 8, H M 43351, I/A 28(15.07.15).

18 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Presidente: NAVARRO IGLESIAS VIRGILIO. Consejero: NAVARRO IGLESIAS VIRGILIO. Nombramientos.Consejero: NAVARRO SANCHEZ SICILIA ALMUDENA. Presidente: NAVARRO IGLESIAS JULIAN. Reelecciones. Consejero:GONZALEZ RUIZ IVAN. Secretario: MU脩OZ CORDEU GONZALO. Consejero: MU脩OZ CORDEU GONZALO;RODRIGUEZ LOSADAAGUADO PILAR;NAVARRO IGLESIAS JULIAN;NAVARRO IGLESIAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 33136 , F 175, S 8, H M43351, I/A 26 (10.06.15).

16 de Abril de 2015
Nombramientos. Apoderado: DE CASTRO DEL AMO MARIANO. Datos registrales. T 2478 , F 186, S 8, H M 43351, I/A 25 (9.04.15).

06 de Febrero de 2013
Reelecciones. Auditor: MUFERMA CONSULTORES Y AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2478 , F 186, S 8, H M 43351, I/A 24(29.01.13).

02 de Junio de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 414.019,48 Euros. Resultante Suscrito: 2.000.000,52 Euros. Datos registrales. T 2478 , F185, S 8, H M 43351, I/A 23 (24.05.11).

13 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREA CUENCA FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ RUIZ IVAN.Reelecciones. Presidente: NAVARRO IGLESIAS VIRGILIO. Secretario: MU脩OZ CORDEU GONZALO. Consejero: MU脩OZ CORDEUGONZALO;RODRIGUEZ LOSADA AGUADO PILAR;NAVARRO IGLESIAS JULIAN;NAVARRO IGLESIAS VIRGILIO;NAVARROIGLESIAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 2478 , F 185, S 8, H M 43351, I/A 22 ( 1.04.11).

03 de Marzo de 2010
Revocaciones. Auditor: MUFERMA SL. Nombramientos. Auditor: MUFERMA CONSULTORES Y AUDITORES SLP. Datosregistrales. T 2478 , F 184, S 8, H M 43351, I/A 21 (22.02.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n