Buscador CIF Logo

Actos BORME Centre Cardio Vascular Sant Jordi Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Centre Cardio Vascular Sant Jordi Sa

Actos BORME Centre Cardio Vascular Sant Jordi Sa - A60050051

Tenemos registrados 41 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Centre Cardio Vascular Sant Jordi Sa con CIF A60050051

馃敊 Perfil de Centre Cardio Vascular Sant Jordi Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Centre Cardio Vascular Sant Jordi Sa

13 de Enero de 2021
Revocaciones. ADM.CONCURS.: GRUPO GISPERT ABOGADOS Y ECONOMISTES SLP. REP.ADM.CONC: GARCIA GARCIAJOSE. Otros conceptos: JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSOVOLUNTARIO 745/2013, AUTO FIRME DE FECHA 13/02/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO. Datos registrales. T 43622 , F 14,S 8, H B 80828, I/A 70 ( 5.01.21).

07 de Diciembre de 2018
Nombramientos. ADM.CONCURS.: GRUPO GISPERT ABOGADOS Y ECONOMISTES SLP. REP.ADM.CONC: GARCIA GARCIAJOSE. Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 745/2013,

14 de Junio de 2017
Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 745/2013, AUTOFIRME DE FECHA 05/05/2017, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD. Extinci贸n.Datos registrales. T 43622 , F 13, S 8, H B 80828, I/A 68 ( 6.06.17).

05 de Enero de 2016
Revocaciones. ADM.CONCURS.: BATLLE MORENO ANTONIO. Nombramientos. ADM.CONCURS.: GRUPO GISPERTABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP. REP.ADM.CONC: GARCIA GARCIA JOSE. Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 10 DEBARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 745/2013, FIRME DE FECHA 16/11/2015, CESE Y NOMBRAMIENTODE ADMINISTRADOR CONCURSAL. Datos registrales. T 43622 , F 13, S 8, H B 80828, I/A 67 (28.12.15).

29 de Octubre de 2014
Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 745/2013, AUTOFIRME DE FECHA 18/07/2014, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 43622 , F 13,S 8, H B 80828, I/A 66 (22.10.14).

05 de Agosto de 2014
Revocaciones. CONSEJERO: FORNELLS ALBANELL EDUARD;BALUST VIDAL JAUME;BARTRINA ROSSELL JORGE.PRESIDENTE: BALUST VIDAL JAUME. SECR.NO CONS: TORENT LOPEZ DE LAMADRID SANTIAGO. Otros conceptos:JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 745/2013, AUTO FIRME DE FECHA14/05/2014, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. Disoluci贸n. Judicial. Datos registrales. T 43622 , F12, S 8, H B 80828, I/A 65 (29.07.14).

17 de Diciembre de 2013
Nombramientos. ADM.CONCURS.: BATLLE MORENO ANTONIO. Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 10 DEBARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 745/2013, AUTO FIRME DE FECHA 29/10/2013,DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 43622 , F 11, S 8, H B 80828, I/A 64(10.12.13).

31 de Mayo de 2013
Revocaciones. CONSEJERO: INSTITUCION TRES TORRES SA. REPR.143 RRM: RAFOLS VIVES ROSER. Datos registrales. T43622 , F 11, S 8, H B 80828, I/A 63 (24.05.13).

26 de Marzo de 2013
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: HORWATH PLM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 42993 , F 20, S 8, H B 80828, I/A 61(14.03.13).

25 de Marzo de 2013
Revocaciones. APODERADO: BALLUS MOLINA RAFAEL. Datos registrales. T 43622 , F 11, S 8, H B 80828, I/A 62 (14.03.13).

04 de Enero de 2013
Cancelaciones de oficio de nombramientos. CONSEJERO: BALUST VIDAL JAUME. PRESIDENTE: BALUST VIDAL JAUME.CONSEJERO: BARTRINA ROSSELL JORDI. SECRETARIO: BARTRINA ROSSELL JORDI. Datos registrales. T 42993 , F 11, S 8, HB 80828, I/A 47 N (13.12.12).

21 de Diciembre de 2012
Nombramientos. CONSEJERO: FORNELLS ALBANELL EDUARD;BALUST VIDAL JAUME;BARTRINA ROSSELLJORGE;INSTITUCION TRES TORRES SA. REPR.143 RRM: RAFOLS VIVES ROSER. Datos registrales. T 42993 , F 18, S 8, H B80828, I/A 58 (13.12.12).

Nombramientos. PRESIDENTE: BALUST VIDAL JAUME. SECR.NO CONS: TORENT LOPEZ DE LAMADRID SANTIAGO. Datosregistrales. T 42993 , F 18, S 8, H B 80828, I/A 59 (13.12.12).

Revocaciones. APODERADO: SERRA MILA MONTSERRAT. Nombramientos. APODERADO: TARRATS OLIVA ALBERT. Datosregistrales. T 42993 , F 19, S 8, H B 80828, I/A 60 (13.12.12).

21 de Agosto de 2012
Revocaciones. CONSEJERO: PUJOL RAFOLS JOAN. Datos registrales. T 42993 , F 17, S 8, H B 80828, I/A 56 ( 7.08.12).

Nombramientos. APODERADO: BARTRINA ROSELL JORGE. Datos registrales. T 42993 , F 17, S 8, H B 80828, I/A 57 ( 7.08.12).

24 de Julio de 2012
Fe de erratas: En el BORME no.96/2012 y con referencia 216265 SE CESO POR ERROR A DON JOAN PUJOL RAFOLS EN SUCARGO DE "CONSEJERO". Datos registrales. T 42993 , F 13, S 8, H B 80828, I/A 51 ( 9.05.12).

17 de Julio de 2012
Revocaciones. APODERADO: PUJOL RAFOLS JOAN. Datos registrales. T 42993 , F 16, S 8, H B 80828, I/A 55 ( 4.07.12).

02 de Julio de 2012
Revocaciones. APODERADO: TEULE VIDAL JAUME. Datos registrales. T 42993 , F 16, S 8, H B 80828, I/A 54 (21.06.12).

19 de Junio de 2012
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 148.840,00 Euros. Desembolsado: 148.840,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.287.317,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.287.317,00 Euros. Datos registrales. T 42993 , F 14, S 8, H B 80828, I/A 53 ( 8.06.12).

14 de Junio de 2012
Nombramientos. APODERADO: BALLUS MOLINA RAFAEL. Datos registrales. T 42993 , F 13, S 8, H B 80828, I/A 52 ( 5.06.12).

23 de Mayo de 2012
Nombramientos. CONS. DELEG.: PUJOL RAFOLS JUAN. Datos registrales. T 42993 , F 12, S 8, H B 80828, I/A 49 ( 9.05.12).

Revocaciones. CONSEJERO: VILADOT PERICE RAMON;PUJOL RAFOLS JOAN. CONS. DELEG.: PUJOL RAFOLS JUAN. Datosregistrales. T 42993 , F 13, S 8, H B 80828, I/A 51 ( 9.05.12).

Revocaciones. CONSEJERO: SERRA MILA MONTSERRAT. CONS. DELEG.: SERRA MILA MONTSERRAT. SECRETARIO:SERRA MILA MONTSERRAT. Nombramientos. SECRETARIO: BARTRINA ROSSELL JORDI. Datos registrales. T 42993 , F 13, S8, H B 80828, I/A 50 ( 9.05.12).

10 de Enero de 2012
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DEBRITTO PEREZ DE AZOFRA JOSE. AUDITOR SUP.: CABEDO GREGORI RODRIGO. Datosregistrales. T 42993 , F 12, S 8, H B 80828, I/A 48 (28.12.11).

28 de Diciembre de 2011
Revocaciones. CONSEJERO: BRUALLA PLANES ANTONIO. PRESIDENTE: BRUALLA PLANES ANTONIO. CONSEJERO:BRUALLA PALAZON DANIEL. SECRETARIO: BRUALLA PALAZON DANIEL. CONSEJERO: BRUGADA TARRADELLAS JOSEP.Nombramientos. SECRETARIO: SERRA MILA MONTSERRAT. CONSEJERO: PUJOL RAFOLS JOAN;BALUST VIDAL JAUME.PRESIDENTE: BALUST VIDAL JAUME. CONSEJERO: BARTRINA ROSSELL JORDI. Datos registrales. T 42993 , F 11, S 8, H B80828, I/A 47 (16.12.11).

13 de Diciembre de 2011
Modificaciones estatutarias. ARTS.38,39 Y 40:TRANSMISION DE ACCIONES. Datos registrales. T 40768 , F 209, S 8, H B80828, I/A 46 (30.11.11).

29 de Noviembre de 2011
Nombramientos. APODERADO: PUJOL RAFOLS JOAN;BALUST VIDAL JAUME. Datos registrales. T 40768 , F 207, S 8, H B80828, I/A 43 (17.11.11).

Nombramientos. APODERADO: TEULE VIDAL JAUME. Datos registrales. T 40768 , F 208, S 8, H B 80828, I/A 44 (17.11.11).

Revocaciones. APODERADO: PLAZA ARNAIZ MARIA DEL CARMEN. GERENTE: PLAZA ARNAIZ MARIA DEL CARMEN. Datosregistrales. T 40768 , F 209, S 8, H B 80828, I/A 45 (17.11.11).

28 de Octubre de 2011
Nombramientos. CONSEJERO: FORNELLS ALBANELL EDUARDO;VILADOT PERICE RAMON. Datos registrales. T 40768 , F207, S 8, H B 80828, I/A 42 (18.10.11).

27 de Octubre de 2011
Revocaciones. CONSEJERO: LAILLA VICENS JOSE MARIA;VILADOT VOEGELI ANTONIO. Nombramientos. CONSEJERO:FORNELLS ALBANELL EDUARDO;VILADOT PERICE RAMON. Datos registrales. T 40768 , F 207, S 8, H B 80828, I/A 41(18.10.11).

09 de Mayo de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DEBRITTO PEREZ DE AZOFRA JOSE. AUDITOR SUP.: CABEDO GREGORI RODRIGO. Datosregistrales. T 40768 , F 206, S 8, H B 80828, I/A 40 (26.04.11).

15 de Abril de 2011
Revocaciones. CONSEJERO: VENDRELL VILA DOMENECH. Datos registrales. T 40768 , F 206, S 8, H B 80828, I/A 39 ( 5.04.11).

10 de Febrero de 2011
Nombramientos. CONSEJERO: BRUALLA PALAZON DANIEL. SECRETARIO: BRUALLA PALAZON DANIEL. CONSEJERO:SERRA MILA MONTSERRAT. CONS. DELEG.: SERRA MILA MONTSERRAT. CONSEJERO: BRUGADA TARRADELLAS JOSEP.Datos registrales. T 40768 , F 206, S 8, H B 80828, I/A 38 (31.01.11).

12 de Agosto de 2010
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 130.235,00 Euros. Desembolsado: 130.235,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.138.477,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.138.477,00 Euros. Datos registrales. T 40768 , F 204, S 8, H B 80828, I/A 37 ( 2.08.10).

03 de Febrero de 2010
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DEBRITTO PEREZ DE AZOFRA JOSE. AUDITOR SUP.: RODRIGUEZ RIQUELME FERNANDO.Datos registrales. T 40768 , F 203, S 8, H B 80828, I/A 35 (21.01.10).

Revocaciones. CONSEJERO: JUBERT ESTIVARIZ JOAQUIM;MONTULL RAFOLS EDUARDO. SECRETARIO: MONTULL RAFOLSEDUARDO. VICESECRET.: BRUALLA PALAZON DANIEL. Nombramientos. CONSEJERO: LAILLA VICENS JOSEMARIA;VILADOT VOEGELI ANTONIO. SECRETARIO: BRUALLA PALAZON DANIEL. Datos registrales. T 40768 , F 203, S 8, H B80828, I/A 36 (21.01.10).

10 de Junio de 2009
Cambio de domicilio social. CL BALMES Num.271 (BARCELONA). Datos registrales. T 40768 , F 203, S 8, H B 80828, I/A 34(28.05.09).

01 de Junio de 2009
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 29.589,94 Euros. Desembolsado: 29.589,94 Euros. Resultante Suscrito: 2.008.242,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.008.242,00 Euros. Datos registrales. T 40768 , F 202, S 8, H B 80828, I/A 33 (20.05.09).

25 de Febrero de 2009
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SJP SERVEIS SANITARIS SL. Datos registrales. T 40768 , F 201, S 8, H B 80828,I/A 32 (13.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n