Actos BORME de Centre Gerontologic Myces Sl
23 de Octubre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: GARMENDIA FERNANDEZ JESUS MARIA;FUENTES DIAZ VIRGINIA. Datos registrales. T 634 , F 19,S 8, H L 9622, I/A 37 (11.10.23).
18 de Agosto de 2023Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 634 , F 19, S 8, H L 9622, I/A 36 ( 9.08.23).
25 de Julio de 2023Revocaciones. Apoderado: GARCIA GARCIA VALENTIN. Datos registrales. T 634 , F 18, S 8, H L 9622, I/A 35 (18.07.23).
26 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GARCIA GARCIA VALENTIN. Nombramientos. Adm. Mancom.: ABAJO MENGUEZ MARIO.Datos registrales. T 632 , F 186, S 8, H L 9622, I/A 33 (15.05.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: ABAJO MENGUEZ MARIO;GARCIA ORTIZ ANTONIO. Datos registrales. T 632 , F 186, S 8, H L 9622,I/A 34 (18.05.23).
10 de Mayo de 2023Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ALEGRE MARIA DOLORES. Datos registrales. T 632 , F 185, S 8, H L 9622, I/A 32 (3.05.23).
04 de Abril de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 632 , F 185, S 8, H L 9622, I/A 31 (24.03.22).
01 de Marzo de 2022Nombramientos. Apoderado: ORTIZ CAS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 632 , F 184, S 8, H L 9622, I/A 30 (22.02.22).
23 de Agosto de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: PELAEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 632 , F 184, S 8, H L 9622, I/A 29(13.08.21).
13 de Agosto de 2021Nombramientos. Apoderado: RUBIO VALOR PABLO. Datos registrales. T 632 , F 183, S 8, H L 9622, I/A 28 ( 5.08.21).
19 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: RUBIO VALOR PABLO. Datos registrales. T 632 , F 182, S 8, H L 9622, I/A 27 (12.03.20).
04 de Marzo de 2019Revocaciones. Apoderado: TERES SUÑE RICARDO RAMON. Datos registrales. T 632 , F 182, S 8, H L 9622, I/A 26 (25.02.19).
18 de Agosto de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL;PELAEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 632 ,F 155, S 8, H L 9622, I/A 24 ( 9.08.17).
Nombramientos. Apoderado: PUBILL CARRO MARIA ANTONIA. Datos registrales. T 632 , F 182, S 8, H L 9622, I/A 25 ( 9.08.17).
23 de Mayo de 2017Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ALEGRE MARIA DOLORES. Datos registrales. T 632 , F 150, S 8, H L 9622, I/A 23(16.05.17).
20 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: TERES SUÑE RICARDO RAMON. Datos registrales. T 632 , F 148, S 8, H L 9622, I/A 22 (11.04.17).
27 de Marzo de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: TERES SUÑE RICARDO RAMON;CARDIL CEREZUELA FERNANDO;SALAZAR PEYRET JOSE MARIA.Datos registrales. T 630 , F 141, S 8, H L 9622, I/A 18 (16.03.17).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA VALENTIN. Datos registrales. T 630 , F 141, S 8, H L 9622, I/A 19 (16.03.17).
Declaración de unipersonalidad. Socio único: CASER RESIDENCIAL INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales.T 632 , F 147, S 8, H L 9622, I/A 20 (16.03.17).
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CARDIL CEREZUELA FERNANDO;SALAZAR PEYRET JOSE MARIA. Nombramientos. Adm.Mancom.: GARCIA GARCIA VALENTIN;GARCIA ORTIZ ANTONIO. Modificaciones estatutarias. Modificación del artículo 15º delos estatutos sociales. Datos registrales. T 632 , F 147, S 8, H L 9622, I/A 21 (16.03.17).
26 de Agosto de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: CARRE CUADRAT ANTONI. Nombramientos. Apo.Manc.: TERES SUÑE RICARDO RAMON;CARDILCEREZUELA FERNANDO;SALAZAR PEYRET JOSE MARIA. Datos registrales. T 630 , F 133, S 8, H L 9622, I/A 17 (17.08.11).
17 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CARDIL CEREZUELA FERNANDO;MORENO ARANDA MIGUEL. Nombramientos. Adm.Mancom.: SALAZAR PEYRET JOSE MARIA;CARDIL CEREZUELA FERNANDO. Datos registrales. T 630 , F 133, S 8, H L 9622, I/A16 ( 4.11.10).