Buscador CIF Logo

Actos BORME Centro De Investigacion Seminal Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Centro De Investigacion Seminal Sociedad Limitada

Actos BORME Centro De Investigacion Seminal Sociedad Limitada - B99061194

Tenemos registrados 16 Actos BORME del Registro Mercantil de Zaragoza para Centro De Investigacion Seminal Sociedad Limitada con CIF B99061194

馃敊 Perfil de Centro De Investigacion Seminal Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Zaragoza

Actos BORME de Centro De Investigacion Seminal Sociedad Limitada

26 de Julio de 2022
Nombramientos. Apoderado: LARRODE ANTO脩ANZAS ISABEL. Datos registrales. T 3898 , F 213, S 8, H Z 39031, I/A 18(15.07.22).

18 de Diciembre de 2018
Otros conceptos: Cambiada la persona f铆sica representante de la consejera "DESARROLLOS INDUSTRIALES SORA, S.L.". Datosregistrales. T 3266 , F 218, S 8, H Z 39031, I/A 17 (11.12.18).

06 de Marzo de 2017
Cambio de objeto social. Arrendamiento de inmuebles. Compraventa, desarrollo, investigaci贸n, importaci贸n y exportaci贸n detecnolog铆a agropecuaria. Cooperaci贸n y proyectos de insvestigaci贸n. Certificaciones anal铆ticas. Explotaciones agropecuarias. Datosregistrales. T 3266 , F 218, S 8, H Z 39031, I/A 16 (24.02.17).

28 de Enero de 2016
Nombramientos. Auditor: TH AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 3266 , F 218, S 8, H Z39031, I/A 15 (21.01.16).

01 de Abril de 2015
Nombramientos. Auditor: SERVICIOS DE ADMINISTRACION CONCURSAL JURIDICA Y E. Datos registrales. T 3266 , F 218, S 8,H Z 39031, I/A 14 (25.03.15).

06 de Noviembre de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 243.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 57.000,00 Euros. Datos registrales. T 3266 , F218, S 8, H Z 39031, I/A 13 (30.10.14).

21 de Marzo de 2014
Nombramientos. Auditor: B & P DE AUDITORIA Y CONSULTORIA SL. Datos registrales. T 3266 , F 217, S 8, H Z 39031, I/A 12(21.02.14).

30 de Octubre de 2013
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL PARRAFO 1潞 DEL ARTICULO 14潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, el cual tendr谩la siguiente redacci贸n: "ARTICULO 14潞. REGLAS. 1. La convocatoria se realizar谩 mediante carta certificada con acuse de recibo, cuyaremisi贸n podr谩 hacerse notarialmente o notificaci贸n notarial, dirigidas a cada uno. Datos registrales. T 3266 , F 217, S 8, H Z 39031,I/A 11 (22.10.13).

09 de Septiembre de 2013
Nombramientos. Presidente: DESARROLLOS INDUSTRIALES SORA SL. Cons.Del.Man: AGROPECUARIA DEL PIRINEO SA.Apoderado: MOLINERO POZA FRANCISCO. Reelecciones. Cons.Del.Man: U V E SOCIEDAD ANONIMA;DESARROLLOSINDUSTRIALES SORA SL. Datos registrales. T 3266 , F 217, S 8, H Z 39031, I/A 10 (29.08.13).

20 de Junio de 2013
Ceses/Dimisiones. Presidente: AGROPECUARIA OBANOS SA. Cons.Del.Man: AGROPECUARIA OBANOS SA. Consejero:AGROPECUARIA OBANOS SA. Cons.Del.Man: MAGAPOR SL. Consejero: MAGAPOR SL. Nombramientos. Consejero:AGROPECUARIA DEL PIRINEO SA. Datos registrales. T 3266 , F 217, S 8, H Z 39031, I/A 9 (12.06.13).

29 de Agosto de 2012
Otros conceptos: Se NOMBRA A DON FRANISCO MOLINERO POZA, como representante de la Sociedad "DESARROLLOSINDUSTRIALES SORAL, S.L.", en sustituci贸n del anterior Don Luis Gonzalo Alayeto Aguar贸n. Datos registrales. T 3266 , F 217, S 8,H Z 39031, I/A 8 (17.08.12).

16 de Mayo de 2012
Otros conceptos: Cesado DON FRANCISCO MOLINERO POZA, como persona f铆sica representante de la Sociedad "UVE, S.A.",Secretaria del Consejo de Administraci贸n de la Sociedad y en sustituci贸n designado DON RAUL GOMEZ ARRANZ. Datosregistrales. T 3266 , F 216, S 8, H Z 39031, I/A 7 ( 3.05.12).

12 de Abril de 2012
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: SERVICIOS GENETICOS PORCINOS SA. Consejero: SERVICIOS GENETICOS PORCINOS SA.Datos registrales. T 3266 , F 216, S 8, H Z 39031, I/A 6 (29.03.12).

29 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: CINCAPORC SOCIEDAD ANONIMA. Vicepresid.: CINCAPORC SOCIEDAD ANONIMA.Consejero: CINCAPORC SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 3266 , F 216, S 8, H Z 39031, I/A 5 (19.03.12).

23 de Septiembre de 2011
Otros conceptos: Se nombra a DON LUIS GONZALO ALAYETO AGUARON representante de la mercantil "Desarrollos IndustrialesSora, S.L.", en sustituci贸n de Don Jos茅 Antonio Alayeto Aguar贸n. Datos registrales. T 3266 , F 216, S 8, H Z 39031, I/A 4 (13.09.11).

24 de Junio de 2009
Cambio de domicilio social. POLIG VALDEFERRIN, CENTRO DE NEGOCIOS, OFICINA 4 (EJEA DE LOS CABALLEROS). Datosregistrales. T 3266 , F 216, S 8, H Z 39031, I/A 3 (12.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n