Actos BORME de Centro De Investigacion Seminal Sociedad Limitada
26 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: LARRODE ANTO脩ANZAS ISABEL. Datos registrales. T 3898 , F 213, S 8, H Z 39031, I/A 18(15.07.22).
18 de Diciembre de 2018Otros conceptos: Cambiada la persona f铆sica representante de la consejera "DESARROLLOS INDUSTRIALES SORA, S.L.". Datosregistrales. T 3266 , F 218, S 8, H Z 39031, I/A 17 (11.12.18).
06 de Marzo de 2017Cambio de objeto social. Arrendamiento de inmuebles. Compraventa, desarrollo, investigaci贸n, importaci贸n y exportaci贸n detecnolog铆a agropecuaria. Cooperaci贸n y proyectos de insvestigaci贸n. Certificaciones anal铆ticas. Explotaciones agropecuarias. Datosregistrales. T 3266 , F 218, S 8, H Z 39031, I/A 16 (24.02.17).
28 de Enero de 2016Nombramientos. Auditor: TH AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 3266 , F 218, S 8, H Z39031, I/A 15 (21.01.16).
01 de Abril de 2015Nombramientos. Auditor: SERVICIOS DE ADMINISTRACION CONCURSAL JURIDICA Y E. Datos registrales. T 3266 , F 218, S 8,H Z 39031, I/A 14 (25.03.15).
06 de Noviembre de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 243.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 57.000,00 Euros. Datos registrales. T 3266 , F218, S 8, H Z 39031, I/A 13 (30.10.14).
21 de Marzo de 2014Nombramientos. Auditor: B & P DE AUDITORIA Y CONSULTORIA SL. Datos registrales. T 3266 , F 217, S 8, H Z 39031, I/A 12(21.02.14).
30 de Octubre de 2013Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL PARRAFO 1潞 DEL ARTICULO 14潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, el cual tendr谩la siguiente redacci贸n: "ARTICULO 14潞. REGLAS. 1. La convocatoria se realizar谩 mediante carta certificada con acuse de recibo, cuyaremisi贸n podr谩 hacerse notarialmente o notificaci贸n notarial, dirigidas a cada uno. Datos registrales. T 3266 , F 217, S 8, H Z 39031,I/A 11 (22.10.13).
09 de Septiembre de 2013Nombramientos. Presidente: DESARROLLOS INDUSTRIALES SORA SL. Cons.Del.Man: AGROPECUARIA DEL PIRINEO SA.Apoderado: MOLINERO POZA FRANCISCO. Reelecciones. Cons.Del.Man: U V E SOCIEDAD ANONIMA;DESARROLLOSINDUSTRIALES SORA SL. Datos registrales. T 3266 , F 217, S 8, H Z 39031, I/A 10 (29.08.13).
20 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Presidente: AGROPECUARIA OBANOS SA. Cons.Del.Man: AGROPECUARIA OBANOS SA. Consejero:AGROPECUARIA OBANOS SA. Cons.Del.Man: MAGAPOR SL. Consejero: MAGAPOR SL. Nombramientos. Consejero:AGROPECUARIA DEL PIRINEO SA. Datos registrales. T 3266 , F 217, S 8, H Z 39031, I/A 9 (12.06.13).
29 de Agosto de 2012Otros conceptos: Se NOMBRA A DON FRANISCO MOLINERO POZA, como representante de la Sociedad "DESARROLLOSINDUSTRIALES SORAL, S.L.", en sustituci贸n del anterior Don Luis Gonzalo Alayeto Aguar贸n. Datos registrales. T 3266 , F 217, S 8,H Z 39031, I/A 8 (17.08.12).
16 de Mayo de 2012Otros conceptos: Cesado DON FRANCISCO MOLINERO POZA, como persona f铆sica representante de la Sociedad "UVE, S.A.",Secretaria del Consejo de Administraci贸n de la Sociedad y en sustituci贸n designado DON RAUL GOMEZ ARRANZ. Datosregistrales. T 3266 , F 216, S 8, H Z 39031, I/A 7 ( 3.05.12).
12 de Abril de 2012Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: SERVICIOS GENETICOS PORCINOS SA. Consejero: SERVICIOS GENETICOS PORCINOS SA.Datos registrales. T 3266 , F 216, S 8, H Z 39031, I/A 6 (29.03.12).
29 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: CINCAPORC SOCIEDAD ANONIMA. Vicepresid.: CINCAPORC SOCIEDAD ANONIMA.Consejero: CINCAPORC SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 3266 , F 216, S 8, H Z 39031, I/A 5 (19.03.12).
23 de Septiembre de 2011Otros conceptos: Se nombra a DON LUIS GONZALO ALAYETO AGUARON representante de la mercantil "Desarrollos IndustrialesSora, S.L.", en sustituci贸n de Don Jos茅 Antonio Alayeto Aguar贸n. Datos registrales. T 3266 , F 216, S 8, H Z 39031, I/A 4 (13.09.11).
24 de Junio de 2009Cambio de domicilio social. POLIG VALDEFERRIN, CENTRO DE NEGOCIOS, OFICINA 4 (EJEA DE LOS CABALLEROS). Datosregistrales. T 3266 , F 216, S 8, H Z 39031, I/A 3 (12.06.09).