Buscador CIF Logo

Actos BORME Centro De Mayores Care Extremadura Dos 2002 Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Centro De Mayores Care Extremadura Dos 2002 Sl

Actos BORME Centro De Mayores Care Extremadura Dos 2002 Sl - B83487611

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Centro De Mayores Care Extremadura Dos 2002 Sl con CIF B83487611

馃敊 Perfil de Centro De Mayores Care Extremadura Dos 2002 Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Centro De Mayores Care Extremadura Dos 2002 Sl

12 de Abril de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: BARCELO MAZARRON LUIS;VALCANERAS DE RODA I脩IGO;MORENO AYMI ENRIQUE;SERRANOBARRIO FERNANDO;DUO DELGADO JOSE LUIS;DOMINGUEZ SANTA MARIA FABIAN;ORTEGA COBO LUISANTONIO;CANTERO FRESNEDA CRISTINA;VICARIO LA CALLE ALFONSO MARIA. Apo.Manc.: NAUDE HURTADOSUSANA;SERRANO BARRIO FERNANDO. Datos registrales. T 41258 , F 36, S 8, H M 317821, I/A 35 ( 3.04.23).

04 de Abril de 2023
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ DEL VALLE CHAVARRI MARTIN;HOLLAND MARTIN ROBERT GEORGE. Apo.Manc.:HOLLAND MARTIN ROBERT GEORGE;GONZALEZ DEL VALLE CHAVARRI MARTIN;ZAMBON NICOLA;HOLLAND MARTINROBERT GEORGE. Datos registrales. T 41258 , F 35, S 8, H M 317821, I/A 34 (28.03.23).

13 de Enero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: MESNARD SEBASTIAN;BATTESTI LOIC DOMINIQUE;CHARRIER PHILIPPE JEAN PIERRE.Presidente: CHARRIER PHILIPPE JEAN PIERRE. VsecrNoConsj: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Revocaciones. Apoderado:MESNARD SEBASTIEN. Nombramientos. Consejero: GUILLOT LAURENT;GIACCARDO BERENGERE;LEMAIRE LAURENT.Presidente: GUILLOT LAURENT. VsecrNoConsj: VICARIO LA CALLE ALFONSO MARIA. Apoderado: GUILLOTLAURENT;GIACCARDO BERENGERE;LEMAIRE LAURENT;AZNAR AZNAR MANUEL;ZARAGOZA LLIRINOS ASUNCION;AZNARAZNAR MANUEL;ZARAGOZA LLIRINOS ASUNCION. Datos registrales. T 41258 , F 33, S 8, H M 317821, I/A 33 ( 5.01.23).

06 de Junio de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: LE MASNE YVES. Presidente: LE MASNE YVES. Nombramientos. Consejero: CHARRIERPHILIPPE JEAN PIERRE. Presidente: CHARRIER PHILIPPE JEAN PIERRE. Datos registrales. T 41258 , F 33, S 8, H M 317821, I/A32 (30.05.22).

14 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apoderado: AZNAR AZNAR MANUEL;ZARAGOZA LLIRINOS ASUNCION. Datos registrales. T 41258 , F 32, S 8,H M 317821, I/A 31 ( 6.10.21).

28 de Junio de 2021
Revocaciones. Apoderado: BRDENK JEAN CLAUDE;BRDENK JEAN CLAUDE. Apo.Sol.: BRDENK JEAN CLAUDE. Datosregistrales. T 41258 , F 32, S 8, H M 317821, I/A 30 (21.06.21).

10 de Marzo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: BRDENK JEAN CLAUDE;ORPEA SA. Representan: MESNARD SEBASTIEN. Nombramientos.Consejero: MESNARD SEBASTIAN;BATTESTI LOIC DOMINIQUE. Datos registrales. T 41258 , F 32, S 8, H M 317821, I/A 29 (3.03.21).

27 de Enero de 2021
Ceses/Dimisiones. Secretario: ALONSO DREGI ALEJANDRO. Nombramientos. SecreNoConsj: SOLCHAGA LOPEZ DE SILANESFRANCISCO. Datos registrales. T 22074 , F 64, S 8, H M 317821, I/A 27 (20.01.21).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22074 , F 64, S 8, H M 317821, I/A 28 (20.01.21).

22 de Enero de 2020
Cambio de domicilio social. PASEO DEL GENERAL MARTINEZ CAMPOS , 46, 7潞 PLANTA, (MADRID). Datos registrales. T22074 , F 64, S 8, H M 317821, I/A 26 (15.01.20).

16 de Noviembre de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22074 , F 64, S 8, H M 317821, I/A 25 ( 8.11.18).

23 de Mayo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARIAN JEAN CLAUDE. Con.Delegado: MARIAN JEAN CLAUDE. Presidente: MARIAN JEANCLAUDE. Nombramientos. Consejero: LE MASNE YVES. Presidente: LE MASNE YVES. Datos registrales. T 22074 , F 63, S 8, HM 317821, I/A 24 (16.05.17).

20 de Abril de 2017
Cambio de domicilio social. C/ MIGUEL ANGEL 26 6陋 (MADRID). Datos registrales. T 22074 , F 63, S 8, H M 317821, I/A 23(11.04.17).

31 de Octubre de 2016
Ampliacion del objeto social. La Promoci贸n y explotaci贸n de Centros de Spa y Balnearios con sus divisiones asociadas tales comohidroterapia, masajes, rehabiliaci贸n, est茅tica y belleza. Datos registrales. T 22074 , F 62, S 8, H M 317821, I/A 22 (20.10.16).

31 de Julio de 2015
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22074 , F 62, S 8, H M 317821, I/A 21 (24.07.15).

29 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Vsecr2.NC: RAMOS TRIVI脩O OSCAR JUAN. Nombramientos. VsecrNoConsj: TARDIN SANCHEZ CAROLINA.Datos registrales. T 22074 , F 62, S 8, H M 317821, I/A 20 (22.05.15).

12 de Diciembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: IGLESIAS HERNANDEZ PATRICIA. Nombramientos. Vsecr2.NC: RAMOS TRIVI脩O OSCARJUAN. Datos registrales. T 22074 , F 61, S 8, H M 317821, I/A 19 (29.11.11).

09 de Junio de 2009
Revocaciones. Apoderado: AZNAR AZNAR MANUEL;WARGNY BENEDICTE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: AZNAR AZNARMANUEL;ZARAGOZA LLIRINOS ASUNSION. Apo.Sol.: BRDENK JEAN CLAUDE. Datos registrales. T 22074 , F 60, S 8, H M317821, I/A 18 (29.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n