Buscador CIF Logo

Actos BORME Centro Europeo De Evolucion Economica Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Centro Europeo De Evolucion Economica Sa

Actos BORME Centro Europeo De Evolucion Economica Sa - A08264350

Tenemos registrados 27 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Centro Europeo De Evolucion Economica Sa con CIF A08264350

馃敊 Perfil de Centro Europeo De Evolucion Economica Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Centro Europeo De Evolucion Economica Sa

04 de Agosto de 2023
Reelecciones. Consejero: FELIU GARANTO LUIS MANUEL. Secretario: FELIU GARANTO LUIS MANUEL. Datos registrales. T

07 de Febrero de 2023
Reelecciones. Representan: MAZZONI FABIO. Consejero: CEDEC MANAGEMENT SA. Vicepresid.: CEDEC MANAGEMENT SA.Datos registrales. T 36764 , F 146, S 8, H M 658684, I/A 17 (31.01.23).

29 de Julio de 2022
Modificaciones estatutarias. modificaci贸n del art铆culo 30. Datos registrales. T 36764 , F 145, S 8, H M 658684, I/A 15 (21.07.22).

Reelecciones. Auditor: EQUIFOND AUDITORES SL. Datos registrales. T 36764 , F 146, S 8, H M 658684, I/A 16 (21.07.22).

24 de Junio de 2021
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 31 de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 36764 , F 145, S 8, H M658684, I/A 14 (17.06.21).

15 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: PIJUAN PRATS ALBERTO. Con.Delegado: PIJUAN PRATS ALBERTO. Presidente: PIJUAN PRATSALBERTO. Revocaciones. Apoderado: PIJUAN PRATS ALBERTO. Nombramientos. Consejero: CEDEC HOLDING SA.Presidente: CEDEC HOLDING SA. Representan: BURINI MARC ALEXANDRE. Datos registrales. T 36764 , F 144, S 8, H M 658684,I/A 13 ( 8.06.21).

27 de Noviembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Representan: PIJUAN PRATS ALBERTO. Nombramientos. Representan: MAZZONI FABIO. Datosregistrales. T 36764 , F 144, S 8, H M 658684, I/A 12 (20.11.20).

14 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apoderado: FELIU GARANTO LUIS MANUEL. Datos registrales. T 36764 , F 144, S 8, H M 658684, I/A 11 (7.02.20).

23 de Septiembre de 2019
Reelecciones. Auditor: EQUIFOND AUDITORES SL. Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 31 de los EstatutosSociales.. Datos registrales. T 36764 , F 143, S 8, H M 658684, I/A 10 (16.09.19).

26 de Febrero de 2019
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 259 C 18 - EDIFICIO CUATRO (MADRID). Datos registrales. T 36764 ,F 143, S 8, H M 658684, I/A 9 (19.02.19).

25 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apoderado: SANTI CARLO. Datos registrales. T 36764 , F 143, S 8, H M 658684, I/A 8 (18.02.19).

26 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DAVALILLO ROMAGOSA PATRICIA;DOMINGUEZ MARTINEZ FRANCISCA;POMARES COSGAYAMARIA DE LOS ANGELES;DOMINGUEZ MARTINEZ FRANCISCA;POMARES COSGAYA MARIA DE LOS ANGELES.Apo.Manc.:DAVALILLO ROMAGOSA PATRICIA. Nombramientos. Apoderado: MELGAR GONZALEZ INMACULADA;POMARES COSGAYAMARIA DE LOS ANGELES;DOMINGUEZ MARTINEZ FRANCISCA. Datos registrales. T 36764 , F 142, S 8, H M 658684, I/A 7(19.11.18).

20 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FELIU GARANTO LUIS MANUEL. Consejero: CONSUL SANCERNI JORGE. Con.Delegado:CONSUL SANCERNI JORGE. Nombramientos. Consejero: FELIU GARANTO LUIS MANUEL. Secretario: FELIU GARANTO LUISMANUEL. Reelecciones. Consejero: PIJUAN PRATS ALBERTO. Con.Delegado: PIJUAN PRATS ALBERTO. Presidente: PIJUANPRATS ALBERTO. Datos registrales. T 36764 , F 141, S 8, H M 658684, I/A 6 (13.11.18).

22 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DOMINGUEZ MARTINEZ FRANCISCA;POMARES COSGAYA MARIA DE LOS ANGELES.Apo.Manc.: DAVALILLO ROMAGOSA PATRICIA. Datos registrales. T 36764 , F 141, S 8, H M 658684, I/A 5 (15.10.18).

22 de Agosto de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RAFECA BARCELO SARA. Nombramientos. SecreNoConsj: FELIU GARANTO LUIS MANUEL.Datos registrales. T 36764 , F 141, S 8, H M 658684, I/A 4 (10.08.18).

01 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DAVALILLO ROMAGOSA PATRICIA;DOMINGUEZ MARTINEZ FRANCISCA;POMARES COSGAYAMARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 36764 , F 139, S 8, H M 658684, I/A 3 (24.01.18).

27 de Diciembre de 2017
Fe de erratas: Se public贸 por error en la Inscripci贸n 2陋 el municipio del domicilio de la sociedad como GETAFE, siendo lo correctoMADRID. Datos registrales. T 36764 , F 139, S 8, H M 658684, I/A 2 ( 5.12.17).

14 de Diciembre de 2017
Cambio de domicilio social. PASEO DE LAS DELICIAS 30 7潞 (GETAFE). Datos registrales. T 36764 , F 139, S 8, H M 658684, I/A2 ( 5.12.17).

06 de Julio de 2017
Revocaciones. CONSEJERO: JEAN NICLAUS. PRESIDENTE: JEAN NICLAUS. CONS. DELEG.: JEAN NICLAUS. VICEPRESIDEN:PIJUAN PRATS ALBERTO. CONSEJERO: FELIU GARANTO LUIS MANUEL. SECRETARIO: FELIU GARANTO LUIS MANUEL.APODERAD.SOL: CONSUL SANCERNI JORGE. Nombramientos. CONSEJERO: CEDEC MANAGEMENT SA. REPR.143 RRM:PIJUAN PRATS ALBERTO. CONSEJERO: CONSUL SANCERNI JORGE. PRESIDENTE: PIJUAN PRATS ALBERTO.VICEPRESIDEN: CEDEC MANAGEMENT SA. SECR.NO CONS: RAFECAS BARCELO SARA. CONS. DELEG.: CONSUL SANCERNIJORGE. Datos registrales. T 36186 , F 150, S 8, H B 88786, I/A 43 (28.06.17).

12 de Abril de 2017
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: EQUIFOND AUDITORES SL. Datos registrales. T 36186 , F 150, S 8, H B 88786, I/A 42 (3.04.17).

30 de Enero de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: CONSUL SANCERNI JORGE. Datos registrales. T 36186 , F 149, S 8, H B 88786, I/A 41(20.01.17).

06 de Septiembre de 2016
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CONVOCATORIA DE LAJUNTA GENERAL. Datos registrales. T 36186 , F 148, S 8, H B 88786, I/A 40 (30.08.16).

17 de Diciembre de 2015
Revocaciones. APODERADO: PIJUAN PRATS ALBERTO. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION Y REFUNDICION DELOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE LA NATURALEZA DE LAS ACCIONES DE AL PORTADOR EN NOMINATIVAS.SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Cambio de objeto social. AMPLIAR A: LAINTERMEDIACION EN LA COMPRA VENTA DE SOCIEDADES,EMPRESAS O ACTIVOS EMPRESARIALES,LLEVANDO A CABOCUANTAS GESTIONES SEAN NECESARIAS Y PERCIBIENDO LAS COMPENSACIONES CONTRACTUALMENTE ACORDADAS.Datos registrales. T 36186 , F 146, S 8, H B 88786, I/A 39 ( 9.12.15).

15 de Noviembre de 2013
Revocaciones. V-SEC NO CON: CONSUL SANCERNI JORGE. CONSEJERO: JEAN NICLAUS. PRESIDENTE: JEAN NICLAUS.CONS. DELEG.: JEAN NICLAUS. CONSEJERO: DONALD ALPHONSE MONIQUE NICLAUS. SECRETARIO: DONALD ALPHONSEMONIQUE NICLAUS. CONSEJERO: BRUMIBAGE INTERNATIONAL BV. REPR.143 RRM: MICHEL JEAN FRANCOIS CADILHAC.Nombramientos. CONSEJERO: JEAN NICLAUS. PRESIDENTE: JEAN NICLAUS. CONS. DELEG.: JEAN NICLAUS. CONSEJERO:PIJUAN PRATS ALBERTO. VICEPRESIDEN: PIJUAN PRATS ALBERTO. CONS. DELEG.: PIJUAN PRATS ALBERTO. CONSEJERO:FELIU GARANTO LUIS MANUEL. SECRETARIO: FELIU GARANTO LUIS MANUEL. Datos registrales. T 36186 , F 145, S 8, H B

Nombramientos. AUDIT.CUENT.: EQUIFOND AUDITORES SL. Datos registrales. T 36186 , F 146, S 8, H B 88786, I/A 38 (7.11.13).

22 de Noviembre de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: EQUIFOND AUDITORES SL. Datos registrales. T 36186 , F 145, S 8, H B 88786, I/A 36(11.11.11).

28 de Abril de 2011
Nombramientos. CONSEJERO: JEAN NICLAUS. PRESIDENTE: JEAN NICLAUS. CONS. DELEG.: JEAN NICLAUS. CONSEJERO:DONALD ALPHONSE MONIQUE NICLAUS. SECRETARIO: DONALD ALPHONSE MONIQUE NICLAUS. CONSEJERO: BRUMIBAGEINTERNATIONAL BV. REPR.143 RRM: MICHEL JEAN FRANCOIS CADILHAC. Datos registrales. T 36186 , F 144, S 8, H B 88786,I/A 35 (14.04.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n