Actos BORME de Centro Farmaceutico Asturiano Sa
07 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ HERNANDEZ SILVIA. Apo.Manc.: LOPEZ HERNANDEZ SILVIA;ARES MONTES LUIS MIGUEL.Apo.Sol.: ARES MONTES LUIS MIGUEL;DE LA VIUDA SAINZ JAVIER. Apo.Manc.: DE LA VIUDA SAINZ JAVIER. Apo.Sol.: TORRAJUANOLA MARTI. Apo.Manc.: TORRA JUANOLA MARTI. Apo.Sol.: MARQUES TEIXEIRA LEONARDO. Apo.Manc.: MARQUESTEIXEIRA LEONARDO. Datos registrales. T 3757 , F 70, S 8, H AS 2450, I/A 142 (30.11.23).
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3757 , F 70, S 8, H AS 2450, I/A 143 (30.11.23).
14 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ FRANCES CARLOS SEBASTIAN. Nombramientos. Consejero: VELA BLASCO IGNACIO.Datos registrales. T 3757 , F 70, S 8, H AS 2450, I/A 141 ( 6.11.23).
10 de Abril de 2023Reelecciones. Consejero: CASAS CANTERO FRANCISCO JAVIER;PEREZ HIDALGO DAVID. Datos registrales. T 3757 , F 70, S8, H AS 2450, I/A 140 (29.03.23).
12 de Agosto de 2022Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 27. Cierre del Ejercicio.-. Datos registrales. T 3757 , F 68, S 8, H AS 2450,I/A 137 ( 4.08.22).
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3757 , F 68, S 8, H AS 2450, I/A 138 ( 4.08.22).
10 de Marzo de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: ELIAS MASDEU JOSEP MARIA;LLORENS GONZALEZ FERNANDO MARIA. Nombramientos. Apo.Sol.:DE LA VIUDA SAINZ JAVIER. Apo.Manc.: DE LA VIUDA SAINZ JAVIER. Apo.Sol.: TORRA JUANOLA MARTI. Apo.Manc.: TORRAJUANOLA MARTI. Apo.Sol.: PALACIO GAMERO CRISTIAN. Apo.Manc.: PALACIO GAMERO CRISTIAN. Apo.Sol.: PASCUALGARCIA RAQUEL. Apo.Manc.: PASCUAL GARCIA RAQUEL. Apo.Sol.: TORRES LISA OLGA. Apo.Manc.: TORRES LISA OLGA.Apo.Sol.: MARQUES TEIXEIRA LEONARDO. Apo.Manc.: MARQUES TEIXEIRA LEONARDO. Apo.Sol.: PONS ESTRADELAURA;ALARCON RAMOS PAULA. Datos registrales. T 3757 , F 24, S 8, H AS 2450, I/A 136 ( 2.03.22).
23 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apoderado: CASAS CANTERO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3757 , F 24, S 8, H AS 2450, I/A 135(15.12.21).
25 de Junio de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3757 , F 24, S 8, H AS 2450, I/A 134 (16.06.21).
15 de Febrero de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: GARRIDO RIBO CLARA. Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ HERNANDEZ SERGI;LLORENSGONZALEZ FERNANDO MARIA. Datos registrales. T 3757 , F 23, S 8, H AS 2450, I/A 133 ( 5.02.21).
19 de Agosto de 2020Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3757 , F 23, S 8, H AS 2450, I/A 132 (10.08.20).
15 de Enero de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: VELA BLASCO IGNACIO. Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ GIMENO PEDRO LUIS. Apo.Manc.:MARTINEZ GIMENO PEDRO LUIS. Apo.Sol.: VELA BLASCO IGNACIO. Apo.Manc.: VELA BLASCO IGNACIO. Apo.Sol.: LOPEZHERNANDEZ LARISSA. Apo.Manc.: LOPEZ HERNANDEZ LARISSA. Apo.Sol.: QUEROL ORTEGA MARTA. Apo.Manc.: QUEROLORTEGA MARTA. Apo.Sol.: VIZCAINO GALLART CLARA. Apo.Manc.: VIZCAINO GALLART CLARA. Apo.Sol.: VAZQUEZ MAYORCRISTINA. Apo.Manc.: VAZQUEZ MAYOR CRISTINA. Datos registrales. T 3757 , F 21, S 8, H AS 2450, I/A 131 ( 8.01.20).
13 de Junio de 2019Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3757 , F 21, S 8, H AS 2450, I/A 130 ( 5.06.19).
24 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: ARIÑO HERRERO MACARENA;MOLINE ARROYO DAVID. Datos registrales. T 3757 , F 20, S 8, H AS2450, I/A 129 (12.04.19).
19 de Febrero de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: ARANDA MONTERROSO ISIDORO;RODRIGUEZ SORIANO OLGA. Apo.Sol.: ARANDA MONTERROSOISIDORO;RODRIGUEZ SORIANO OLGA. Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN LOPEZ ANTONIO MARIA. Apo.Manc.: MARTINLOPEZ ANTONIO MARIA. Apo.Sol.: ADELL SANCHEZ JORGE;GARCIA FUSTER LAURA;GARRIDO RIBO CLARA;ELIAS MASDEUJOSEP MARIA. Datos registrales. T 3757 , F 19, S 8, H AS 2450, I/A 128 (12.02.19).
26 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: TASSONE GIANLUIGI SERGIO. Nombramientos. Consejero: PEREZ FRANCES CARLOSSEBASTIAN. Datos registrales. T 3757 , F 19, S 8, H AS 2450, I/A 127 (17.12.18).
21 de Agosto de 2018Reelecciones. Consejero: PEREZ HIDALGO DAVID;CASAS CANTERO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3757 , F 18, S8, H AS 2450, I/A 125 ( 7.08.18).
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3757 , F 19, S 8, H AS 2450, I/A 126 ( 7.08.18).
22 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: STRAIN DERMID MARTIN. Nombramientos. Consejero: TASSONE GIANLUIGI SERGIO. Datosregistrales. T 3757 , F 18, S 8, H AS 2450, I/A 123 (10.08.17).
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3757 , F 18, S 8, H AS 2450, I/A 124 (10.08.17).
18 de Julio de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: MATEO RUIZ VICTOR;BUXTON MARC. Datos registrales. T 3757 , F 17, S 8, H AS 2450, I/A 122(11.07.17).
17 de Abril de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: VILADOMS FUSTER CRISTIAN. Apo.Manc.: VILADOMS FUSTER CRISTIAN. Datos registrales. T 3757 ,F 17, S 8, H AS 2450, I/A 121 ( 5.04.17).
02 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GUERRA JUAN JOSE RICARDO. Nombramientos. Consejero: STRAIN DERMID MARTIN. Datosregistrales. T 3757 , F 16, S 8, H AS 2450, I/A 119 (25.05.16).
Revocaciones. Apo.Sol.: ARANDA ORTEGA ANTONIO. Apo.Manc.: ARANDA ORTEGA ANTONIO. Apo.Sol.: MATEO RUIZ VICTOR.Apo.Manc.: MATEO RUIZ VICTOR. Nombramientos. Apo.Manc.: MATEO RUIZ VICTOR. Apo.Sol.: MATEO RUIZ VICTOR.Apo.Manc.: PARRA FERNANDEZ REMEDIOS. Apo.Sol.: PARRA FERNANDEZ REMEDIOS. Apo.Manc.: MOLINE ARROYO DAVID.Apo.Sol.: MOLINE ARROYO DAVID. Apo.Manc.: ARES MONTES LUIS MIGUEL. Apo.Sol.: ARES MONTES LUIS MIGUEL. Datosregistrales. T 3757 , F 16, S 8, H AS 2450, I/A 120 (25.05.16).
07 de Julio de 2015Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 27. Cierre del Ejercicio.-. Datos registrales. T 3757 , F 16, S 8, H AS 2450,I/A 118 (29.06.15).
03 de Junio de 2015Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3757 , F 16, S 8, H AS 2450, I/A 117 (22.05.15).
24 de Abril de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: MIR JULIA CRISTINA;CASAÑAS URPI JOAN;ECHANIZ SAMPEDRO FEDERICO. Apo.Manc.: MIR JULIACRISTINA;CASAÑAS URPI JOAN;ECHANIZ SAMPEDRO FEDERICO;PEREZ HIDALGO DAVID. Apo.Sol.: PEREZ HIDALGODAVID;CASAS CANTERO FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: CASAS CANTERO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apo.Sol.:CASAS CANTERO FRANCISCO JAVIER;PEREZ HIDALGO DAVID. Apo.Manc.: CASAS CANTERO FRANCISCO JAVIER;PEREZHIDALGO DAVID;ARANDA MONTERROSO ISIDORO. Apo.Sol.: ARANDA MONTERROSO ISIDORO;BUXTON MARC. Apo.Manc.:BUXTON MARC;RODRIGUEZ SORIANO OLGA. Apo.Sol.: RODRIGUEZ SORIANO OLGA. Datos registrales. T 3757 , F 14, S 8, HAS 2450, I/A 116 (16.04.15).
26 de Mayo de 2014Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3757 , F 14, S 8, H AS 2450, I/A 115 (15.05.14).
04 de Marzo de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: RIVAS CORTES PABLO. Nombramientos. Consejero: GUERRA JUAN JOSE RICARDO. Datosregistrales. T 3757 , F 14, S 8, H AS 2450, I/A 114 (21.02.14).
24 de Enero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: FIZESAN IOAN MARIUS. Secretario: RIVAS CORTES PABLO. Nombramientos. Consejero: PEREZHIDALGO DAVID. Secretario: PEREZ HIDALGO DAVID. Datos registrales. T 3757 , F 13, S 8, H AS 2450, I/A 112 (16.01.14).
Revocaciones. Apo.Sol.: RIVAS CORTES PABLO. Apo.Manc.: RIVAS CORTES PABLO. Apo.Sol.: DESSENA STEFANO. Apo.Manc.:DESSENA STEFANO;QUINTANA PASCUAL MARIA LUISA. Apo.Sol.: QUINTANA PASCUAL MARIA LUISA. Nombramientos.Apo.Manc.: PEREZ HIDALGO DAVID. Apo.Sol.: PEREZ HIDALGO DAVID;CASAS CANTERO JAVIER. Apo.Manc.: CASAS CANTEROJAVIER. Datos registrales. T 3757 , F 13, S 8, H AS 2450, I/A 113 (16.01.14).
19 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: DESSENA STEFANO. Presidente: DESSENA STEFANO. Nombramientos. Consejero: CASASCANTERO JAVIER. Presidente: CASAS CANTERO JAVIER. Datos registrales. T 3757 , F 13, S 8, H AS 2450, I/A 110 (12.06.13).
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3757 , F 13, S 8, H AS 2450, I/A 111 (12.06.13).
31 de Agosto de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: CASAS CANTERO FRANCISCO JAVIER;VILADOMS FUSTER CRISTIAN;VELA BLASCOIGNACIO;ARANDA ORTEGA ANTONIO;GONZALEZ MARTIN-MONTALVO ENRIQUE;ARIÑO HERRERO MACARENA;LOPEZHERNANDEZ SERGI;MATEO RUIZ VICTOR;ROMERO MARTIN BERNAT;QUINTANA PASCUAL MARIA LUISA;CABEZASGONZALEZ JUAN CARLOS;ANTUÑA LEON CESAR;LOPEZ HERNANDEZ SERGI;MIR JULIA CRISTINA;ROMERO MARTIN
Revocaciones. Apo.Sol.: PONS VANDELLOS INMACULADA CONCEPCION;OLIVER MAYOR FERRAN. Apo.Manc.: BARRAHERRANZ JUAN JOSE;BALAT LLOPART MIQUEL;ARREGUI GARCIA JAVIER;PORTERO MARTIN YOLANDA;FERRE TREJORUBEN IGNACIO;MARTINEZ RECARI CESAR;OLIVER MAYOR FERRAN;PONS VANDELLOS INMACULADACONCEPCION;QUINTANA PASCUAL MARIA LUISA;ARANDA ORTEGA ANTONIO;VILADOMS FUSTER CRISTIAN;DIAZ MARTINMIRIAM;DASCA VINYALS RAFAEL;MARTINEZ BLANCO JOSE RAMON. Apo.Sol.: QUINTANA PASCUAL MARIA LUISA;ARANDAORTEGA ANTONIO;VILADOMS FUSTER CRISTIAN;DIAZ MARTIN MIRIAM;DASCA VINYALS RAFAEL;MARTINEZ BLANCO JOSERAMON;BARRA HERRANZ JUAN JOSE;BALAT LLOPART MIQUEL;ARREGUI GARCIA JAVIER;PORTERO MARTINYOLANDA;FERRE TREJO RUBEN IGNACIO;MARTINEZ RECARI CESAR;PLUMED SOBRINO ANA MARIA;PEDRAZA CARRILLOJAVIER;CASAS CANTERO JAVIER;VELA BLASCO IGNACIO;LOPEZ HERNANDEZ SERGIO;ROMERO MARTIN BERNAT;AZANZACRESPO ROBERTO;BELTRAN COSTEA EDUARDO;FERNANDEZ DEL RIO RAFAEL;MIR JULIA CRISTINA;TORCAL ALAMOJORDI. Apo.Manc.: CABEZAS GONZALEZ JUAN CARLOS;PLUMED SOBRINO ANA MARIA;PEDRAZA CARRILLO JAVIER;CASASCANTERO JAVIER;VELA BLASCO IGNACIO;LOPEZ HERNANDEZ SERGIO;ROMERO MARTIN BERNAT;AZANZA CRESPOROBERTO. Apo.Sol.: SANJUAN ROYO JOSE LUIS;CABEZAS GONZALEZ JUAN CARLOS. Apo.Manc.: SANJUAN ROYO JOSELUIS. Apo.Sol.: LOPEZ HERNANDEZ SILVIA. Apoderado: VELA BLASCO IGNACIO. Apo.Sol.: RIVAS CORTES PABLO. Apo.Manc.:RIVAS CORTES PABLO. Apo.Sol.: DOMINGOS DE ALMEIDA FERREIRA JOAQUIM FAUSTO. Apo.Manc.: DOMINGOS DE ALMEIDAFERREIRA JOAQUIM FAUSTO. Datos registrales. T 3757 , F 11, S 8, H AS 2450, I/A 108 (20.08.12).
31 de Julio de 2012Revocaciones. Consejero: KELSEY FORD STEPHEN. Nombramientos. Consejero: FIZESAN IOAN MARIUS. Datos registrales.T 3757 , F 11, S 8, H AS 2450, I/A 107 (19.07.12).
16 de Mayo de 2012Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3757 , F 11, S 8, H AS 2450, I/A 106 ( 3.05.12).
26 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Presidente: DOMINGOS DE ALMEIDA FERREIRA JOAQUIM FAUSTO. Consejero: DOMINGOS DE ALMEIDAFERREIRA JOAQUIM FAUSTO. Nombramientos. Consejero: DESSENA STEFANO. Presidente: DESSENA STEFANO. Datosregistrales. T 3757 , F 11, S 8, H AS 2450, I/A 105 (14.12.11).
02 de Agosto de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: RIVAS CORTES PABLO;DESSENA STEFANO. Apo.Manc.: RIVAS CORTES PABLO;DESSENASTEFANO. Datos registrales. T 3757 , F 10, S 8, H AS 2450, I/A 104 (19.07.11).
30 de Mayo de 2011Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3757 , F 10, S 8, H AS 2450, I/A 103 (18.05.11).
26 de Enero de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: RIVAS CORTES PABLO. Apo.Manc.: RIVAS CORTES PABLO. Apo.Sol.: DOMINGOS DE ALMEIDAFERREIRA JOAQUIM FAUSTO. Apo.Manc.: DOMINGOS DE ALMEIDA FERREIRA JOAQUIM FAUSTO. Datos registrales. T 3757 ,F 9, S 8, H AS 2450, I/A 102 (14.01.11).
26 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apoderado: VELA BLASCO IGNACIO. Datos registrales. T 3757 , F 9, S 8, H AS 2450, I/A 101 (17.11.10).
21 de Diciembre de 2009Revocaciones. Consejero: ALLIANCE HEALTHCARE SA. Presidente: ALLIANCE HEALTHCARE SA. Consejero: NEXIAPHARMASA;SAFANDALUS SA. Secretario: SAFANDALUS SA. Consejero: MEDICAMENTA SA. Nombramientos. Consejero: DOMINGOS DEALMEIDA FERREIRA JOAQUIM FAUSTO;RIVAS CORTES PABLO;KELSEY FORD STEPHEN. Presidente: DOMINGOS DEALMEIDA FERREIRA JOAQUIM FAUSTO. Secretario: RIVAS CORTES PABLO. Datos registrales. T 3757 , F 8, S 8, H AS 2450, I/A100 (10.12.09).