Buscador CIF Logo

Actos BORME Centros De Dependencia La Viña Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Centros De Dependencia La Viña Sl

Actos BORME Centros De Dependencia La Viña Sl - B21342423

Tenemos registrados 25 Actos BORME del Registro Mercantil de Pontevedra para Centros De Dependencia La Viña Sl con CIF B21342423

🔙 Perfil de Centros De Dependencia La Viña Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Pontevedra

Actos BORME de Centros De Dependencia La Viña Sl

24 de Enero de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: CASTA SALUD SL.Datos registrales. T 4324, L 4324, F 51, S 8, H PO 66852, I/A 14 (14.01.22).

04 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4324, L 4324, F 51, S 8, H PO 66852, I/A 13(26.10.21).

03 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4324, L 4324, F 49, S 8, H PO 66852, I/A 12(22.10.21).

26 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 4324, L 4324, F 49, S 8, H PO 66852, I/A 11(15.10.21).

21 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4324, L 4324, F 48, S 8, H PO 66852, I/A 10 (13.10.21).

19 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4324, L 4324, F 48, S 8, H PO 66852, I/A 9 ( 7.10.21).

05 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: GIL ROJAS MARIA ANGELES. Datos registrales. T 4324, L 4324, F 48, S 8, H PO 66852, I/A 8(24.09.21).

06 de Mayo de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA MORENO. Datos registrales. T 4324, L 4324, F 48, S 8, H PO66852, I/A 7 (26.04.21).

07 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4324, L 4324, F 47, S 8, H PO 66852, I/A 5(31.07.20).

03 de Abril de 2020
Declaración de unipersonalidad. Socio único: CASTA SALUD SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: CARDENAS FALCONEVA;BORMUVERSITAS SL;ACARREGUI SANTIAGO ACARREGUI SANTIAGO ESTEBAN. Presidente: ACARREGUI SANTIAGOACARREGUI SANTIAGO ESTEBAN. Secretario: BORMUVERSITAS SL. Cons.Del.Sol: CARDENAS FALCON EVA. Nombramientos.Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo deadministración a Administrador único. Datos registrales. T 966 , F 156, S 8, H H 10993, I/A 22 (17.03.20).

Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 966 , F 156, S 8, H H 10993, I/A 23 (17.03.20).

Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIA JOSE. Datos registrales. T 966 , F 157, S 8, H H 10993, I/A 24 (17.03.20).

Nombramientos. Apoderado: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 966 , F 157, S 8, H H 10993, I/A 25(17.03.20).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 966 , F 157, S 8, H H 10993, I/A 26 (17.03.20).

Nombramientos. Apoderado: BRAVO ARAGON PEDRO. Datos registrales. T 1144 , F 39, S 8, H H 10993, I/A 27 (17.03.20).

Nombramientos. Apoderado: REYES PONCE MONICA. Datos registrales. T 1144 , F 39, S 8, H H 10993, I/A 28 (17.03.20).

Nombramientos. Apoderado: CARDENAS FALCON EVA. Datos registrales. T 1144 , F 40, S 8, H H 10993, I/A 29 (17.03.20).

Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 1144 , F 40, S 8, H H 10993, I/A 30 (17.03.20).

Nombramientos. Apoderado: ABASCAL CASTAÑON ALVARO MARIA. Datos registrales. T 1144 , F 44, S 8, H H 10993, I/A 31(17.03.20).

Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 1144 , F 47, S 8, H H 10993, I/A 32

Nombramientos. Apo.Sol.: DEL CAMPO REDONDO LUCIA;MELON CASTRO MARIA JOSE. Datos registrales. T 1144 , F 48, S 8,H H 10993, I/A 33 (17.03.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER;GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU;MARIN SORRIBESANA;RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA MORENO. Datos registrales. T 1144 , F 48, S 8, H H 10993, I/A 34 (17.03.20).

27 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. D. Gerente: MACARRO MUÑOZ MARIOLA. Revocaciones. Apoderado: MACARRO MUÑOZ MARIOLA. Datosregistrales. T 966 , F 155, S 8, H H 10993, I/A 21 (16.12.19).

01 de Marzo de 2017
Reelecciones. Auditor: QLEY AUDITORES CONSULTORES SL. Datos registrales. T 966 , F 154, S 8, H H 10993, I/A 17(21.02.17).

07 de Julio de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: MACARRO MUÑOZ MARIOLA. Cons.Del.Sol: MACARRO MUÑOZ MARIOLA. Datos registrales. T966 , F 154, S 8, H H 10993, I/A 16 (27.06.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información