Buscador CIF Logo

Actos BORME Centros E Instalaciones Asistenciales Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Centros E Instalaciones Asistenciales Sa

Actos BORME Centros E Instalaciones Asistenciales Sa - A21037122

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Centros E Instalaciones Asistenciales Sa con CIF A21037122

馃敊 Perfil de Centros E Instalaciones Asistenciales Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Centros E Instalaciones Asistenciales Sa

20 de Octubre de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 30421 , F 218, S 8, H M 547553, I/A 35 (13.10.23).

17 de Octubre de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;CABALLERO CABALLERO MARIANO;DELGADO SORIAMARIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE;RODRIGUEZ-VILLA MATONSANDRES;CABALLERO CABALLERO MARIANO;GARCIA CALLE LAURA;RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO;HERNANDEZMORENO-VENTAS RAUL. Datos registrales. T 30421 , F 217, S 8, H M 547553, I/A 34 ( 9.10.23).

17 de Agosto de 2023
Reelecciones. Consejero: IVORRA MIRALLES FRANCISCO;DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE. Cons.Del.Sol: IVORRAMIRALLES FRANCISCO;DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE. Consejero: CABALLERO CABALLERO MARIANO. Secretario:CABALLERO CABALLERO MARIANO. Presidente: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Datos registrales. T 30421 , F 216, S 8, H M547553, I/A 33 ( 9.08.23).

11 de Enero de 2023
Revocaciones. Apoderado: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Apo.Man.Soli: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Datosregistrales. T 30421 , F 216, S 8, H M 547553, I/A 32 ( 3.01.23).

22 de Noviembre de 2022
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 30421 , F 216, S 8, H M 547553, I/A 31 (15.11.22).

05 de Mayo de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL. Presidente: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBAMANUEL. Cons.Del.Sol: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL. Nombramientos. Presidente: IVORRA MIRALLESFRANCISCO. Datos registrales. T 30421 , F 216, S 8, H M 547553, I/A 30 (27.04.22).

19 de Abril de 2022
Revocaciones. Apoderado: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL. Apo.Manc.: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBAMANUEL. Apo.Man.Soli: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL. Datos registrales. T 30421 , F 215, S 8, H M 547553, I/A 29( 8.04.22).

13 de Enero de 2022
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n y refundici贸n de los estatutos sociales.. Cambio de objeto social. a) La organizaci贸n,direcci贸n, gesti贸n e intermediaci贸n para la prestaci贸n de servicios de asistencia cl铆nica general, tratamientos m茅dico-quir煤rgicos detodo tipo de enfermedades humanas, actividades socio-sanitarias, de residencias geri谩tricas, cualquier otro servicio sanitario. Datosregistrales. T 30421 , F 211, S 8, H M 547553, I/A 28 ( 5.01.22).

24 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apoderado: RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO;CABALLERO CABALLERO MARIANO;ALCALDE GOMEZ MARIADOLORES. Datos registrales. T 30421 , F 209, S 8, H M 547553, I/A 27 (16.03.21).

11 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ FLORES JUAN LUIS. Datos registrales. T 30421 , F 208, S 8, H M 547553, I/A 26 (4.02.20).

23 de Octubre de 2019
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 30421 , F 208, S 8, H M 547553, I/A 25 (16.10.19).

25 de Julio de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;ALCALDEGOMEZ MARIA DOLORES;CABALLERO CABALLERO MARIANO;DELGADO SORIA MARIO. Otros conceptos: REVOCADASPARCIALMENTE , 煤nicamente LAS FACULTADES DE TESORERIA a los apoderados: Don Manuel Soria Fern谩ndez de C贸rdoba, DonAndr茅s Rodr铆guez-Villa Matons, Do帽a Mar铆a Dolores Alcalde G贸mez y Don Mariano Caballero Caballero y que causo la inscripcion 5潞.Datos registrales. T 30421 , F 207, S 8, H M 547553, I/A 24 (17.07.19).

24 de Enero de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: POSADA SERNA ALMICAR. Datos registrales. T 30421 , F 207, S 8, H M 547553, I/A 23 (17.01.19).

15 de Noviembre de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30421 , F 207, S 8, H M 547553,I/A 22 ( 7.11.18).

05 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: GIMENEZ RODRIGUEZ PAULA;CASTILLO ALONSO GABRIEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli:RODRIGUEZ FLORES JUAN LUIS;GIMENEZ RODRIGUEZ PAULA. Datos registrales. T 30421 , F 206, S 8, H M 547553, I/A 21(26.10.18).

31 de Agosto de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CABALLERO CABALLERO MARIANO. Cancelaciones de oficio de nombramientos.Cons.Del.Sol: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;IVORRA MIRALLES FRANCISCO;DE PORRES ORTIZ DE URBINAENRIQUE. Nombramientos. Cons.Del.Sol: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;IVORRA MIRALLES FRANCISCO;DEPORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE. Consejero: CABALLERO CABALLERO MARIANO. Secretario: CABALLERO CABALLEROMARIANO. Reelecciones. Consejero: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL. Presidente: SORIA FERNANDEZ DECORDOBA MANUEL. Consejero: IVORRA MIRALLES FRANCISCO;DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE. Datos registrales.T 30421 , F 205, S 8, H M 547553, I/A 19 (22.08.18).

29 de Agosto de 2018
Revocaciones. Apoderado: GARCIA MULET VICENTE. Datos registrales. T 30421 , F 206, S 8, H M 547553, I/A 20 (22.08.18).

19 de Abril de 2018
Nombramientos. Apoderado: RIVERA GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 30421 , F 205, S 8, H M 547553, I/A 18(12.04.18).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n