Actos BORME de Centros Medicos Asistenciales De Medicina Integral Sl
02 de Febrero de 2023Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: CLINICA NOVO SANCTI PETRI SL. Datos registrales. T 2409 , F 91, S 8, H CA12627, I/A 62 (24.01.23).
20 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CLAVO BATURONE MIGUEL. Datos registrales. T 2409 , F 91, S 8, H CA 12627, I/A 61 (13.12.21).
25 de Noviembre de 2021Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2409 , F 91, S 8, H CA 12627, I/A 60 (17.11.21).
07 de Octubre de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: LOPEZ-DIEGUEZ MURUBE MARCIAL;MANRIQUE TROYAS JOSE IGNACIO;CUEVAS ALA脩ALUZ;AMILIBIA PICAZO JUAN JOSE;AMILIBIA PICAZO JUAN JOSE;FERNANDEZ HERREROS LUIS MARIANO;MANRIQUETROYAS JOSE IGNACIO;CUEVAS ALA脩A LUZ;LOPEZ-DIEGUEZ MURUBE MARCIAL. Datos registrales. T 2369 , F 66, S 8, H CA12627, I/A 59 (28.09.21).
14 de Julio de 2021Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ HERREROS LUIS MARIANO. Apo.Manc.: ARNOTT FERNANDEZ ZUBIZARRETAMANUEL;AMILIBIA PICAZO JUAN JOSE;CUEVAS ALA脩A LUZ;RODRIGUEZ SILVA MANUEL MARIA;FERNANDEZ HERREROSLUIS MARIANO;NARVAEZ JARE脩O IGNACIO. Datos registrales. T 2369 , F 64, S 8, H CA 12627, I/A 56 ( 6.07.21).
Nombramientos. Apoderado: CASTELLANO ROQUE MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 2369 , F 65, S 8, H CA 12627, I/A 57 (6.07.21).
Nombramientos. Apo.Manc.: ARNOTT FERNANDEZ ZUBIZARRETA MANUEL;AMILIBIA PICAZO JUAN JOSE;CUEVAS ALA脩ALUZ;RODRIGUEZ SILVA MANUEL MARIA;CASTELLANO ROQUE MARIA CRISTINA;NARVAEZ JARE脩O IGNACIO. Datosregistrales. T 2369 , F 65, S 8, H CA 12627, I/A 58 ( 6.07.21).
07 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: ARNOTT FERNANDEZ ZUBIZARRETA MANUEL;AMILIBIA PICAZO JUAN JOSE;CUEVAS ALA脩ALUZ;RODRIGUEZ SILVA MANUEL MARIA;FERNANDEZ HERREROS LUIS MARIANO;NARVAEZ JARE脩O IGNACIO. Datosregistrales. T 2369 , F 63, S 8, H CA 12627, I/A 55 (28.04.21).
06 de Mayo de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: AMILIBIA PICAZO JUAN JOSE;LOPEZ-DIEGUEZ MURUBE MARCIAL;ESCALERA MEDINA MARIAEUGENIA;MANRIQUE TROYAS JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 2369 , F 63, S 8, H CA 12627, I/A 53 (27.04.21).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ SILVA MANUEL MARIA. Datos registrales. T 2369 , F 63, S 8, H CA 12627, I/A 54(27.04.21).
26 de Noviembre de 2020Otros conceptos: Inscrito el cambio de representante fisico del Administrador 煤nico la entidad " Viadmed Salud SL. Datosregistrales. T 2183 , F 40, S 8, H CA 12627, I/A 51 (17.11.20).
Revocaciones. Apo.Manc.: YERA BLASCO MARIA;PRADAS POVEDA JUAN CARLOS. Apoderado: LOPEZ OTERO MANUEL.Datos registrales. T 2183 , F 40, S 8, H CA 12627, I/A 52 (17.11.20).
19 de Marzo de 2020Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: VIAMED SALUD SL. Datos registrales. T 2183 , F 40, S 8, H CA12627, I/A 50 (11.03.20).
21 de Enero de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: MANRIQUE TROYAS JOSE IGNACIO;AMILIBIA PICAZO JUAN JOSE;CUEVAS ALA脩A LUZ;LOPEZ-DIEGUEZ MURUBE MARCIAL;FERNANDEZ HERREROS LUIS MARIANO. Datos registrales. T 2183 , F 39, S 8, H CA 12627, I/A49 (13.01.20).
19 de Septiembre de 2019Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MORENO JOAQUIN. Datos registrales. T 2183 , F 38, S 8, H CA 12627, I/A 48 ( 9.09.19).
03 de Abril de 2019Nombramientos. Auditor: ABANTOS AUDITORES Y ASESORES SL. Datos registrales. T 2183 , F 38, S 8, H CA 12627, I/A 47(26.03.19).
25 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ SILVA MANUEL MARIA. Datos registrales. T 2183 , F 37, S 8, H CA 12627, I/A 45(16.10.17).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: AGARISTA CONSULTING SL. Nombramientos. Adm. Unico: VIAMED SALUD SL. Datosregistrales. T 2183 , F 37, S 8, H CA 12627, I/A 46 (16.10.17).
30 de Mayo de 2016Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: OPTIMUM HOLDING SANITARIO SL. Datos registrales. T 2183 , F 37, S 8, H CA12627, I/A 44 (19.05.16).
08 de Marzo de 2016Nombramientos. Auditor: ABANTOS AUDITORES Y ASESORES SL. Datos registrales. T 2183 , F 36, S 8, H CA 12627, I/A 43 (1.03.16).
03 de Febrero de 2016Nombramientos. Apoderado: LOPEZ OTERO MANUEL. Datos registrales. T 2054 , F 60, S 8, H CA 12627, I/A 39 (26.01.16).
Nombramientos. Apo.Manc.: MANRIQUE TROYAS JOSE IGNACIO;AMILIBIA PICAZO JUAN JOSE;CUEVAS ALA脩A LUZ;LOPEZ-DIEGUEZ MURUBE MARCIAL. Datos registrales. T 2183 , F 35, S 8, H CA 12627, I/A 40 (27.01.16).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ HERREROS LUIS MARIANO. Datos registrales. T 2183 , F 35, S 8, H CA 12627, I/A 41(27.01.16).
Revocaciones. Apoderado: FERIA ALIAGA ANTONIO JOSE;BASCUAS MELIZ CARLOS;RODRIGUEZ SILVA MANUELMARIA;BASCUAS MELIZ SANTIAGO;RODRIGUEZ FLORES HIPOLITO;CLAVO SANCHEZ ANTONIO JESUS. Datos registrales. T2183 , F 36, S 8, H CA 12627, I/A 42 (27.01.16).
21 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: PRADAS POVEDA JUAN CARLOS;MANRIQUE TROYAS JOSE IGNACIO;YERA BLASCOMARIA;AMILIBIA PICAZO JUAN JOSE;ESCALERA MEDINA MARIA EUGENIA;LOPEZ-DIEGUEZ MURUBE MARCIAL. Datosregistrales. T 2054 , F 59, S 8, H CA 12627, I/A 36 (11.12.15).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RODRIGUEZ SILVA MANUEL MARIA. Nombramientos. Adm. Unico: AGARISTA CONSULTINGSL. Datos registrales. T 2054 , F 60, S 8, H CA 12627, I/A 37 (11.12.15).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ SILVA MANUEL MARIA. Datos registrales. T 2054 , F 60, S 8, H CA 12627, I/A 38(11.12.15).
03 de Noviembre de 2014Nombramientos. Auditor: MANCERA CLAVERIA JUAN. Aud.Supl.: GALLO FERNANDEZ RAFAEL JOSE. Datos registrales. T 2054, F 59, S 8, H CA 12627, I/A 35 (27.10.14).
15 de Julio de 2013Nombramientos. Apoderado: CLAVO SANCHEZ ANTONIO JESUS. Datos registrales. T 2054 , F 58, S 8, H CA 12627, I/A 34 (8.07.13).
17 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CLAVO SANCHEZ ANTONIO JESUS;RODRIGUEZ SILVA MANUEL MARIA. Nombramientos.Adm. Unico: RODRIGUEZ SILVA MANUEL MARIA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Cambio de objeto social. a) La intermediaci贸n en la prestaci贸n de servicios deasistencia sanitariaen todas sus vertientes; impartir cursos docentes en cualquier rama de la ense帽anza; ortopedia y asistenciageri谩trica. b) La prestaci贸n de serviciosa empresas, organismos de contabilidad y personas f铆sicas, relativos a la t. Datos registrales.T 2054 , F 57, S 8, H CA 12627, I/A 33 ( 6.06.13).
17 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MARCUELLO AZON MARIA ISABEL. Nombramientos. Adm. Solid.: CLAVO SANCHEZ ANTONIOJESUS. Datos registrales. T 2054 , F 57, S 8, H CA 12627, I/A 32 ( 6.08.12).
25 de Julio de 2012Fe de erratas: Rectificaci贸n de la escritura que produjo la inscripci贸n 27& de esta hoja en cuanto a la adjudicaci贸n de lasparticipacione sociales a los socios. Datos registrales. T 1731 , F 5, S 8, H CA 12627, I/A 31 (12.07.12).
23 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BASCUAS MELIZ CARLOS. Nombramientos. Adm. Solid.: RODRIGUEZ SILVA MANUEL MARIA.Datos registrales. T 1731 , F 5, S 8, H CA 12627, I/A 30 (11.11.10).
15 de Julio de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 30.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 270.000,00 Euros. Datos registrales. T 1731 , F 4,S 8, H CA 12627, I/A 29 ( 6.07.10).
28 de Mayo de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: BASCUAS MELIZ CARLOS DAMIAN;RODRIGUEZ SILVA MANUEL MARIA;MARCUELLO AZONMARIA ISABEL. Presidente: BASCUAS MELIZ CARLOS DAMIAN. Secretario: RODRIGUEZ SILVA MANUEL MARIA. Cons.Del.Sol:MARCUELLO AZON MARIA ISABEL;BASCUAS MELIZ CARLOS DAMIAN. Nombramientos. Adm. Solid.: BASCUAS MELIZCARLOS;MARCUELLO AZON MARIA ISABEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 1731 , F 4, S 8, H CA 12627, I/A 28 (19.05.10).