Buscador CIF Logo

Actos BORME Cepl La Roca Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cepl La Roca Sl

Actos BORME Cepl La Roca Sl - B65408676

Tenemos registrados 50 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Cepl La Roca Sl con CIF B65408676

🔙 Perfil de Cepl La Roca Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Cepl La Roca Sl

21 de Diciembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: ECHEVERRIA ALDUNATE ITZIAR;SANZ JIMENEZ RAUL;JACEK JEROME RENE FRANCOIS. Datosregistrales. T 44180 , F 211, S 8, H M 587339, I/A 42 (14.12.23).

14 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: PONS JEAN-VINCENT. Datos registrales. T 41860 , F 216, S 8, H M 587339, I/A 41 ( 7.12.23).

12 de Junio de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: ECHENIQUE MOSCOSO DE PRADO JAVIER. Secretario: ECHENIQUE MOSCOSO DE PRADOJAVIER. Nombramientos. Consejero: JACEK JEROME. Secretario: JACEK JEROME. Apoderado: JACEK JEROME RENEFRANCOIS. Datos registrales. T 41860 , F 83, S 8, H M 587339, I/A 39 ( 2.06.23).

Revocaciones. Apoderado: DOUANNE JEAN LOUIS EUGENE JOSEPH. Datos registrales. T 41860 , F 216, S 8, H M 587339, I/A40 ( 2.06.23).

23 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: JACEK JEROME RENE FRANCOIS. Datos registrales. T 41860 , F 78, S 8, H M 587339, I/A 37(16.09.22).

Revocaciones. Apoderado: REYES MORENO MERCEDES;GARCIA DE CASTRO ALBERTO. Nombramientos. Apoderado: ACIENPONS YOLANDA. Datos registrales. T 41860 , F 82, S 8, H M 587339, I/A 38 (16.09.22).

11 de Febrero de 2022
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 41860 , F 78, S 8, H M 587339, I/A 36 ( 6.02.22).

03 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: GALLEGO OLLERO RAFAEL. Datos registrales. T 41860 , F 75, S 8, H M 587339, I/A 33 (26.10.21).

Nombramientos. Apoderado: SANZ JIMENEZ RAUL;MOLL GARCIA DANIEL. Datos registrales. T 41860 , F 75, S 8, H M 587339,I/A 34 (26.10.21).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ JIMENEZ CRISTINA. Datos registrales. T 41860 , F 77, S 8, H M 587339, I/A 35(26.10.21).

14 de Junio de 2021
Nombramientos. Apoderado: DURANTON VICENT YVES ERIC. Datos registrales. T 36045 , F 193, S 8, H M 587339, I/A 32 (7.06.21).

24 de Marzo de 2021
Revocaciones. Apoderado: PARRA GARCIA LAURA. Nombramientos. Apoderado: HERRERO ARIAS PATRICIA. Datosregistrales. T 36045 , F 192, S 8, H M 587339, I/A 31 (16.03.21).

31 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apoderado: ECHEVERRIA ALDUNATE ITZIAR. Datos registrales. T 36045 , F 192, S 8, H M 587339, I/A 30(24.10.19).

09 de Abril de 2019
Nombramientos. Apoderado: DOUANNE JEAN LOUIS EUGENE JOSEPH. Datos registrales. T 36045 , F 190, S 8, H M 587339,I/A 29 ( 2.04.19).

08 de Abril de 2019
Nombramientos. Apoderado: PARRA GARCIA LAURA. Datos registrales. T 36045 , F 186, S 8, H M 587339, I/A 25 ( 1.04.19).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA DE CASTRO ALBERTO. Datos registrales. T 36045 , F 187, S 8, H M 587339, I/A 26 (1.04.19).

Nombramientos. Apoderado: DELAVAL GUILLAUME LAURENT ARNAUD. Datos registrales. T 36045 , F 189, S 8, H M 587339,I/A 27 ( 1.04.19).

Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ ITURRALDE JESUS. Datos registrales. T 36045 , F 190, S 8, H M 587339, I/A 28 (1.04.19).

08 de Enero de 2019
Nombramientos. Apoderado: DEL CERRO PEÑALVER ISABEL. Datos registrales. T 36045 , F 185, S 8, H M 587339, I/A 23(28.12.18).

Revocaciones. Apo.Sol.: AZPIROZ BLANCO BEATRIZ. Apoderado: ECHENIQUE MOSCOSO DEL PRADO JAVIER;DOUANNEJEAN LOUIS;GARCIA DE CASTRO ALBERTO. Apo.Manc.: ALONSO DE FRANCISCO CARLOS. Apo.Sol.: DELGADO HERNANDEZCARLOS. Datos registrales. T 36045 , F 186, S 8, H M 587339, I/A 24 (28.12.18).

20 de Diciembre de 2018
Cambio de domicilio social. C/ FEDERICO MOMPOU - Nº5, EDIFICIO 1, 6º PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 36045 , F184, S 8, H M 587339, I/A 22 (13.12.18).

17 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 36045 , F 184, S 8, H M 587339, I/A 21 (10.12.18).

25 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: DEL POZO JIMENEZ VERONICA. Datos registrales. T 36045 , F 184, S 8, H M 587339, I/A 20(18.09.18).

28 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apoderado: REYES MORENO MERCEDES. Datos registrales. T 36045 , F 183, S 8, H M 587339, I/A 19(18.05.18).

30 de Abril de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ECHENIQUE MOSCOSO DEL PRADO JAVIER. Nombramientos. Consejero: SATINCHRISTOPHE LAURENT EMILE PATRICE;ECHENIQUE MOSCOSO DE PRADO JAVIER;PEROT YANN GUY. Presidente: SATINCHRISTOPHE LAURENT EMILE PATRICE. Con.Delegado: SATIN CHRISTOPHE LAURENT EMILE PATRICE. Secretario:ECHENIQUE MOSCOSO DE PRADO JAVIER. Apoderado: ECHENIQUE MOSCOSO DE PRADO JAVIER;DELGADO HERNANDEZCARLOS;AZPIROZ BLANCO BEATRIZ. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo deadministración. Datos registrales. T 36045 , F 176, S 8, H M 587339, I/A 18 (23.04.18).

22 de Febrero de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 36045 , F 175, S 8, H M 587339, I/A 17 (15.02.18).

21 de Junio de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN DIAZ MARIA EUGENIA;GARCIA DIAZ ELVIRA;LONCOMILLA SANHUEZA ERNESTOARMANDO;VAZQUEZ CASCAJERO FRANCISCO JAVIER;CASIMIRO DE GRACIA GISELA;SORIANO FELIPE PEDRO JOSE.Datos registrales. T 32630 , F 103, S 8, H M 587339, I/A 13 (13.06.17).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ITURRALDE JESUS. Datos registrales. T 32630 , F 103, S 8, H M 587339, I/A 14(13.06.17).

Nombramientos. Apoderado: AGUDIN GONZALEZ AVELINO MANUEL. Datos registrales. T 36045 , F 173, S 8, H M 587339, I/A15 (13.06.17).

Nombramientos. Apoderado: GALLEGO OLLERO RAFAEL. Datos registrales. T 36045 , F 174, S 8, H M 587339, I/A 16 (13.06.17).

24 de Abril de 2017
Cambio de domicilio social. C/ BUENOS AIRES 10 - POLIGONO INDUSTRIAL CAMPORROS (ALCALA DE HENARES). Datosregistrales. T 32630 , F 102, S 8, H M 587339, I/A 12 (12.04.17).

19 de Abril de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32630 , F 102, S 8, H M 587339, I/A 11 ( 7.04.17).

14 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apo.Manc.: ALONSO DE FRANCISCO CARLOS. Datos registrales. T 32630 , F 98, S 8, H M 587339, I/A 9 (6.03.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: DELGADO HERNANDEZ CARLOS. Datos registrales. T 32630 , F 99, S 8, H M 587339, I/A 10 (6.03.17).

25 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: HERNANDEZ MUÑOZ JESUS. Nombramientos. Adm. Unico: ECHENIQUE MOSCOSO DELPRADO JAVIER. Datos registrales. T 32630 , F 98, S 8, H M 587339, I/A 8 (18.05.15).

14 de Mayo de 2015
Nombramientos. Apoderado: ECHENIQUE MOSCOSO DEL PRADO JAVIER. Datos registrales. T 32630 , F 96, S 8, H M 587339,I/A 5 ( 6.05.15).

Nombramientos. Apoderado: DOUANNE JEAN LOUIS. Datos registrales. T 32630 , F 97, S 8, H M 587339, I/A 6 ( 7.05.15).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA DE CASTRO ALBERTO. Datos registrales. T 32630 , F 97, S 8, H M 587339, I/A 7 (7.05.15).

15 de Abril de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: DOUANNE JEAN LOUIS. Datos registrales. T 32630 , F 95, S 8, H M 587339, I/A 4 ( 7.04.15).

03 de Noviembre de 2014
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32630 , F 95, S 8, H M 587339, I/A 3 (27.10.14).

25 de Septiembre de 2014
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 6. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. AVDA DOCTOR SEVEROOCHOA , Nº 51, 2& PLANTA, EDIF (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 32630 , F 95, S 8, H M 587339, I/A 2 (17.09.14).

07 de Mayo de 2014
Nombramientos. APODERAD.SOL: AZPIROZ BLANCO BEATRIZ. Datos registrales. T 42144 , F 128, S 8, H B 401642, I/A 9(28.04.14).

25 de Abril de 2014
Modificaciones estatutarias. ART. 5 : FIJACION DE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, FINALIZANDO EL 31 DEDICIEMBRE DE CADA AÑO. Datos registrales. T 42144 , F 128, S 8, H B 401642, I/A 8 (14.04.14).

26 de Febrero de 2014
Revocaciones. ADM.UNICO: JEAN LUC DUQUESNE. Nombramientos. ADM.UNICO: HERNANDEZ MUÑOZ JESUS. Datosregistrales. T 42144 , F 128, S 8, H B 401642, I/A 6 (14.02.14).

Otros conceptos: SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: CEPL IBERIA SL. Datos registrales. T 42144 , F 128, S 8, H B401642, I/A 7 (14.02.14).

17 de Julio de 2013
Revocaciones. APODERADO: SIERRA REY LUIS. Cambio de domicilio social. CL GARRAF,1,POL.IND. PLA DE LA BRUGUERA(CASTELLAR DEL VALLES). Datos registrales. T 42144 , F 127, S 8, H B 401642, I/A 5 ( 9.07.13).

16 de Mayo de 2013
Nombramientos. APODERADO: JEAN LOUIS DOUANNE. Datos registrales. T 42144 , F 127, S 8, H B 401642, I/A 4 ( 8.05.13).

19 de Abril de 2012
Revocaciones. ADM.UNICO: ABDELHAKIM LAMRANI. Nombramientos. ADM.UNICO: JEAN LUC DUQUESNE. Datosregistrales. T 42144 , F 126, S 8, H B 401642, I/A 3 ( 5.04.12).

28 de Octubre de 2010
Nombramientos. APODERADO: SIERRA REY LUIS. Datos registrales. T 42144 , F 124, S 8, H B 401642, I/A 2 (18.10.10).

22 de Octubre de 2010
Constitución. Comienzo de operaciones: 13.09.10. Objeto social: LA PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS DE TODACONDICION.LA COMPRAVENTA Y ALQUILER,SALVO EL FINANCIERO ACTIVO DE BIENES INMUEBLES. Domicilio: PS DEGRACIA Num.61 P.1 PTA.1 (BARCELONA). Capital: 300.000,00 Euros. Nombramientos. ADM.UNICO: ABDELHAKIM LAMRANI.Otros conceptos: DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO:COMPAGNIE EUROPEENNE DEPRESTATIONS LOGISTIQUES SAS. Datos registrales. T 42144 , F 122, S 8, H B 401642, I/A 1 ( 8.10.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información