Buscador CIF Logo

Actos BORME Cepsa Comercial Norte Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cepsa Comercial Norte Sl

Actos BORME Cepsa Comercial Norte Sl - B31715691

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Navarra para Cepsa Comercial Norte Sl con CIF B31715691

馃敊 Perfil de Cepsa Comercial Norte Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Navarra

Actos BORME de Cepsa Comercial Norte Sl

29 de Diciembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROBRES CALVO JUAN CARLOS;SANZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO;GRANDA CAMPO JUANRAMON. Presidente: GRANDA CAMPO JUAN RAMON. Consejero: HERRANZ DE LENIZ JUAN ANTONIO. SecreNoConsj: MILANCUESTA MARTA. VsecrNoConsj: DE LA VARGA GIMENO SANTIAGO. Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ FIDALGOJUAN;FERNANDEZ GARCIA JULIO;RODRIGUEZ FIDALGO JUAN;COBOS MOLINA FEDERICO;RODRIGUEZ FIDALGOJUAN;COBOS MOLINA FEDERICO;MORAN MOYA CARLOS;PEREZ ROMERA JOSE MARIA;MORAN MOYA CARLOS.Apo.Man.Soli: MARIN MORAN JUAN LUIS;GIL SAN MARTIN FRANCISCO JAVIER. Apoderado: SEBASTIAN BERRENDERO JUANANTONIO;MORAN MOYA CARLOS;FREIRE LOPEZ FRANCISCO JAVIER;GRANDA CAMPO JUAN RAMON;MARIN MORAN JUANLUIS;RUIZ GUTIERREZ JAIME;GONZALEZ ROMERO FERNANDO;SAENZ MU脩OZ GONZALO;SANCHEZ BOTRANJACINTO;GRANDA CAMPO JUAN RAMON;GARCIA MARTIN EVA;VALDES SANZ ISABEL. Otros conceptos: QUEDANCANCELADAS todas las inscripciones de la sociedad de esta hoja, al haberse recibido oficio del Registro Mercantil y de BienesMuebles de Le贸n, de fecha 19 de noviembre de 2014, no expidi茅ndose la certificaci贸n a que se refiere dicho art铆culo por no existirasiento alguno vigente. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1694 , F 107, S 8, H NA 16863, I/A 50 ( 9.12.14).

23 de Junio de 2014
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CEPSA COMERCIAL NOROESTE SL. Datos registrales. T 1694 , F 107, S 8, H NA16863, I/A 47 ( 5.06.14).

30 de Mayo de 2014
Nombramientos. Consejero: HERRANZ DE LENIZ JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 1694 , F 106, S 8, H NA 16863, I/A 46(20.05.14).

31 de Marzo de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ HERNANDEZ FLORENCIO. Presidente: PEREZ HERNANDEZ FLORENCIO. Revocaciones.Apo.Man.Soli: PEREZ HERNANDEZ FLORENCIO. Nombramientos. Apoderado: GRANDA CAMPO JUAN RAMON. Consejero:GRANDA CAMPO JUAN RAMON. Presidente: GRANDA CAMPO JUAN RAMON. Datos registrales. T 1694 , F 101, S 8, H NA16863, I/A 43 (21.03.14).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA MARTIN EVA. Datos registrales. T 1694 , F 106, S 8, H NA 16863, I/A 44 (21.03.14).

Nombramientos. Apoderado: VALDES SANZ ISABEL. Datos registrales. T 1694 , F 106, S 8, H NA 16863, I/A 45 (21.03.14).

17 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: FREIRE LOPEZ FRANCISCO JAVIER;GRANDA CAMPO JUAN RAMON;MARIN MORAN JUANLUIS;RUIZ GUTIERREZ JAIME;GONZALEZ ROMERO FERNANDO;SAENZ MU脩OZ GONZALO;SANCHEZ BOTRAN JACINTO.Datos registrales. T 1574 , F 20, S 8, H NA 16863, I/A 42 ( 5.12.13).

02 de Octubre de 2013
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 1574 , F 20, S 8, H NA 16863, I/A 41 (25.09.13).

20 de Agosto de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: RIBER GIL FRANCISCO JAVIER;GIL SAN MARTIN FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: GIL SANMARTIN FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: SANZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 1574 , F20, S 8, H NA 16863, I/A 40 ( 9.08.13).

06 de Junio de 2013
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: SANCHEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN. VsecrNoConsj: VELASCO DIAZ MARIA LUISA.Nombramientos. SecreNoConsj: MILAN CUESTA MARTA. VsecrNoConsj: DE LA VARGA GIMENO SANTIAGO. Datos registrales.T 1574 , F 20, S 8, H NA 16863, I/A 39 (29.05.13).

05 de Marzo de 2013
Revocaciones. Apoderado: ALCALDE LOPEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Apoderado: SEBASTIAN BERRENDERO JUANANTONIO;MORAN MOYA CARLOS. Datos registrales. T 1574 , F 19, S 8, H NA 16863, I/A 38 (25.02.13).

08 de Agosto de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ ROMERA JOSE MARIA. Presidente: PEREZ ROMERA JOSE MARIA. Revocaciones.Apoderado: PEREZ ROMERA JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: PEREZ HERNANDEZ FLORENCIO. Presidente: PEREZ

Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 1574 , F 18, S 8, H NA 16863, I/A 36 (30.07.12).

Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ FIDALGO JUAN. Datos registrales. T 1574 , F 18, S 8, H NA 16863, I/A 37 (30.07.12).

14 de Junio de 2012
Nombramientos. Apoderado: MORAN MOYA CARLOS. Datos registrales. T 1574 , F 12, S 8, H NA 16863, I/A 34 ( 4.06.12).

05 de Septiembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datosregistrales. T 1574 , F 12, S 8, H NA 16863, I/A 33 (19.08.11).

13 de Julio de 2011
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GIL SAN MARTIN FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Con.Delegado: GIL SAN MARTINFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 825 , F 223, S 8, H NA 16863, I/A 32 ( 2.07.11).

10 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apoderado: COBOS MOLINA FEDERICO. Datos registrales. T 825 , F 219, S 8, H NA016863, I/A00031 (28.10.10).

19 de Agosto de 2010
Nombramientos. Apoderado: ALCALDE LOPEZ JOSE LUIS;MORAN MOYA CARLOS;PEREZ ROMERA JOSE MARIA. Datosregistrales. T 825 , F 218, S 8, H NA016863, I/A00030 (10.08.10).

29 de Julio de 2010
Reelecciones. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 825 , F 218, S 8, H NA016863, I/A00029 (16.07.10).

14 de Julio de 2009
Reelecciones. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 825 , F 218, S 8, H NA016863, I/A00028 ( 3.07.09).

13 de Febrero de 2009
Nombramientos. Consejero: ROBRES CALVO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 825 , F 218, S 8, H NA016863, I/A00027 (4.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n