Buscador CIF Logo

Actos BORME Ceramica Nulense Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ceramica Nulense Sociedad Anonima

Actos BORME Ceramica Nulense Sociedad Anonima - A12016101

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Castellon para Ceramica Nulense Sociedad Anonima con CIF A12016101

馃敊 Perfil de Ceramica Nulense Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Castellon

Actos BORME de Ceramica Nulense Sociedad Anonima

13 de Noviembre de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: BARBER MESA JOAQUIN;BARBER MESA JOAQUIN. Datos registrales. T 867, L 434, F 31, S 8, H CS5044, I/A 65 ( 3.11.23).

10 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MORILLO ALEJANDRO. Datos registrales. T 867, L 434, F 21, S 8, H CS 5044, I/A 64 (2.11.23).

02 de Junio de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: BARBER MESA JOAQUIN;CARRATALA MARTINEZ ANA;QUERAL ALTAVA AMPARO. Datosregistrales. T 867, L 434, F 21, S 8, H CS 5044, I/A 62 (26.05.23).

13 de Abril de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: BARBER MESA JOAQUIN;CARRATALA MARTINEZ ANA;QUERAL ALTAVA AMPARO. Datosregistrales. T 867, L 434, F 21, S 8, H CS 5044, I/A 61 (30.03.23).

07 de Marzo de 2023
Reelecciones. Adm. Unico: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES RIMAR SOCIEDAD ANON. Datos registrales. T 867, L 434, F20, S 8, H CS 5044, I/A 60 (28.02.23).

26 de Mayo de 2021
Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 20 de los Estatutos Sociales por cambio en la retribuci贸n del 贸rgano deadministraci贸n. Datos registrales. T 867, L 434, F 20, S 8, H CS 5044, I/A 58 (19.05.21).

08 de Abril de 2021
Reelecciones. Auditor: RUSSELL BEDFORD. MARTINEZ Y OJEDA AUDITORES SL. Datos registrales. T 867, L 434, F 20, S 8, HCS 5044, I/A 57 (30.03.21).

18 de Septiembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: BARTOLL CARNICER MARIA CARMEN. Datos registrales. T 867, L 434, F 20, S 8, H CS 5044, I/A 56(30.08.19).

26 de Abril de 2019
Reelecciones. Auditor: RUSSELL BEDFORD. MARTINEZ Y OJEDA AUDITORES SL. Datos registrales. T 867, L 434, F 19, S 8, HCS 5044, I/A 55 (15.04.19).

06 de Febrero de 2019
Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 20 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 867, L 434, F 19, S 8, H CS5044, I/A 54 (25.01.19).

07 de Febrero de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: APARICI BARTOLL JAVIER;APARICI BARTOLL RICARDO;APARICI BARTOLL ENRIQUE.Secretario: APARICI BARTOLL JAVIER. Presidente: APARICI BARTOLL RICARDO. Nombramientos. Adm. Unico: INVERSIONES YREPRESENTACIONES RIMAR SOCIEDAD ANON. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION del art铆culo 20潞.. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 867, L434, F 17, S 8, H CS 5044, I/A 51 (27.01.17).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: APARICI BARTOLL ENRIQUE;APARICI BARTOLL RICARDO;APARICI BARTOLL JAVIER. Datosregistrales. T 867, L 434, F 18, S 8, H CS 5044, I/A 52 (27.01.17).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARBERA UBEDA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 867, L 434, F 18, S 8, H CS 5044, I/A 53(27.01.17).

30 de Marzo de 2016
Reelecciones. Auditor: RUSSELL BEDFORD ESPA脩A AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 867, L 434, F 17,S 8, H CS 5044, I/A 50 (17.03.16).

17 de Marzo de 2015
Reelecciones. Consejero: APARICI BARTOLL RICARDO;APARICI BARTOLL JAVIER;APARICI BARTOLL ENRIQUE. Presidente:APARICI BARTOLL RICARDO. Secretario: APARICI BARTOLL JAVIER. Datos registrales. T 867, L 434, F 17, S 8, H CS 5044, I/A49 (11.03.15).

17 de Febrero de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: APARICI BARTOLL JAVIER. Datos registrales. T 867, L 434, F 17, S 8, H CS 5044, I/A 48 (10.02.14).

09 de Mayo de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARBERA UBEDA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 630, L 197, F 110, S 8, H CS 5044, I/A 47(30.04.13).

06 de Febrero de 2013
Reelecciones. Auditor: RUSSELL BEDFORD ESPA脩A AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 630, L 197, F 110,S 8, H CS 5044, I/A 46 (30.01.13).

28 de Junio de 2011
Modificaciones estatutarias. Modificado el Art铆culo 20潞 de los estatutos sociales, al establecer Retribuci贸n del Organo deAdministraci贸n.. Datos registrales. T 630, L 197, F 110, S 8, H CS 5044, I/A 45 (15.06.11).

30 de Marzo de 2011
Ceses/Dimisiones. Auditor: RUSSELL BEDFORD AUDITORES Y CONSULTORES SL. Nombramientos. Auditor: RUSSELLBEDFORD AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 630, L 197, F 110, S 8, H CS 5044, I/A 44 (18.03.11).

31 de Agosto de 2010
Reelecciones. Consejero: APARICI BARTOLL RICARDO;APARICI BARTOLL JAVIER;APARICI BARTOLL ENRIQUE. Presidente:APARICI BARTOLL RICARDO. Secretario: APARICI BARTOLL JAVIER. Datos registrales. T 630, L 197, F 109, S 8, H CS 5044, I/A42 (18.08.10).

Nombramientos. Apo.Manc.: BARBERA UBEDA JUAN CARLOS;APARICI BARTOLL JAVIER. Datos registrales. T 630, L 197, F

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n