Actos BORME de Ceramicas Belcaire Sa
28 de Agosto de 2023Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1851, L 1411, F 183, S 8, H CS 13491, I/A 97 (21.08.23).
04 de Abril de 2022Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1851, L 1411, F 183, S 8, H CS 13491, I/A 95 (28.03.22).
31 de Marzo de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: TOUSSAINT ELOSUA FEDERICO;TOUCHE ZAMBRANO JORGE ANTONIO;NARVAEZ GARZASERGIO ERNESTO;COLOMO PRADOS DOMINGO;MICIC GORAN;GALLEGO CANOS JUAN BAUTISTA;ORTIN CAMPOS JUANFRANCISCO;ESBERT TORRES JUAN CARLOS;PEDROS NAVARRO JOSE LUIS. Datos registrales. T 1851, L 1411, F 182, S 8, HCS 13491, I/A 94 (24.03.22).
19 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: MAGRANS PERELLO ALBERTO;MUNAR SAURA MIGUEL ANGEL;CORTES CASCON MANUEL;VIDALCALVO JAUME;ALBOS BARBARROJA JUAN. Datos registrales. T 1851, L 1411, F 181, S 8, H CS 13491, I/A 92 (11.10.21).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: FRANCINO MARTI JORGE. Apoderado: AGUILERA LOPEZ JAVIER;AGUILERA LOPEZJAVIER;LASCUEVAS PEREZ SALA LORENA. Apo.Manc.: VIDAL CALVO JAUME. Apo.Sol.: VIDAL CALVO JAUME. Apo.Manc.:SEGURA DOMENECH ANTONIO;SEGURA DOMENECH ANTONIO;CORTES CASCON MANUEL;CORTES CASCON MANUEL.Apo.Sol.: CORTES CASCON MANUEL. Apo.Manc.: CASTRO URZAIZ CARLOS. Apo.Man.Soli: AGUILERA LOPEZ JAVIER.Apoderado: PEREZ CRESPO CLAUDIO;DE SAAVEDRA MALDONADO MARTA. Apo.Sol.: MAGRANS PERELLO ALBERTO;ALBOSBARBARROJA JUAN;MUNAR SAURA MIGUEL ANGEL;LAFUENTE ELIZONDO AINHOA. Apoderado: RIDAO GARCIAELENA;RIDAO GARCIA ELENA. Datos registrales. T 1851, L 1411, F 182, S 8, H CS 13491, I/A 93 (11.10.21).
07 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ CORTIJO PABLO MIGUEL;PEREZ SALGADO CONSTANTINO;CASTRO ISLAANDRES;ORRI TORREGROSA CAROLINA;DE LA FUENTE MUGURUZA IGNACIO;RIVERO SANS CLARA;OJEDA SOLERMONICA. Datos registrales. T 1851, L 1411, F 181, S 8, H CS 13491, I/A 90 (29.09.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: DE SAAVEDRA MALDONADO MARTA. Datos registrales. T 1851, L 1411, F 181, S 8, H CS 13491, I/A91 (29.09.21).
05 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: MAGRANS PERELLO ALBERTO;ALBOS BARBARROJA JUAN. Presidente: MAGRANS PERELLOALBERTO. Secretario: ALBOS BARBARROJA JUAN. Nombramientos. Presidente: NARVAEZ GARZA SERGIO ERNESTO.Consejero: TOUCHE ZAMBRANO JORGE ANTONIO;NARVAEZ GARZA SERGIO ERNESTO. SecreNoConsj: FERNANDEZ CORTIJOPABLO MIGUEL. VsecrNoConsj: PEREZ SALGADO CONSTANTINO. Datos registrales. T 1347, L 910, F 217, S 8, H CS 13491, I/A88 (28.09.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: TOUSSAINT ELOSUA FEDERICO. Apo.Man.Soli: NARVAEZ GARZA SERGIO ERNESTO;TOUCHEZAMBRANO JORGE ANTONIO. Datos registrales. T 1347, L 910, F 220, S 8, H CS 13491, I/A 89 (28.09.21).
19 de Agosto de 2021Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.872.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.894.040,00 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: REDUCCION CAPITAL. MOD.A RT. 5. Datos registrales. T 1347, L 910, F 216, S 8, H CS13491, I/A 86 (11.08.21).
Nombramientos. Apo.Manc.: PEDROS NAVARRO JOSE LUIS;GALLEGO CANOS JUAN BAUTISTA. Datos registrales. T 1347, L910, F 216, S 8, H CS 13491, I/A 87 (11.08.21).
04 de Agosto de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: TILES INVESTMENTS AND HOLDINGS SL. Datos registrales. T1347, L 910, F 216, S 8, H CS 13491, I/A 85 (28.07.21).
18 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: SEGURA DOMENECH ANTONIO;VIDAL CALVO JAUME;CORTES GASCON MANUEL. Datosregistrales. T 1347, L 910, F 216, S 8, H CS 13491, I/A 83 (11.06.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: PEDROS NAVARRO JOSE LUIS. Datos registrales. T 1347, L 910, F 216, S 8, H CS 13491, I/A 84(11.06.21).
27 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: PEDROS NAVARRO JOSE LUIS. Apo.Sol.: PEDROS NAVARRO JOSE LUIS. Datos registrales. T1347, L 910, F 213, S 8, H CS 13491, I/A 82 (20.05.21).
27 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: MICIC GORAN;ESBERT TORRES JUAN CARLOS;ORTIN CAMPOS JUAN FRANCISCO. Datosregistrales. T 1347, L 910, F 213, S 8, H CS 13491, I/A 81 (20.04.21).
26 de Abril de 2021Revocaciones. Apoderado: CALAVIA IBA脩EZ JOSE IGNACIO. Apo.Sol.: PUJOL PANTINAT DAVID. Apoderado: FIGUEROLALOPEZ DANIEL;CALAVIA IBA脩EZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 1347, L 910, F 212, S 8, H CS 13491, I/A 80 (19.04.21).
15 de Abril de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ROCA SANITARIO SA. Datos registrales. T 1347, L 910, F 212, S8, H CS 13491, I/A 79 ( 8.04.21).
04 de Marzo de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1347, L 910, F 212, S 8, H CS 13491, I/A 78 (26.02.21).
26 de Febrero de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: MICIC GORAN. Datos registrales. T 1347, L 910, F 210, S 8, H CS 13491, I/A 76 (18.02.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESBERT TORRES JUAN CARLOS. Datos registrales. T 1347, L 910, F 211, S 8, H CS 13491, I/A77 (18.02.21).
23 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: DE SAAVEDRA MALDONADO MARTA. Datos registrales. T 1347, L 910, F 210, S 8, H CS 13491, I/A75 (16.02.21).
22 de Diciembre de 2020Reelecciones. Consejero: ALBOS BARBARROJA JUAN. Secretario: ALBOS BARBARROJA JUAN. Datos registrales. T 1347, L910, F 210, S 8, H CS 13491, I/A 74 (15.12.20).
04 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: AGUILERA LOPEZ JAVIER;RIDAO GARCIA ELENA. Datos registrales. T 1257, L 820, F 176, S 8, HCS 13491, I/A 73 (29.05.20).
20 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1257, L 820, F 176, S 8, H CS 13491, I/A 70 ( 2.01.20).
Revocaciones. Apo.Manc.: FRONTERA AVELLANA GERARDO;FRONTERA AVELLANA GERARDO. Datos registrales. T 1257, L820, F 176, S 8, H CS 13491, I/A 71 ( 2.01.20).
Revocaciones. Apo.Manc.: ASENSIO ASENSIO RAMON. Datos registrales. T 1257, L 820, F 176, S 8, H CS 13491, I/A 72 (2.01.20).
17 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: ASENSIO ASENSIO RAMON. Presidente: ASENSIO ASENSIO RAMON. Nombramientos.Consejero: MAGRANS PERELLO ALBERTO. Presidente: MAGRANS PERELLO ALBERTO. Datos registrales. T 1257, L 820, F 175,S 8, H CS 13491, I/A 69 ( 4.12.19).
25 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: CASTRO URZAIZ CARLOS. Datos registrales. T 1257, L 820, F 175, S 8, H CS 13491, I/A 67(11.04.19).
Revocaciones. Apo.Manc.: LICHTSTEINER ANTON PATRICK. Datos registrales. T 1257, L 820, F 175, S 8, H CS 13491, I/A 68(11.04.19).
28 de Febrero de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: VIDAL CALVO JAUME;CORTES GASCON MANUEL;SEGURA DOMENECHANTONIO;LICHTSTEINER ANTON PATRICK. Datos registrales. T 1257, L 820, F 175, S 8, H CS 13491, I/A 66 (20.02.19).
06 de Febrero de 2019Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1257, L 820, F 174, S 8, H CS 13491, I/A 65 (29.01.19).
08 de Enero de 2019Reelecciones. Consejero: COLOMO PRADOS DOMINGO. Datos registrales. T 1257, L 820, F 174, S 8, H CS 13491, I/A 62(20.12.18).
Revocaciones. Apoderado: ARROYO VILORIA FELISA. Datos registrales. T 1257, L 820, F 174, S 8, H CS 13491, I/A 63(20.12.18).
Nombramientos. Apoderado: LASCUEVAS PEREZ SALA LORENA. Datos registrales. T 1257, L 820, F 174, S 8, H CS 13491, I/A64 (20.12.18).
10 de Agosto de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: FRONTERA AVELLANA GERARDO;CORTES CASCON MANUEL;SEGURA DOMENECH ANTONIO.Datos registrales. T 1257, L 820, F 174, S 8, H CS 13491, I/A 61 ( 1.08.18).
28 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: CALAVIA IBA脩EZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 1257, L 820, F 173, S 8, H CS 13491, I/A 60(18.05.18).
16 de Mayo de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: VILASECA MARQUES JORGE. Apo.Manc.: ROIG BARBERA SERGIO. Datos registrales. T 1257, L820, F 173, S 8, H CS 13491, I/A 59 ( 7.05.18).
21 de Diciembre de 2017Nombramientos. Apoderado: MALLEA DURBAN GONZALO. Datos registrales. T 1257, L 820, F 173, S 8, H CS 13491, I/A 58 (7.12.17).
28 de Noviembre de 2017Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1257, L 820, F 173, S 8, H CS 13491, I/A 57 (20.11.17).
10 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: ARROYO VILORIA FELISA. Datos registrales. T 1156, L 720, F 146, S 8, H CS 13491, I/A 56 (2.08.17).
19 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: ASENSIO ASENSIO RAMON;FRONTERA AVELLANA GERARDO;CORTES CASCONMANUEL;SEGURA DOMENECH ANTONIO;VIDAL CALVO JAUME. Datos registrales. T 1156, L 720, F 146, S 8, H CS 13491, I/A 56(10.05.17).
07 de Abril de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORTIN CAMPOS JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 1156, L 720, F 146, S 8, H CS 13491,I/A 54 (30.03.17).
09 de Febrero de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORTIN CAMPOS JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 1156, L 720, F 145, S 8, H CS 13491,I/A 53 (31.01.17).
05 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apoderado: PEREZ CRESPO CLAUDIO. Datos registrales. T 1156, L 720, F 145, S 8, H CS 13491, I/A 52(24.11.16).
07 de Noviembre de 2016Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1156, L 720, F 145, S 8, H CS 13491, I/A 51 (25.10.16).
15 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apoderado: AGUILERA LOPEZ JAVIER. Datos registrales. T 1156, L 720, F 144, S 8, H CS 13491, I/A 49 (1.09.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: AGUILERA LOPEZ JAVIER. Datos registrales. T 1156, L 720, F 144, S 8, H CS 13491, I/A 50 (1.09.16).
07 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apoderado: FIGUEROLA LOPEZ DANIEL. Datos registrales. T 1156, L 720, F 143, S 8, H CS 13491, I/A 47(22.08.16).
Reelecciones. Consejero: ASENSIO ASENSIO RAMON. Presidente: ASENSIO ASENSIO RAMON. Datos registrales. T 1156, L720, F 143, S 8, H CS 13491, I/A 48 (30.08.16).
29 de Diciembre de 2015Reelecciones. Consejero: ALBOS BARBARROJA JUAN. Secretario: ALBOS BARBARROJA JUAN. Datos registrales. T 1156, L720, F 143, S 8, H CS 13491, I/A 46 (18.12.15).
02 de Noviembre de 2015Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1156, L 720, F 143, S 8, H CS 13491, I/A 45 (23.10.15).
16 de Septiembre de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: ROIG BARBERA SERGIO. Datos registrales. T 1156, L 720, F 142, S 8, H CS 13491, I/A 44 (9.09.15).
05 de Marzo de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 7.453.560,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.766.440,00 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: Modificado el Art铆culo 5潞 de los Estatutos por reducci贸n del capital social. Datos registrales. T1156, L 720, F 142, S 8, H CS 13491, I/A 43 (25.02.15).
14 de Enero de 2015Nombramientos. Apoderado: RIDAO GARCIA ELENA. Datos registrales. T 1156, L 720, F 142, S 8, H CS 13491, I/A 42 (31.12.14).
10 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ ALSEDA AGUSTIN. Co.De.Ma.So: LOPEZ ALSEDA AGUSTIN. Nombramientos.Consejero: COLOMO PRADOS DOMINGO. Apo.Man.Soli: COLOMO PRADOS DOMINGO. Datos registrales. T 1120, L 684, F 212,S 8, H CS 13491, I/A 30 ( 3.04.13).
06 de Marzo de 2013Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1120, L 684, F 211, S 8, H CS 13491, I/A 40 (27.02.13).
10 de Mayo de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: ASENJO GOMEZ JORDI. Datos registrales. T 1120, L 684, F 211, S 8, H CS 13491, I/A 39(26.04.11).
24 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: ROCA SANS JOSE MIGUEL. Presidente: ROCA SANS JOSE MIGUEL. Nombramientos.Consejero: ASENSIO ASENSIO RAMON. Presidente: ASENSIO ASENSIO RAMON. Datos registrales. T 1120, L 684, F 211, S 8, HCS 13491, I/A 38 (15.03.11).
06 de Julio de 2010Reelecciones. Consejero: ROCA SANS JOSE MIGUEL;ALBOS BARBARROJA JUAN. Datos registrales. T 1120, L 684, F 211, S 8,H CS 13491, I/A 37 (28.06.10).
15 de Abril de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: VILASECA MARQUES JORGE. Datos registrales. T 1120, L 684, F 210, S 8, H CS 13491, I/A 36 (6.04.10).
10 de Febrero de 2010Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1120, L 684, F 210, S 8, H CS 13491, I/A 35 ( 2.02.10).
20 de Marzo de 2009Revocaciones. Apo.Man.Soli: VIDAL CALVO JAUME. Datos registrales. T 1120, L 684, F 210, S 8, H CS 13491, I/A 34 ( 9.03.09).