Actos BORME de Ceramicas Gala Sa
15 de Junio de 2023Nombramientos. Apoderado: BRAVO NUEVO IGNACIO. Datos registrales. T 755, L 546, F 204, S 8, H BU 2786, I/A 137 ( 9.06.23).
10 de Abril de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: BLANCH MARTINEZ INMACULADA. Datos registrales. T 755, L 546, F 202, S 8, H BU 2786, I/A 134(31.03.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: SEGURA DOMENECH ANTONIO. Datos registrales. T 755, L 546, F 202, S 8, H BU 2786, I/A 135(31.03.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: SEGURA DOMENECH ANTONIO. Datos registrales. T 755, L 546, F 203, S 8, H BU 2786, I/A 136(31.03.23).
21 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 755, L 546, F 201, S 8, H BU 2786, I/A 132 (15.12.21).
07 de Enero de 2021Reelecciones. Consejero: MUNAR SAURA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 755, L 546, F 200, S 8, H BU 2786, I/A 129(29.12.20).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CRISOL GIRALT MIQUEL. Apoderado: CRISOL GIRALT MIQUEL. Datos registrales. T 755, L 546, F200, S 8, H BU 2786, I/A 130 (29.12.20).
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 755, L 546, F 201, S 8, H BU 2786, I/A 131 (29.12.20).
29 de Octubre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: MUNAR SAURA MIGUEL ANGEL;CORTES CASCON MANUEL. Datos registrales. T 755, L 546, F 200,S 8, H BU 2786, I/A 128 (23.10.20).
23 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: GARCIA ALONSO BLANCA ESTER. Datos registrales. T 755, L 546, F 199, S 8, H BU 2786, I/A 127(16.07.20).
03 de Junio de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: AGUILERA LOPEZ JAVIER;RIDAO GARCIA ELENA. Datos registrales. T 755, L 546, F 199, S 8, H BU2786, I/A 126 (28.05.20).
06 de Mayo de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA ALONSO BLANCA ESTER. Datos registrales. T 755, L 546, F 197, S 8, H BU 2786, I/A125 (29.04.20).
03 de Enero de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: FRONTERA AVELLANA GERARDO;FRONTERA AVELLANA GERARDO;FRONTERA AVELLANAGERARDO. Datos registrales. T 755, L 546, F 197, S 8, H BU 2786, I/A 123 (27.12.19).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ASENSIO ASENSIO RAMON. Apo.Manc.: ASENSIO ASENSIO RAMON. Datos registrales. T 755, L546, F 197, S 8, H BU 2786, I/A 124 (27.12.19).
19 de Diciembre de 2019Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 755, L 546, F 197, S 8, H BU 2786, I/A 122 (12.12.19).
27 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: ASENSIO ASENSIO RAMON. Presidente: ASENSIO ASENSIO RAMON. Nombramientos.Consejero: MAGRANS PERELLO ALBERTO. Presidente: MAGRANS PERELLO ALBERTO. Datos registrales. T 755, L 546, F 196,S 8, H BU 2786, I/A 120 (21.11.19).
Nombramientos. Apoderado: MAGRANS PERELLO ALBERTO. Datos registrales. T 755, L 546, F 196, S 8, H BU 2786, I/A 121(21.11.19).
23 de Septiembre de 2019Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 755, L 546, F 196, S 8, H BU 2786, I/A 119 (17.09.19).
26 de Agosto de 2019Nombramientos. Apoderado: CRISOL GIRALT MIQUEL. Datos registrales. T 755, L 546, F 195, S 8, H BU 2786, I/A 118(20.08.19).
15 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: CASTRO URZAIZ CARLOS. Datos registrales. T 755, L 546, F 194, S 8, H BU 2786, I/A 117 (9.04.19).
Revocaciones. Apo.Manc.: LICHTSTEINER ANTON PATRICK. Datos registrales. T 755, L 546, F 194, S 8, H BU 2786, I/A 116 (9.04.19).
13 de Marzo de 2019Otros conceptos: Se actualiza la designación del domicilio de la sociedad que en adelante será: Carretera Madrid-Irun Km. 244 C.P.09007, Burgos,. Datos registrales. T 755, L 546, F 194, S 8, H BU 2786, I/A 115 ( 6.03.19).
Nombramientos. Apo.Manc.: VIDAL CALVO JAUME;CORTES CASCON MANUEL;SEGURA DOMENECHANTONIO;LICHTSTEINER ANTON PATRICK. Datos registrales. T 755, L 546, F 194, S 8, H BU 2786, I/A 114 ( 6.03.19).
29 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: FRONTERA AVELLANA GERARDO. Nombramientos. Consejero: CORTES CASCON MANUEL.Datos registrales. T 674, L 465, F 199, S 8, H BU 2786, I/A 113 (23.01.19).
08 de Agosto de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: CORTES CASCON MANUEL;FRONTERA AVELLANA GERARDO;SEGURA DOMENECH ANTONIO.Datos registrales. T 674, L 465, F 199, S 8, H BU 2786, I/A 112 ( 2.08.18).
21 de Noviembre de 2017Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 674, L 465, F 198, S 8, H BU 2786, I/A 111 (15.11.17).
22 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: ASENSIO ASENSIO RAMON;FRONTERA AVELLANA GERARDO;VIDAL CALVO JAUME;CORTESCASCON MANUEL;SEGURA DOMENECH ANTONIO. Datos registrales. T 674, L 465, F 198, S 8, H BU 2786, I/A 110 (16.05.17).
12 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apoderado: PEREZ CRESPO CLAUDIO. Datos registrales. T 674, L 465, F 197, S 8, H BU 2786, I/A 108(29.11.16).
Nombramientos. Apoderado: AGUILERA LOPEZ JAVIER. Datos registrales. T 674, L 465, F 198, S 8, H BU 2786, I/A 109(29.11.16).
26 de Octubre de 2016Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 674, L 465, F 197, S 8, H BU 2786, I/A 107 (20.10.16).
12 de Julio de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: CALVO DE LA MARCA TEODORO. Datos registrales. T 674, L 465, F 197, S 8, H BU 2786, I/A 106 (6.07.16).
17 de Mayo de 2016Nombramientos. Apo.Manc.: SEVILLA ANDRES JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 674, L 465, F 196, S 8, H BU 2786, I/A 105(10.05.16).
26 de Octubre de 2015Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 674, L 465, F 196, S 8, H BU 2786, I/A 104 (20.10.15).
19 de Enero de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: CALVO DE LA MARCA TEODORO;SEVILLA ANDRES JOSE IGNACIO;SALVADOR COMES JOSEP.Datos registrales. T 586, L 377, F 66, S 8, H BU 2786, I/A 80 (11.05.09).
Ceses/Dimisiones. Consejero: SALVADOR COMES JOSE. Nombramientos. Consejero: MUNAR SAURA MIGUEL ANGEL. Datosregistrales. T 674, L 465, F 194, S 8, H BU 2786, I/A 102 (13.01.15).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SALVADOR COMES JOSE. Apoderado: SALVADOR COMES JOSE;SALVADOR COMESJOSE;SALVADOR COMES JOSE. Apo.Manc.: SALVADOR COMES JOSEP. Apoderado: SALVADOR COMES JOSE.Nombramientos. Apo.Man.Soli: MUNAR SAURA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 674, L 465, F 195, S 8, H BU 2786, I/A 103(13.01.15).
30 de Julio de 2014Ampliación de capital. Suscrito: 900,00 Euros. Desembolsado: 900,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.500.900,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 4.500.900,00 Euros. Datos registrales. T 674, L 465, F 193, S 8, H BU 2786, I/A 100 (23.07.14).
Reelecciones. Consejero: ASENSIO ASENSIO RAMON;FRONTERA AVELLANA GERARDO. Presidente: ASENSIO ASENSIORAMON. Datos registrales. T 674, L 465, F 193, S 8, H BU 2786, I/A 101 (23.07.14).
26 de Marzo de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: RIDAO GARCIA ELENA. Datos registrales. T 618, L 409, F 158, S 8, H BU 2786, I/A 97 (20.03.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CRISOL GIRALT MIQUEL. Datos registrales. T 618, L 409, F 158, S 8, H BU 2786, I/A 98(20.03.14).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CESAR RUSCO PEDRO. Datos registrales. T 674, L 465, F 193, S 8, H BU 2786, I/A 99 (20.03.14).
05 de Febrero de 2013Nombramientos. Apoderado: SEVILLA ANDRES JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 618, L 409, F 157, S 8, H BU 2786, I/A 96(29.01.13).
18 de Octubre de 2012Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 618, L 409, F 157, S 8, H BU 2786, I/A 95 ( 9.10.12).
18 de Abril de 2012Nombramientos. Apoderado: SALVADOR COMES JOSE. Datos registrales. T 618, L 409, F 157, S 8, H BU 2786, I/A 94 ( 4.04.12).
12 de Enero de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: BRAVO NUEVO IGNACIO. Datos registrales. T 618, L 409, F 157, S 8, H BU 2786, I/A 93 ( 2.01.12).
17 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: BRAVO NUEVO IGNACIO. Datos registrales. T 618, L 409, F 156, S 8, H BU 2786, I/A 92 ( 8.11.11).
20 de Julio de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: HINJOS GARCIA LEOPOLDO;PURCALLA BONILLA LUCIA. Datos registrales. T 618, L 409, F 156, S8, H BU 2786, I/A 91 (12.07.11).
29 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Presidente: ROCA SANS JOSE MIGUEL. Consejero: ROCA SANS JOSE MIGUEL. Nombramientos.Presidente: ASENSIO ASENSIO RAMON. Apo.Man.Soli: ASENSIO ASENSIO RAMON. Datos registrales. T 618, L 409, F 155, S 8,H BU 2786, I/A 89 (18.03.11).
Revocaciones. Apoderado: ROCA SANS JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 618, L 409, F 155, S 8, H BU 2786, I/A 90 (18.03.11).
29 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: CALVO DE LA MARCA TEODORO. Apo.Manc.: CALVO DE LA MARCA TEODORO;CALVO DE LAMARCA TEODORO. Datos registrales. T 618, L 409, F 155, S 8, H BU 2786, I/A 87 (20.12.10).
Revocaciones. Apoderado: BARRASA RUIZ PABLO. Apo.Manc.: BARRASA RUIZ PABLO. Datos registrales. T 618, L 409, F 155,S 8, H BU 2786, I/A 88 (20.12.10).
16 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apoderado: PUJOL PANTINAT DAVID. Datos registrales. T 618, L 409, F 155, S 8, H BU 2786, I/A 86 ( 4.11.10).
12 de Julio de 2010Reelecciones. Consejero: ROCA SANS JOSE MIGUEL;SALVADOR COMES JOSE. Presidente: ROCA SANS JOSE MIGUEL.Datos registrales. T 586, L 377, F 68, S 8, H BU 2786, I/A 85 ( 1.07.10).
20 de Mayo de 2010Nombramientos. Apoderado: BARRASA RUIZ PABLO. Apo.Manc.: BARRASA RUIZ PABLO. Datos registrales. T 586, L 377, F 68,S 8, H BU 2786, I/A 84 (11.05.10).
23 de Marzo de 2010Revocaciones. Apoderado: VAL PRUGENT JOSE. Apo.Manc.: VAL PRUGENT JOSE;VAL PRUGENT JOSE;VAL PRUGENT JOSE.Datos registrales. T 586, L 377, F 67, S 8, H BU 2786, I/A 83 (11.03.10).
22 de Febrero de 2010Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 586, L 377, F 67, S 8, H BU 2786, I/A 82 (11.02.10).
29 de Septiembre de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: CESAR RUSCO PEDRO. Datos registrales. T 586, L 377, F 66, S 8, H BU 2786, I/A 81 (18.09.09).
21 de Mayo de 2009Otros conceptos: Se revoca tan solo los poderes: a Teodoro Calvo de la Marca, en escritura 2145, de 29/5/2008; Mariano ArmijoPenalva, en escritura 23/12/2003, nº 4153 y José Salvador Comes, en escritura 12/2/2008, nº 575, otorgadas ante el Notario deBarcelona Sr. García Ruiz, en cuánto a la facultad Y. BANCOS. Datos registrales. T 586, L 377, F 66, S 8, H BU 2786, I/A 79(11.05.09).
Revocaciones. Apoderado: SEVILLA ANDRES JOSE IGNACIO;CALVO DE LA MARCA TEODORO. Nombramientos. Apo.Sol.:SEVILLA ANDRES JOSE IGNACIO. Apo.Manc.: ARMIJO PENALVA MARIANO;CALVO DE LA MARCA TEODORO;SEVILLAANDRES JOSE IGNACIO;SALVADOR COMES JOSEP. Datos registrales. T 586, L 377, F 66, S 8, H BU 2786, I/A 80 (11.05.09).
13 de Febrero de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: CALVO DE LA MARCA TEODORO;SEVILLA ANDRES JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 586, L377, F 66, S 8, H BU 2786, I/A 78 ( 3.02.09).
10 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: SEVILLA ANDRES JOSE IGNACIO;CALVO DE LA MARCA TEODORO. Apo.Manc.: CALVO DE LAMARCA TEODORO;SEVILLA ANDRES JOSE IGNACIO;SALVADOR COMES JOSEP. Datos registrales. T 586, L 377, F 65, S 8, HBU 2786, I/A 76 (26.01.09).
Nombramientos. Apo.Manc.: SALVADOR COMES JOSEP;CALVO DE LA MARCA TEODORO;SEVILLA ANDRES JOSE IGNACIO.Datos registrales. T 586, L 377, F 65, S 8, H BU 2786, I/A 77 (26.01.09).