Actos BORME de Ceribeco Sl
15 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: NEGLEIN HANS GERD. Presidente: NEGLEIN HANS GERD. Consejero: CARULLA FONT ARTUR.Secretario: CARULLA FONT ARTUR. Consejero: LUDEKE ANDREA ERNESTINA;SIEBOLD MATTHIAS;CHEMTROL ESPA脩OLASA;GARCIA BOSCH XAVIER. Nombramientos. Liquidador: CONSORCIO DE JABUGO SOCIEDAD ANONIMA. Disoluci贸n.Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 5006 , F 154, S 8, H SE 48565, I/A 14 (29.08.11).
02 de Marzo de 2011Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: MODIFICACION DEL ARTICULO 4潞.-. Cambio de domicilio social. AVDADE LA CONSTITUCION 24 5 - CP: 41004 (SEVILLA). Datos registrales. T 5006 , F 153, S 8, H SE 48565, I/A 13 (17.02.11).
27 de Agosto de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: MORA GRISO GUILLERMO. Nombramientos. Consejero: GARCIA BOSCH XAVIER.Modificaciones estatutarias. 14. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 5006 , F 152, S 8, H SE 48565, I/A 12(10.08.10).
18 de Febrero de 2009Revocaciones. Apo.Man.Soli: REVILLA SAAVEDRA JULIO ANTONIO;JOSE CUELLAR MALLOFRET. Datos registrales. T 3479 , F163, S 8, H SE 48565, I/A 5 ( 2.02.09).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CHEMTROL ESPA脩OLA SA. Otros conceptos: El poder se confiere en la forma y con los l铆mitesque resultan de la escritura otorgada en Sevilla, el doce de enero de dos mil nueve, ante el Notario Don Pedro Antonio RomeroCandau, numero 38 de protocolo.- Datos registrales. T 3479 , F 163, S 8, H SE 48565, I/A 6 ( 2.02.09).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MATIAS FRANCISCO PASCUAL NARVAEZ. Datos registrales. T 3479 , F 168, S 8, H SE 48565,I/A 8 ( 2.02.09).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORILLO LECO ALVARO. Datos registrales. T 5006 , F 150, S 8, H SE 48565, I/A 9 ( 2.02.09).
Nombramientos. Apoderado: MAGDALENA CERERO DE LA ROSA. Datos registrales. T 5006 , F 152, S 8, H SE 48565, I/A 10 (2.02.09).
Nombramientos. Apoderado: ROMERO ESLAVA JAIME. Datos registrales. T 5006 , F 152, S 8, H SE 48565, I/A 11 ( 2.02.09).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALCAZAR MARTINEZ ALFONSO GABRIEL. Datos registrales. T 5006 , F 165, S 8, H SE 48565,I/A 7 ( 2.02.09).
Otros conceptos: El poder se confiere en la forma y con los limites que resultan de la escritura otorgada en Sevilla, el docoe de enerode dos mil nueve, ante el Notario Don Pedro Antonio Romero Candau, numero 39 de protocolo.- Datos registrales. T 3479 , F 165, S8, H SE 48565, I/A 7 ( 2.02.09).
03 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: NEGLEIN HANS GERD. Presidente: NEGLEIN HANS GERD. Consejero: JOSE CUELLARMALLOFRET. Secretario: JOSE CUELLAR MALLOFRET. Consejero: REVILLA SAAVEDRA JULIO ANTONIO;MATIAS FRANCISCOPASCUAL NARVAEZ;SOLANO CURTO FERNANDO;ANDREA ERNESTINE LUDEKE. Nombramientos. Consejero: NEGLEINHANS GERD. Presidente: NEGLEIN HANS GERD. Consejero: CARULLA FONT ARTUR. Secretario: CARULLA FONT ARTUR.Consejero: LUDEKE ANDREA ERNESTINA;SIEBOLD MATTHIAS;CHEMTROL ESPA脩OLA SA;MORA GRISO GUILLERMO.Modificaciones estatutarias. 13. Duraci贸n y retribuci贸n. El administrador ejercer谩 su cargo por plazo de cinco a帽os y podr谩 serremovido del mismo en cualquier tiempo por la Junta General. El cargo de administrador no ser谩 retribuido. No se requiere la condid贸nde socio para ser administrador..-. Datos registrales. T 3479 , F 162, S 8, H SE 48565, I/A 4 (22.01.09).