Buscador CIF Logo

Actos BORME Cetelem Gestion Aie

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cetelem Gestion Aie

Actos BORME Cetelem Gestion Aie - V81380917

Tenemos registrados 79 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Cetelem Gestion Aie con CIF V81380917

馃敊 Perfil de Cetelem Gestion Aie
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Cetelem Gestion Aie

17 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: EIZAGUIRE DE VICTORIA CRISTINA. Datos registrales. T 42243 , F 53, S 8, H M 167370, I/A 126 (9.08.23).

31 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: VIGNARD-ROSEZ FRANCK LAURENT ROLAND WILFRIED;JIMENEZ PEREZ JUAN;PALOMO ATANCEMARIA VICTORIA;DAUDEN CASAS JOSE;YUSTE DE LA FUENTE MARIA DE LOS ANGELES;LOPEZ GONZALEZ ELENA;RUBIOGONZALEZ OLGA;MARTIN VERDAGUER MARCOS;GARCIA GARCES SERGIO;BARREDO LOPEZ DANIEL;PEREZ IZQUIERDOMARIAN;VICENTE ALVAREZ NESTOR. Apo.Sol.: JIMENEZ PEREZ JUAN. Datos registrales. T 42243 , F 53, S 8, H M 167370, I/A125 (24.10.22).

19 de Abril de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: CORTES REQUENA JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 42243 , F 52, S 8, H M 167370, I/A 124 (8.04.22).

14 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: MOURIZ COSTA JOAQUIN. Datos registrales. T 42243 , F 51, S 8, H M 167370, I/A 123 ( 7.03.22).

18 de Enero de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: ANGEL ALEJANDRO PEREZ ESTEVE;VICENTE ALVAREZ NESTOR;PEREZ IZQUIERDOMARIAN;BARREDO LOPEZ DANIEL;GARCIA GARCES SERGIO;MARTIN VERDAGUER MARCOS;RUBIO GONZALEZOLGA;LOPEZ GONZALEZ ELENA;YUSTE DE LA FUENTE MARIA DE LOS ANGELES;DAUDEN CASAS JOSE;PALOMO ATANCEMARIA VICTORIA;ANTIGLIO XAVIER GEORGES;VIGNARD-ROSEZ FRANCK LAURENT ROLAND WILFRIED. Datos registrales. T42243 , F 50, S 8, H M 167370, I/A 121 (11.01.22).

Revocaciones. Apoderado: MASIP COBOS MARIA JESUS;MASIP COBOS MARIA JESUS. Datos registrales. T 42243 , F 51, S 8,H M 167370, I/A 122 (11.01.22).

17 de Enero de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ DE MESA VARGAS JOSE MANUEL;ANGEL ALEJANDRO PEREZ ESTEVE;VICENTEALVAREZ NESTOR;PEREZ IZQUIERDO MARIAN;BARREDO LOPEZ DANIEL;GARCIA GARCES SERGIO;MARTIN VERDAGUERMARCOS;RUBIO GONZALEZ OLGA;LOPEZ GONZALEZ ELENA;DAUDEN CASAS JOSE;YUSTE DE LA FUENTE MARIA DE LOSANGELES;PALOMO ATANCE MARIA VICTORIA;ANTIGLIO XAVIER GEORGES;VIGNARD-ROSEZ FRANCK LAURENT ROLANDWILFRIED. Datos registrales. T 42243 , F 50, S 8, H M 167370, I/A 120 (10.01.22).

22 de Octubre de 2021
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 10 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 32719 ,F 196, S 8, H M 167370, I/A 119 (15.10.21).

20 de Octubre de 2021
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32719 , F 196, S 8, H M 167370, I/A 118 (13.10.21).

06 de Julio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO GONZALEZ OLGA;GARCIA GARCES SERGIO;MARTIN VERDAGUER MARCOS;YUSTE DE LAFUENTE MARIA ANGELES;LOPEZ GONZALEZ ELENA;JIMENEZ PEREZ JUAN;DAUDEN CASAS JOSE. Datos registrales. T32719 , F 195, S 8, H M 167370, I/A 117 (29.06.21).

15 de Abril de 2021
Nombramientos. Apoderado: DAUDEN CASAS JOSE. Datos registrales. T 32719 , F 193, S 8, H M 167370, I/A 114 ( 8.04.21).

Nombramientos. Apoderado: MONROY LOPEZ LUZ LORENA. Datos registrales. T 32719 , F 193, S 8, H M 167370, I/A 115 (8.04.21).

Nombramientos. Apoderado: DELGADO JIMENEZ ANTONIO FELIPE. Datos registrales. T 32719 , F 195, S 8, H M 167370, I/A116 ( 8.04.21).

26 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: VIGNARD-ROSEZ FRANCK LAURENT ROLAND WILFRIED;VIGNARD-ROSEZ FRANCK LAURENTROLAND WILFRIED;LE BOLES SERGE LEON MAURICE;VIGNARD-ROSEZ FRANK LAURENT ROLAND WILFRIED. Datosregistrales. T 32719 , F 192, S 8, H M 167370, I/A 113 (19.11.20).

12 de Noviembre de 2020
Cambio de domicilio social. PASEO DE LOS MELANCOLICOS 14 A (MADRID). Datos registrales. T 32719 , F 192, S 8, H M167370, I/A 112 ( 4.11.20).

21 de Julio de 2020
Revocaciones. Apo.Manc.: JIMENEZ PEREZ JUAN;PALOMO ATANCE MARIA VICTORIA;YUSTE DE LA FUENTE MARIA DE LOSANGELES;LOPEZ GONZALEZ ELENA;RUBIO GONZALEZ OLGA;MARTIN VERDAGUER MARCOS;GARCIA GARCESSERGIO;BARREDO LOPEZ DANIEL. Datos registrales. T 32719 , F 192, S 8, H M 167370, I/A 111 (14.07.20).

25 de Junio de 2020
Nombramientos. Apo.Manc.: VIGNARD-ROSEZ FRANCK LAURENT ROLAND WILFRIED;JIMENEZ PEREZ JUAN;PALOMOATANCE MARIA VICTORIA;DAUDEN CASAS JOSE;YUSTE DE LA FUENTE MARIA DE LOS ANGELES;LOPEZ GONZALEZELENA;RUBIO GONZALEZ OLGA;MARTIN VERDAGUER MARCOS;GARCIA GARCES SERGIO;BARREDO LOPEZ DANIEL;PEREZIZQUIERDO MARIAN;VICENTE ALVAREZ NESTOR. Datos registrales. T 32719 , F 191, S 8, H M 167370, I/A 110 (18.06.20).

18 de Mayo de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LE BOLES SERGE LEON MAURICE. Nombramientos. Adm. Unico: VIGNARD-ROSEZ FRANCKLAURENT ROLAND WILFRIED. Datos registrales. T 32719 , F 191, S 8, H M 167370, I/A 109 ( 8.05.20).

08 de Mayo de 2020
Revocaciones. Apoderado: CASTI脩EIRA CABEZAS MARIANO. Datos registrales. T 32719 , F 190, S 8, H M 167370, I/A 107(29.04.20).

Nombramientos. Apoderado: DE LA ROSA VALVERDE GONZALO. Datos registrales. T 32719 , F 190, S 8, H M 167370, I/A 108(29.04.20).

23 de Enero de 2020
Nombramientos. Apoderado: VIGNARD-ROSEZ FRANK LAURENT ROLAND WILFRIED. Datos registrales. T 32719 , F 189, S 8,H M 167370, I/A 106 (17.01.20).

19 de Diciembre de 2019
Otros conceptos: REVOCACION PARCIAL DE FACULTADES DE DON MARIANO CASTI脩EIRAS CABEZA CONFERIDAS ENINSCRIPCION 92. Datos registrales. T 32719 , F 188, S 8, H M 167370, I/A 104 (12.12.19).

Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ-ALEMAN RODRIGUEZ JOSE-IGNACIO;BEDACARRAZ MARIANA. Datos registrales. T32719 , F 188, S 8, H M 167370, I/A 105 (12.12.19).

21 de Octubre de 2019
Nombramientos. Socio Miembr: XFERA CONSUMER FINANCE ESTABLECIMIENTO FINANCIERO. Modificaciones estatutarias.Modificados los art铆culos 5潞 y 6潞 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 32719 , F 188, S 8, H M 167370, I/A 103 (14.10.19).

30 de Julio de 2019
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32719 , F 187, S 8, H M 167370, I/A 102 (23.07.19).

07 de Junio de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: FUENTES SANCHEZ RAFAEL VICTOR;CORTES REQUENA JUAN ANTONIO;EIZAGUIRE DEVICTORIA CRISTINA. Datos registrales. T 32719 , F 186, S 8, H M 167370, I/A 101 (31.05.19).

06 de Junio de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: LOPEZ GONZALEZ ELENA;MARTIN VERDAGUER MARCOS;GARCIA GARCES SERGIO. Datosregistrales. T 32719 , F 186, S 8, H M 167370, I/A 100 (29.05.19).

11 de Abril de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: BEDACARRATZ MARIANA;PALOMO ATANCE MARIA VICTORIA;YUSTE DE LA FUENTE MARIA DELOS ANGELES;RUBIO GONZALEZ OLGA;BARREDO LOPEZ DANIEL. Datos registrales. T 32719 , F 186, S 8, H M 167370, I/A 99( 4.04.19).

09 de Abril de 2019
Nombramientos. Apo.Manc.: JIMENEZ PEREZ JUAN;PALOMO ATANCE MARIA VICTORIA;YUSTE DE LA FUENTE MARIA DELOS ANGELES;LOPEZ GONZALEZ ELENA;RUBIO GONZALEZ OLGA;MARTIN VERDAGUER MARCOS;GARCIA GARCESSERGIO;BARREDO LOPEZ DANIEL. Datos registrales. T 32719 , F 185, S 8, H M 167370, I/A 98 ( 2.04.19).

31 de Agosto de 2018
Otros conceptos: REVOCACION PARCIAL DE FACULTADES DE DO脩A MARIA JESUS MASIP COBOS CONFERIDAS ENINSCRIPCION 28, Y DE DON ANTONIO GIRALDO BURGOS EN LA INSCRIPCION 58. Datos registrales. T 32719 , F 185, S 8, H M167370, I/A 97 (24.08.18).

02 de Agosto de 2018
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32719 , F 184, S 8, H M 167370, I/A 96 (25.07.18).

11 de Junio de 2018
Otros conceptos: Revocadas las facultades n煤meros 7, 17 y 20 del poder conferido a don Franck Laurent Roland Wilfried Vignard-Rosez, que caus贸 la inscripci贸n 65. Datos registrales. T 32719 , F 184, S 8, H M 167370, I/A 95 ( 4.06.18).

19 de Abril de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: BEDACARRATZ MARIANA;PALOMO ATANCE MARIA VICTORIA;YUSTE DE LA FUENTE MARIA DELOS ANGELES;LOPEZ GONZALEZ ELENA;RUBIO GONZALEZ OLGA;MARTIN VERDAGUER MARCOS;GARCIA GARCESSERGIO;BARREDO LOPEZ DANIEL. Datos registrales. T 32719 , F 182, S 8, H M 167370, I/A 91 (11.04.18).

Nombramientos. Apoderado: CASTI脩EIRA CABEZAS MARIANO. Datos registrales. T 32719 , F 183, S 8, H M 167370, I/A 92(11.04.18).

Revocaciones. Apo.Manc.: BEDACARRATZ MARIANA;PALOMO ATANCE MARIA VICTORIA;YUSTE DE LA FUENTE MARIA DELOS ANGELES;RUBIO GONZALEZ OLGA;PEREZ IZQUIERDO MARIAN;BARREDO LOPEZ DANIEL. Datos registrales. T 32719 , F184, S 8, H M 167370, I/A 93 (11.04.18).

Revocaciones. Apoderado: DE LA ROSA VALVERDE GONZALO. Datos registrales. T 32719 , F 184, S 8, H M 167370, I/A 94

19 de Marzo de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ZEITOUN GILLES DENIS DAVID. Nombramientos. Adm. Unico: LE BOLES SERGE LEONMAURICE. Datos registrales. T 32719 , F 182, S 8, H M 167370, I/A 90 (12.03.18).

04 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: BARREDO LOPEZ DANIEL. Datos registrales. T 32719 , F 180, S 8, H M 167370, I/A 88 (27.11.17).

Nombramientos. Apoderado: LE BOLES SERGE LEON MAURICE. Datos registrales. T 32719 , F 181, S 8, H M 167370, I/A 89(27.11.17).

23 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apo.Manc.: BARREDO LOPEZ DANIEL. Datos registrales. T 32719 , F 180, S 8, H M 167370, I/A 87 (15.11.17).

12 de Julio de 2017
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32719 , F 180, S 8, H M 167370, I/A 86 ( 4.07.17).

11 de Julio de 2017
Reelecciones. Adm. Unico: ZEITOUN GILLES DENIS DAVID. Datos registrales. T 32719 , F 180, S 8, H M 167370, I/A 85(29.06.17).

27 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apo.Manc.: BARREDO LOPEZ DANIEL;ZEITOUN GILLES DENIS DAVID. Datos registrales. T 32719 , F 179, S 8,H M 167370, I/A 84 (17.03.17).

05 de Enero de 2017
Nombramientos. Apo.Manc.: BEDACARRATZ MARIANA;PALOMO ATANCE MARIA VICTORIA;YUSTE DE LA FUENTE MARIA DELOS ANGELES;RUBIO GONZALEZ OLGA;PEREZ IZQUIERDO MARIAN;ZEITOUN GILLES DENIS DAVID. Datos registrales. T32719 , F 178, S 8, H M 167370, I/A 83 (27.12.16).

22 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: PALOMO ATANCE MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 32719 , F 177, S 8, H M 167370, I/A 79(14.12.16).

Nombramientos. Apoderado: YUSTE DE LA FUENTE MARIA ANGELES. Datos registrales. T 32719 , F 178, S 8, H M 167370, I/A80 (14.12.16).

Otros conceptos: Revocaci贸n parcial del poder conferido a D陋 Mariana Bedacarratz en virtud de escritura otorgada ante el Notario D.Ignacio Ramos Covarrubias el 28-09-15 con n煤mero 6221 de su protocolo y que caus贸 la inscripci贸n 74陋 de la hoja social, s贸lo enrelaci贸n a las facultades n煤meros 13 y 17. Datos registrales. T 32719 , F 178, S 8, H M 167370, I/A 81 (14.12.16).

Revocaciones. Apoderado: YUSTE DE LA FUENTE MARIA ANGELES;PALOMO ATANCE MARIA VICTORIA. Datos registrales. T32719 , F 178, S 8, H M 167370, I/A 82 (15.12.16).

08 de Julio de 2016
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32719 , F 177, S 8, H M 167370, I/A 78 (30.06.16).

07 de Julio de 2016
Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ ALDAMA I脩IGO. Datos registrales. T 32719 , F 177, S 8, H M 167370, I/A 77 (29.06.16).

08 de Marzo de 2016
Otros conceptos: Queda como socio de la AIE, la entidad GCC Consumo E.F.C., S.A., al adquirir por compra a Banco Cetelem, S.A.,una participaci贸n, la n煤mero 90. Datos registrales. T 32719 , F 176, S 8, H M 167370, I/A 76 (25.02.16).

15 de Enero de 2016
Nombramientos. Socio: BANCO CETELEM SA. Modificaciones estatutarias. Se modifican los art铆culos 5 y 6 de los estatutos..Otros conceptos: Queda como socio de la AIE, la entidad Banco Cetelem, S.A., adquiri贸 por sucesi贸n universal todos los activos ypasivos de Euro Cr茅dito, E.F.C., S.A. Datos registrales. T 32719 , F 176, S 8, H M 167370, I/A 75 ( 8.01.16).

12 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: BEDACARRAZ MARIANA. Datos registrales. T 32719 , F 175, S 8, H M 167370, I/A 74 ( 4.11.15).

14 de Septiembre de 2015
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32719 , F 174, S 8, H M 167370, I/A 73 ( 2.09.15).

03 de Febrero de 2015
Revocaciones. Apoderado: PALOMO ATANCE MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 32719 , F 174, S 8, H M 167370, I/A 71(27.01.15).

Revocaciones. Apoderado: PASCUAL IZQUIERDO LUIS. Datos registrales. T 32719 , F 174, S 8, H M 167370, I/A 72 (27.01.15).

05 de Diciembre de 2014
Revocaciones. Apoderado: TUDELA HERNANDEZ JULIO;TUDELA HERNANDEZ JULIO. Datos registrales. T 21743 , F 184, S 8,H M 167370, I/A 68 (28.11.14).

Nombramientos. Apoderado: PALOMO ATANCE MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 21743 , F 185, S 8, H M 167370, I/A 69(28.11.14).

Nombramientos. Apoderado: VIGNARD-ROSEZ FRANCK LAURENT ROLAND WILFRIED. Datos registrales. T 32719 , F 174, S 8,H M 167370, I/A 70 (28.11.14).

10 de Octubre de 2014
Nombramientos. Apoderado: PASCUAL IZQUIERDO LUIS MANUEL. Datos registrales. T 21743 , F 184, S 8, H M 167370, I/A 67 (3.10.14).

30 de Septiembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: RIBAGORDA LLORCA ANA. Datos registrales. T 21743 , F 184, S 8, H M 167370, I/A 66 (22.09.14).

08 de Agosto de 2014
Revocaciones. Apoderado: DE KORVER MARC. Nombramientos. Apoderado: VIGNARD-ROSEZ FRANCK LAURENT ROLANDWILFRIED. Datos registrales. T 21743 , F 183, S 8, H M 167370, I/A 65 ( 1.08.14).

18 de Junio de 2014
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 21743 , F 182, S 8, H M 167370, I/A 64 (10.06.14).

30 de Enero de 2014
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ NIETO ORGAZ LUIS. Datos registrales. T 21743 , F 182, S 8, H M 167370, I/A 63(22.01.14).

20 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apoderado: TUDELA HERNANDEZ JULIO. Datos registrales. T 21743 , F 182, S 8, H M 167370, I/A 62 ( 8.08.13).

05 de Julio de 2013
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 21743 , F 182, S 8, H M 167370, I/A 61 (26.06.13).

27 de Noviembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ-NIETO ORGAZ LUIS FELIPE. Nombramientos. Adm. Unico: ZEITOUN GILLESDENIS DAVID. Datos registrales. T 21743 , F 182, S 8, H M 167370, I/A 60 (15.11.12).

07 de Agosto de 2012
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 21743 , F 181, S 8, H M 167370, I/A 59 (26.07.12).

07 de Junio de 2012
Nombramientos. Apoderado: GIRALDO BURGOS ANTONIO. Datos registrales. T 21743 , F 180, S 8, H M 167370, I/A 58(29.05.12).

12 de Abril de 2012
Reelecciones. Adm. Unico: FERNANDEZ-NIETO ORGAZ LUIS FELIPE. Datos registrales. T 21743 , F 180, S 8, H M 167370, I/A57 (30.03.12).

29 de Agosto de 2011
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 21743 , F 179, S 8, H M 167370, I/A 55 (10.08.11).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ-ALEMAN RODRIGUEZ JOSE-IGNACIO. Datos registrales. T 21743 , F 180, S 8, H M167370, I/A 56 (10.08.11).

02 de Agosto de 2010
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 21743 , F 179, S 8, H M 167370, I/A 54 (22.07.10).

03 de Mayo de 2010
Nombramientos. Apoderado: DE LA ROSA VALVERDE GONZALO. Datos registrales. T 21743 , F 178, S 8, H M 167370, I/A 53(22.04.10).

06 de Noviembre de 2009
Revocaciones. Apoderado: SERVAJEAN PICHON MAITENA. Datos registrales. T 21743 , F 178, S 8, H M 167370, I/A 52(27.10.09).

03 de Agosto de 2009
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 21743 , F 178, S 8, H M 167370, I/A 51 (23.07.09).

22 de Julio de 2009
Nombramientos. Apoderado: RIBAGORDA LLORCA ANA ISABEL. Datos registrales. T 21743 , F 177, S 8, H M 167370, I/A 50(11.07.09).

30 de Abril de 2009
Revocaciones. Apoderado: RIBAGORDA LLORCA ANA. Datos registrales. T 21743 , F 176, S 8, H M 167370, I/A 48 (20.04.09).

Revocaciones. Apoderado: PEREZ GOMEZ ZAIDA ISABEL. Datos registrales. T 21743 , F 176, S 8, H M 167370, I/A 49(20.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n