Actos BORME de Cetil Dispensing Technology Sl
05 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: MOORE ADDVERIS AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 34058 , F 69, S 8, H M612740, I/A 13 (28.11.22).
26 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apoderado: CABRERA GOMEZ FRANCISCO DE ASIS;REGALES PALOMINO OSCAR;GUILLERMO MEGIAPALMA. Datos registrales. T 34058 , F 68, S 8, H M 612740, I/A 12 (19.11.20).
30 de Octubre de 2019Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS ADDVERIS AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 34058 , F 67, S8, H M 612740, I/A 11 (22.10.19).
17 de Abril de 2019Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 31 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 34058 , F67, S 8, H M 612740, I/A 10 (10.04.19).
14 de Enero de 2019Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ DEL POZO MARIA DEL PILAR. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ DEL POZOMARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 34058 , F 65, S 8, H M 612740, I/A 8 ( 3.01.19).
Revocaciones. Apoderado: REQUENA GORDO LUIS. Nombramientos. Apoderado: REQUENA GORDO LUIS. Datos registrales.T 34058 , F 66, S 8, H M 612740, I/A 9 ( 3.01.19).
13 de Enero de 2017Nombramientos. Auditor: MOORE STEPHENS ADDVERIS AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 34058 , F 64,S 8, H M 612740, I/A 7 ( 4.01.17).
17 de Agosto de 2016Cambio de domicilio social. C/ PELAYA Nº37 POLIGONO INDUSTRIAL RIO DE JANEIRO (ALGETE). Datos registrales. T 34058 ,F 64, S 8, H M 612740, I/A 6 ( 9.08.16).
03 de Junio de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: DE LA FUENTE ESPADA PABLO. Datos registrales. T 34058 , F 64, S 8, H M 612740, I/A 5 (26.05.16).
12 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ DEL POZO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 34058 , F 63, S 8, H M 612740, I/A 4 (5.05.16).
04 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: REQUENA GORDO LUIS. Datos registrales. T 34058 , F 62, S 8, H M 612740, I/A 3 (25.04.16).
23 de Febrero de 2016Nombramientos. Con.Delegado: SANCHEZ DEL POZO JOSE. Apo.Sol.: DE LA FUENTE ESPADA PABLO. Datos registrales. T34058 , F 61, S 8, H M 612740, I/A 2 (16.02.16).
01 de Febrero de 2016Constitución. Comienzo de operaciones: 21.12.15. Objeto social: La Sociedad tendrá por objeto: A. La realización de toda clase deestudios técnicos relativos a los proyectos, montaje, fabricación y suministro de:- 1. Aparatos y equipos para la industria petrolífera,tales como surtidores de cualquier rendimiento y uso. 2. Camiones cisterna para el transporte y. Domicilio: C/ PELAYA, 29 -POLIGONO INDUSTRIAL RIO DE JANEIRO (ALGETE). Capital: 126.258,00 Euros. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ DELPOZO MARIA DEL PILAR;SANCHEZ DEL POZO JOSE;DEL POZO FERNANDEZ MARIA DEL PILAR;KREMERS WINANDYCARLOS. Presidente: SANCHEZ DEL POZO JOSE. Secretario: SANCHEZ DEL POZO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T34058 , F 57, S 8, H M 612740, I/A 1 (25.01.16).