Actos BORME de Chemtrol -proyectos Y Sistemas Sl
24 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ MAILLO LAURA. Datos registrales. T 43245 , F 11, S 8, H M 318294, I/A 87(17.11.23).
06 de Junio de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: BARAJAS GONZALEZ PAZ. Datos registrales. T 43245 , F 10, S 8, H M 318294, I/A 85 (30.05.23).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ LIMON ELENA. Datos registrales. T 43245 , F 11, S 8, H M 318294, I/A 86 (30.05.23).
24 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: AZULA PALACIOS IGNACIO. Datos registrales. T 43245 , F 10, S 8, H M 318294, I/A 84 (16.03.23).
01 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: CUESTA RODRIGUEZ EVA MARIA;LOPEZ ALVAREZ MARIA BELEN. Datos registrales. T 43245 , F10, S 8, H M 318294, I/A 83 (22.07.22).
17 de Marzo de 2022Cambio de objeto social. (i) la instalaci贸n y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad y contra-incendios; (ii)la instalaci贸n y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras dealarmas o a centros de control o de video vigilancia; y (iii) l. Datos registrales. T 34018 , F 75, S 8, H M 318294, I/A 82 (10.03.22).
28 de Diciembre de 2021Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 34018 , F 75, S 8, H M 318294, I/A 81 (21.12.21).
18 de Noviembre de 2021Modificaciones estatutarias. 3.-. Datos registrales. T 34018 , F 75, S 8, H M 318294, I/A 80 (11.11.21).
04 de Noviembre de 2021Ampliacion del objeto social. LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE APARATOS, EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DESEGURIDAD CONECTADOS A CENTRALES RECEPTORAS DE ALARMAS O A CENTROS DE CONTROL O DEVIDEOVIGILANCIA; Y LA INSTALACION EN EDIFICIOS Y OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CABLES Y MATERIALELECTRICO, SISTEMAS DE TELECOMUNICACION. Datos registrales. T 34018 , F 75, S 8, H M 318294, I/A 79 (27.10.21).
28 de Junio de 2021Revocaciones. Apoderado: CANO TOROLLO IGNACIO. Datos registrales. T 34018 , F 74, S 8, H M 318294, I/A 78 (21.06.21).
20 de Abril de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: DOMINGUEZ HEREDERO GUILLERMO. Datos registrales. T 34018 , F 74, S 8, H M 318294, I/A 77(13.04.21).
18 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 34018 , F 74, S 8, H M 318294, I/A 76 (11.12.20).
14 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GALINDO GARBAY ALEJANDRO. Nombramientos. Adm. Mancom.: PIEDRA GONZALEZALBERTO. Datos registrales. T 34018 , F 74, S 8, H M 318294, I/A 75 ( 6.10.20).
07 de Agosto de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: PIEDRA GONZALEZ ALBERTO. Datos registrales. T 34018 , F 72, S 8, H M 318294, I/A 74(31.07.20).
23 de Marzo de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: BARAJAS GONZALEZ PAZ. Datos registrales. T 34018 , F 71, S 8, H M 318294, I/A 73 (16.03.20).
17 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 34018 , F 71, S 8, H M 318294, I/A 72 (10.01.20).
28 de Junio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ ESTEBAN IGNACIO. Datos registrales. T 34018 , F 70, S 8, H M 318294, I/A 70 (21.06.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ARRIBAS PERLINES JAVIER. Datos registrales. T 34018 , F 70, S 8, H M 318294, I/A 71 (21.06.19).
28 de Febrero de 2019Revocaciones. Apoderado: VIZCAINO MARTINEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 34018 , F 70, S 8, H M 318294, I/A 68(21.02.19).
Revocaciones. Apo.Sol.: WEICKERT MOLINA ENRIQUE;VALENTIN GARCIA CANDIDO. Apo.Man.Soli: MORGADO DE ORTUETAJOSE ALBERTO. Datos registrales. T 34018 , F 70, S 8, H M 318294, I/A 69 (21.02.19).
18 de Febrero de 2019Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 34018 , F 69, S 8, H M 318294, I/A 67 (11.02.19).
31 de Diciembre de 2018Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS SL. Datos registrales. T 34018 , F68, S 8, H M 318294, I/A 66 (21.12.18).
29 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: SAGARDOY LLONIS JOSE MARIA. Datos registrales. T 34018 , F 67, S 8, H M 318294, I/A 65(21.11.18).
25 de Octubre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: GARRIDO PEREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 34018 , F 67, S 8, H M 318294, I/A 64 (18.10.18).
24 de Octubre de 2018Nombramientos. Apoderado: VIZCAINO MARTINEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 34018 , F 65, S 8, H M 318294, I/A 62(17.10.18).
Nombramientos. Apoderado: ARRIBAS PERLINES JAVIER. Datos registrales. T 34018 , F 66, S 8, H M 318294, I/A 63 (17.10.18).
24 de Septiembre de 2018Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 259 D 7 - TORRESPACIO (MADRID). Datos registrales. T 34018 , F65, S 8, H M 318294, I/A 61 (17.09.18).
12 de Septiembre de 2018Otros conceptos: Con fecha 30 de Agosto de 2018 ha sido insertado en la web de "CHEMTROL PROYECTOS Y SISTEMAS SL"www.chepro.com el texto 铆ntegro del Proyecto de Fusi贸n com煤n y 煤nico de la misma y de "Comercial de Materiales de Incencio SL"domiciliada en Huelva, suscrito por sus Organos de Administraci贸n con fecha 29 de Junio de 2018.- Datos registrales. T 18351 , F104, S 8, H M 318294, I/A 1-M ( 4.09.18).
24 de Agosto de 2018Revocaciones. Apoderado: GORDON GARCIA ALFONSO MARIA. Datos registrales. T 34018 , F 65, S 8, H M 318294, I/A 60(17.08.18).
23 de Agosto de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: SALVADOR PENDON JUAN. Datos registrales. T 34018 , F 65, S 8, H M 318294, I/A 59 (14.08.18).
29 de Junio de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: TOME ABELLA JAVIER MARIA;PALOMERO GONZALEZ ROBERTO. Datos registrales. T 34018 ,F 63, S 8, H M 318294, I/A 58 (22.06.18).
23 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MARIN BEDOYA MIGUEL. Nombramientos. Adm. Mancom.: GALINDO GARBAYALEJANDRO. Datos registrales. T 34018 , F 63, S 8, H M 318294, I/A 57 (14.05.18).
20 de Abril de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: GALINDO GARBAY ALEJANDRO-PEDRO. Datos registrales. T 34018 , F 61, S 8, H M 318294, I/A54 (12.04.18).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA GIL JAIME;MORA MARTIN LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 34018 , F 62, S 8, H M318294, I/A 55 (12.04.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DOMINGUEZ HEREDERO GUILLERMO. Datos registrales. T 34018 , F 62, S 8, H M 318294, I/A56 (12.04.18).
05 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 34018 , F 60, S 8, H M 318294, I/A 53 (27.12.17).
27 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL. Datos registrales. T 34018 , F 60, S 8, H M 318294, I/A 52(20.11.17).
10 de Julio de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: DE BENGOA DIAZ JULIO MARIA. Datos registrales. T 34018 , F 59, S 8, H M 318294, I/A 51 (29.06.17).
16 de Diciembre de 2016Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 34018 , F 59, S 8, H M 318294, I/A 50 ( 7.12.16).
18 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: OLMEDO RUIZ ANTONIO. Nombramientos. Adm. Mancom.: MARIN BEDOYA MIGUEL.Datos registrales. T 34018 , F 59, S 8, H M 318294, I/A 49 (11.11.16).
22 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: MARIN BEDOYA MIGUEL. Datos registrales. T 34018 , F 56, S 8, H M 318294, I/A 48 (15.04.16).
07 de Marzo de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: MARTIN FERNANDEZ JUAN LORENZO. Datos registrales. T 34018 , F 56, S 8, H M 318294, I/A 46(25.02.16).
Revocaciones. Apoderado: OLMEDO RUIZ ANTONIO. Datos registrales. T 34018 , F 56, S 8, H M 318294, I/A 47 (25.02.16).
20 de Enero de 2016Revocaciones. Apoderado: FERRANDEZ BUENO CARMELO. Datos registrales. T 34018 , F 56, S 8, H M 318294, I/A 45(12.01.16).
15 de Enero de 2016Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 34018 , F 56, S 8, H M 318294, I/A 44 ( 7.01.16).
04 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: OLMEDO RUIZ ANTONIO. Datos registrales. T 18351 , F 224, S 8, H M 318294, I/A 43 (26.11.15).
07 de Agosto de 2015Nombramientos. Apoderado: GORDON GARCIA ALFONSO MARIA. Datos registrales. T 18351 , F 224, S 8, H M 318294, I/A 42(30.07.15).
20 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: SALVADOR PENDON JUAN. Datos registrales. T 18351 , F 224, S 8, H M 318294, I/A 41(12.03.15).
25 de Febrero de 2015Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 18351 , F 223, S 8, H M 318294, I/A 40 (18.02.15).
29 de Enero de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA LINARES GARCIA LUIS;MOLINA ESTEBAN MARCELO;OLMEDO RUIZANTONIO;BERJILLOS DOBLAS ANTONIO. Presidente: BERJILLOS DOBLAS ANTONIO. Consejero: SICRE DIAZ ALBERTO.Secretario: FLORES GALLEGO ALBERTO. Vicesecret.: FERNANDEZ MARTINEZ MARIA. Nombramientos. Adm. Mancom.:OLMEDO RUIZ ANTONIO;MOLINA ESTEBAN MARCELO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 18351 , F 223, S 8, H M 318294, I/A 39 (21.01.15).
25 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: DE BENGOA DIAZ JULIO MARIA. Datos registrales. T 18351 , F 222, S 8, H M 318294, I/A 38(16.09.14).
22 de Septiembre de 2014Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ ELEJAGA JOSE ANTONIO;VALENTIN GARCIA CANDIDO;ALFONSO CARLSSONPATRICIO;GUTIERREZ GOMEZ MARTA;PASTOR MATADOR MANUEL;GARCIA GIL JAIME;MORA MARTIN LUIS MIGUEL;AZULAPALACIOS IGNACIO;RAMOS FERNANDEZ JOSE;WEICKERT MOLINA ENRIQUE. Datos registrales. T 18351 , F 222, S 8, H M318294, I/A 37 (12.09.14).
16 de Julio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: SAN CRISTOBAL TIERRA GONZALO. Presidente: SAN CRISTOBAL TIERRA GONZALO.Nombramientos. Presidente: BERJILLOS DOBLAS ANTONIO. Consejero: SICRE DIAZ ALBERTO. Datos registrales. T 18351 , F222, S 8, H M 318294, I/A 36 ( 9.07.14).
26 de Marzo de 2014Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 12. Datos registrales. T 18351 , F 221, S 8, H M 318294, I/A 35(19.03.14).
25 de Marzo de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: WEICKERT MOLINA ENRIQUE;VALENTIN GARCIA CANDIDO. Apo.Man.Soli: CARLSSON PATRICIOALFONSO;GUTIERREZ GOMEZ MARTA;PASTOR MATADOR MANUEL;GARCIA GIL JAIME;MORA MARTIN LUIS MIGUEL;AZULAPALACIOS IGNACIO;MORGADO DE ORTUETA JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 18351 , F 220, S 8, H M 318294, I/A 34(14.03.14).
05 de Marzo de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 448.460,00 Euros. Resultante Suscrito: 629.960,00 Euros. Datos registrales. T 18351 , F 220, S 8,H M 318294, I/A 33 (24.02.14).
30 de Diciembre de 2013Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 18351 , F 219, S 8, H M 318294, I/A 32 (20.12.13).
15 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Secretario: DEL CUVILLO PEMAN JOSE MARIA. VsecrNoConsj: FLORES GALLEGO ALBERTO.Nombramientos. Secretario: FLORES GALLEGO ALBERTO. Vicesecret.: FERNANDEZ MARTINEZ MARIA. Datos registrales. T18351 , F 219, S 8, H M 318294, I/A 31 ( 7.10.13).
26 de Febrero de 2013Nombramientos. Apoderado: DELGADO ROBAYNA DAVID. Datos registrales. T 18351 , F 218, S 8, H M 318294, I/A 29(18.02.13).
Nombramientos. Apoderado: AGUILAR PARRA JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 18351 , F 218, S 8, H M 318294, I/A 30(18.02.13).
12 de Diciembre de 2012Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: MKH PROMATEC SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 18351 , F 213, S 8,H M 318294, I/A 28 ( 3.12.12).
06 de Agosto de 2012Nombramientos. Apoderado: PALOMINO CANTARELLAS JOSE FELIX. Datos registrales. T 18351 , F 212, S 8, H M 318294, I/A26 (26.07.12).
Nombramientos. Apoderado: CASTRO ALVAREZ JOAQUIN. Datos registrales. T 18351 , F 213, S 8, H M 318294, I/A 27(26.07.12).
27 de Julio de 2012Otros conceptos: DEPOSITO DEL PROYECTO DE FUSION DE ESTA COMPA脩IA , SIENDO LA SOCIEDAD QUE EN SU DIASERA LA ABSORBIDA , LA DOMICILIADA EN CASTELLON , DENOMINADA " MKH PROMATEC SA ".- Datos registrales. T 18351 ,
04 de Mayo de 2012Otros conceptos: APROBACION DE LA RENUMERACION DE LOS ARTICULOS ESTATUTARIOSY EL TEXTO REFUNDIDO DELOS MISMOS DE CONFORMIDAD CON EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010 DE 2 DE JULIO, LEY DE SOCIEDADES DECAPITAL.- Datos registrales. T 18351 , F 209, S 8, H M 318294, I/A 25 (20.04.12).
10 de Agosto de 2011Nombramientos. Apoderado: BERNAL GUIJARRRO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 18351 , F 208, S 8, H M 318294,I/A 23 (28.07.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: TRULLEN GINES JOSE ANTONIO. Apo.Manc.: OLMEDO RUIZ ANTONIO. Datos registrales. T18351 , F 208, S 8, H M 318294, I/A 24 (28.07.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CARRELLAN JIMENEZ FRANCISCO. Apo.Manc.: OLMEDO RUIZ ANTONIO. Datos registrales. T18351 , F 208, S 8, H M 318294, I/A 22 (28.07.11).
08 de Agosto de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA COPADO ESTEBAN. Cons.Del.Man: GARCIA COPADO ESTEBAN. Datos registrales. T18351 , F 207, S 8, H M 318294, I/A 21 (27.07.11).
20 de Mayo de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN FERNANDEZ JUAN LORENZO;GARRIDO PEREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 18351, F 207, S 8, H M 318294, I/A 20 (10.05.11).
31 de Enero de 2011Nombramientos. Apoderado: FERRANDEZ BUENO CARMELO;GOMEZ ROJO EMILIO;CANO TOROLLO IGNACIO. Datosregistrales. T 18351 , F 206, S 8, H M 318294, I/A 19 (19.01.11).
24 de Enero de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 18351 , F 206, S 8, H M 318294, I/A 18 (12.01.11).
22 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apoderado: WEICKERT MOLINA ENRIQUE. Datos registrales. T 18351 , F 205, S 8, H M 318294, I/A 17(10.11.10).
07 de Octubre de 2010Cambio de domicilio social. C/ ARTURO SORIA 343 (MADRID). Datos registrales. T 18351 , F 205, S 8, H M 318294, I/A 16(28.09.10).
13 de Agosto de 2010Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: OHL INDUSTRIAL SL. Datos registrales. T 18351 , F 205, S 8, H M 318294, I/A 15( 3.08.10).
23 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: PASCUAL NARVAEZ MATIAS FRANCISCO. Cons.Del.Sol: PASCUAL NARVAEZ MATIASFRANCISCO. Datos registrales. T 18351 , F 205, S 8, H M 318294, I/A 14 (13.07.10).
26 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ ELEJAGA JOSE ANTONIO;VALENTIN GARCIA CANDIDO;ALAVA RUBIO JOSELUIS;ALFONSO CARLSSON PATRICIO;ASENJO DEL OJO CARLOS;MORA MARTIN LUIS MIGUEL;AZULA PALACIOSIGNACIO;FERNANDEZ JOSE RAMOS;GARCIA GIL JAIME. Datos registrales. T 18351 , F 110, S 8, H M 318294, I/A 12 (16.11.09).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ELEJAGA JOSE ANTONIO;VALENTIN GARCIA CANDIDO;ALFONSO CARLSSONPATRICIO;GUTIERREZ GOMEZ MARTA;PASTOR MATADOR MANUEL;GARCIA GIL JAIME;MORA MARTIN LUIS MIGUEL;AZULA
27 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: OLMEDO RUIZ ANTONIO. Datos registrales. T 18351 , F 109, S 8, H M 318294, I/A 10 (16.02.09).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ELEJAGA JOSE ANTONIO;VALENTIN GARCIA CANDIDO;ALAVA RUBIO JOSELUIS;ALFONSO CARLSSON PATRICIO;ASENJO DEL OJO CARLOS;MORA MARTIN LUIS MIGUEL;AZULA PALACIOSIGNACIO;FERNANDEZ JOSE RAMOS;GARCIA GIL JAIME. Datos registrales. T 18351 , F 110, S 8, H M 318294, I/A 11 (16.02.09).