Buscador CIF Logo

Actos BORME Chevron Spain Holdings 1 Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Chevron Spain Holdings 1 Sl

Actos BORME Chevron Spain Holdings 1 Sl - B84711811

Tenemos registrados 13 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Chevron Spain Holdings 1 Sl con CIF B84711811

馃敊 Perfil de Chevron Spain Holdings 1 Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Chevron Spain Holdings 1 Sl

17 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: WRIGHT STEWART W. Nombramientos. Liquidador: WRIGHT STEWART W. Disoluci贸n.Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 22852 , F 218, S 8, H M 409132, I/A 15 (10.01.20).

12 de Diciembre de 2019
Nombramientos. Apoderado: DE LA TORRE GARCIA VICTOR JOSE;SAINZ DE LOS TERREROS ELIZALDE IGNACIO;CONDEGOMEZ GUILLERMO;RIJO RAMIREZ ANGEL. Datos registrales. T 22852 , F 217, S 8, H M 409132, I/A 13 ( 3.12.19).

Nombramientos. Apoderado: SERVICIOS GENERALES DE GESTION SL. Datos registrales. T 22852 , F 217, S 8, H M 409132, I/A14 ( 3.12.19).

07 de Agosto de 2019
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 22852 , F 217, S 8, H M 409132, I/A 12 (31.07.19).

18 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apoderado: SERVICIOS GENERALES DE GESTION SL;SERVICIOS GENERALES DE GESTION SL;DE LA TORREGARCIA VICTOR JOSE;SAINZ DE LOS TERREROS ELIZALDE IGNACIO;CONDE GOMEZ GUILLERMO;SANTIAGO PEREZJENIFER. Nombramientos. Apoderado: SERVICIOS GENERALES DE GESTION SL. Datos registrales. T 22852 , F 216, S 8, H M409132, I/A 11 (11.02.19).

16 de Agosto de 2016
Nombramientos. Apoderado: DE LA TORRE GARCIA VICTOR JOSE;SAINZ DE LOS TERREROS ELIZALDE IGNACIO;CONDEGOMEZ GUILLERMO;SANTIAGO PEREZ JENIFER. Datos registrales. T 22852 , F 215, S 8, H M 409132, I/A 9 ( 5.08.16).

Cambio de domicilio social. C/ COVARRUBIAS, NUMERO 3, BAJO D (MADRID). Datos registrales. T 22852 , F 216, S 8, H M409132, I/A 10 ( 5.08.16).

16 de Junio de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CARDENES SANTANA PEDRO. Nombramientos. Adm. Unico: WRIGHT STEWART W. Datosregistrales. T 22852 , F 215, S 8, H M 409132, I/A 8 ( 9.06.16).

27 de Noviembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: SERVICIOS GENERALES DE GESTION SL. Datos registrales. T 22852 , F 212, S 8, H M 409132, I/A7 (19.11.13).

27 de Abril de 2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CARDENES SANTANA PEDRO JULIAN;VILLANUEVA GIRON CARLOS LUIS. Nombramientos.Adm. Unico: CARDENES SANTANA PEDRO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradoressolidarios a Administrador 煤nico. Cambio de domicilio social. C/ CAMINO CERRO DE LOS GAMOS 1 - EDIFICIO 1 (POZUELO DEALARCON). Datos registrales. T 22852 , F 212, S 8, H M 409132, I/A 6 (17.04.12).

20 de Marzo de 2012
Nombramientos. Apoderado: SERVICIOS GENERALES DE GESTION SL. Datos registrales. T 22852 , F 211, S 8, H M 409132, I/A5 ( 7.03.12).

23 de Febrero de 2011
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CHEVRON GLOBAL ENERGY INC. Datos registrales. T 22852 , F210, S 8, H M 409132, I/A 4 (11.02.11).

22 de Febrero de 2011
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.003.006,00 Euros. Datos registrales. T 22852 , F 210, S8, H M 409132, I/A 3 (10.02.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n