Actos BORME de Chimento Iberica Sl
11 de Octubre de 2019Revocaciones. ADM.UNICO: MARIO CHIMENTO. LIQUIDADOR: MARIO CHIMENTO. Nombramientos. LIQUIDADOR: MARIOCHIMENTO. Extinci贸n. Datos registrales. T 43688 , F 201, S 8, H B 12991, I/A 27 ( 3.10.19).
08 de Mayo de 2019Nombramientos. APODERAD.SOL: BOREN TERAN MARIA;CABOT SETO FRANCESC. Datos registrales. T 43688 , F 201, S 8, HB 12991, I/A 26 (26.04.19).
21 de Mayo de 2018Revocaciones. ADM.UNICO: PAUL CHRISTOPHE LUCIEN SEEFELD. Nombramientos. ADM.UNICO: MARIO CHIMENTO. Datosregistrales. T 43688 , F 201, S 8, H B 12991, I/A 25 ( 8.05.18).
23 de Mayo de 2013Nombramientos. APODERADO: DE ROJAS PEREZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 43688 , F 201, S 8, H B 12991, I/A 24(15.05.13).
20 de Mayo de 2013Revocaciones. ADMINISTR.: PASCAL MARIE DOMINIQUE BRUGGER. Nombramientos. ADM.UNICO: PAUL CHRISTOPHELUCIEN SEEFELD. Cambio de domicilio social. CL DIPUTACION Num.260 (BARCELONA). Datos registrales. T 31374 , F 205, S8, H B 12991, I/A 23 ( 9.05.13).
17 de Enero de 2011Nombramientos. APODERADO: ROF CORTS JUAN. Datos registrales. T 31374 , F 205, S 8, H B 12991, I/A 22 ( 4.01.11).
28 de Diciembre de 2010Cambio de domicilio social. CL ARAGON Num.271 P.5 (BARCELONA). Datos registrales. T 31374 , F 205, S 8, H B 12991, I/A 21(17.12.10).
12 de Marzo de 2010Cambio de domicilio social. VIA LAYETANA Num.59 P.3 PTA.2 (BARCELONA). Datos registrales. T 31374 , F 204, S 8, H B12991, I/A 20 ( 3.03.10).
04 de Mayo de 2009Revocaciones. APODERADO: NEREO MICONI. Datos registrales. T 31374 , F 204, S 8, H B 12991, I/A 19 (20.04.09).