Buscador CIF Logo

Actos BORME Cie Mecauto SA

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cie Mecauto SA

Actos BORME Cie Mecauto SA - A48285399

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Alava para Cie Mecauto SA con CIF A48285399

🔙 Perfil de Cie Mecauto SA
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Alava

Actos BORME de Cie Mecauto SA

19 de Enero de 2023
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1751 , F 189, S 8, H VI 3262, I/A 73(27.12.22).

30 de Agosto de 2022
Reelecciones. Consejero: CIE BERRIZ SL. Presidente: CIE BERRIZ SL. Consejero: HERRERA BARANDIARAN JESUSMARIA;ARENAZA ALVAREZ ANDER. Representan: PRADERA JAUREGUI ANTONIO MARIA. Datos registrales. T 1499 , F 183, S8, H VI 3262, I/A 72 ( 8.08.22).

23 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1499 , F 183, S 8, H VI 3262, I/A 70( 8.11.21).

03 de Marzo de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DEL RIO LOZARES ELISABET;GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE VICUÑA RICARDO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARQUES ARANDUY FRANCISCO DE BORJA. Datos registrales. T 1499 , F 182, S 8, H VI 3262,I/A 69 (15.02.21).

03 de Febrero de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1499 , F 182, S 8, H VI 3262, I/A 68(21.01.21).

27 de Abril de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: VAZQUEZ IRIZAR ZENON. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RABANAL NUÑEZ MIKEL;AVELINOMORALES ESTHER;URIARTE MESANZA BEATRIZ. Datos registrales. T 1499 , F 181, S 8, H VI 3262, I/A 67 (20.04.20).

03 de Octubre de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1499 , F 181, S 8, H VI 3262, I/A 66(20.09.19).

04 de Diciembre de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1499 , F 181, S 8, H VI 3262, I/A 65(22.11.18).

02 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: IPIÑA OLMOS JUAN CARLOS;PRADERA JAUREGUI ANTONIO MARIA;ECHANIZ SUINAGA JUANLUIS;RICO SANCHEZ RAFAEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ECHANIZ SUINAGA JUAN LUIS;RICO SANCHEZRAFAEL;ARISTIZABAL ABASOLO LOREA;ESMORIS ESMORIS JOSE MANUEL;LOIZAGA URBISTONDO IÑIGO;PARDOVILLANUEVA IRATXE;GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE VICUÑA RICARDO. Datos registrales. T 1499 , F 180, S 8, H VI 3262,I/A 64 (23.10.18).

21 de Julio de 2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1499 , F 179, S 8, H VI 3262, I/A 61(10.07.17).

29 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: CIE BERRIZ SL;HERRERA BARANDIARAN JESUS MARIA. Presidente: CIE BERRIZ SL. Consejero:ARENAZA ALVAREZ ANDER. Nombramientos. Representan: PRADERA JAUREGUI ANTONIO MARIA. Consejero: CIE BERRIZSL. Presidente: CIE BERRIZ SL. Consejero: HERRERA BARANDIARAN JESUS MARIA;ARENAZA ALVAREZ ANDER. Datosregistrales. T 1499 , F 178, S 8, H VI 3262, I/A 60 (21.06.17).

24 de Julio de 2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1499 , F 176, S 8, H VI 3262, I/A 53(10.07.13).

08 de Octubre de 2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1499 , F 175, S 8, H VI 3262, I/A 52(18.09.12).

22 de Marzo de 2012
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: CIE BERRIZ SL. Datos registrales. T 1499 , F 174, S 8, H VI 3262,I/A 50 (27.02.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información