Buscador CIF Logo

Actos BORME Cin Valentine Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cin Valentine Sa

Actos BORME Cin Valentine Sa - A61356713

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Cin Valentine Sa con CIF A61356713

馃敊 Perfil de Cin Valentine Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Cin Valentine Sa

11 de Mayo de 2023
Revocaciones. SECR.NO CONS: GIRBAU PEDRAGOSA RAMON. V-SEC NO CON: ESBRI UCAR ANDREA. Datos registrales. T47461 , F 131, S 8, H B 160105, I/A 83 ( 3.05.23).

15 de Marzo de 2022
Revocaciones. APOD.MANCOMU: NATERCIA ALICE GUIMARAES MARINHO MOREIRA DE VASCON. Datos registrales. T47461 , F 131, S 8, H B 160105, I/A 82 ( 7.03.22).

08 de Julio de 2021
Cancelaciones de oficio de nombramientos. CONSEJERO: BASTE LOPEZ DE SAGREDO LUIS. Datos registrales. T 44576 , F11, S 8, H B 160105, I/A 61 N (28.06.21).

27 de Octubre de 2020
Nombramientos. AUDIT.INDIV.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 46027 , F 120, S 8, H B 160105, I/A 80 (15.10.20).

26 de Octubre de 2020
Nombramientos. V-SEC NO CON: ESBRI UCAR ANDREA. Datos registrales. T 46027 , F 120, S 8, H B 160105, I/A 81 (15.10.20).

20 de Agosto de 2020
Nombramientos. CONSEJERO: JOAO MANUEL FIALHO MARTINS SERRENHO;FERNANDO JORGE DE ALMEIDA FERREIRA.Datos registrales. T 46027 , F 120, S 8, H B 160105, I/A 79 (12.08.20).

29 de Octubre de 2019
Nombramientos. AUDIT.INDIV.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 46027 , F 120, S 8, H B 160105, I/A 78 (18.10.19).

22 de Agosto de 2019
Nombramientos. CONSEJERO: ANGELO BARBEDO CESAR MACHADO. Datos registrales. T 46027 , F 119, S 8, H B 160105, I/A77 (12.08.19).

24 de Julio de 2019
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: BALCELLS SANAHUJA SERGIO. Datos registrales. T 46027 , F 114, S 8, H B 160105, I/A 74(16.07.19).

Nombramientos. APODERAD.SOL: LEON MARIN NURIA. Datos registrales. T 46027 , F 119, S 8, H B 160105, I/A 75 (16.07.19).

Revocaciones. APODERADO: PEREZ CARRASCO ANTONIO. Datos registrales. T 46027 , F 119, S 8, H B 160105, I/A 76(16.07.19).

28 de Mayo de 2019
Nombramientos. AUDIT.INDIV.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 46027 , F 114, S 8, H B 160105, I/A 73 (21.05.19).

25 de Febrero de 2019
Revocaciones. APOD.MANCOMU: FERRER FIGUERAS FRANCISCO. Datos registrales. T 46027 , F 114, S 8, H B 160105, I/A 72(14.02.19).

15 de Noviembre de 2017
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 46027 , F 114, S 8, H B 160105, I/A 71 ( 7.11.17).

02 de Agosto de 2017
Revocaciones. APODERADO: JOAO MANUEL FIALHO MARTINS SERRENHO;ANGELO BARBEDO CESARMACHADO;FERNANDO JORGE DE ALMEIDA FERREIRA;FERRER FIGUERAS FRANCISCO;BRINGUE SALA ANTONIO MARIA.APOD.MANCOMU: LLARENA ASCANIO BEATRIZ;NATERCIA ALICE GUIMARAES MARINHO MOREIRA DE VASCON. Datosregistrales. T 44576 , F 20, S 8, H B 160105, I/A 69 (25.07.17).

Nombramientos. APOD.SOL/MAN: JOAO MANUEL FIALHO MARTINS SERRENHO. APOD.MANCOMU: ANGELO BARBEDOCESAR MACHADO;FERNANDO JORGE DE ALMEIDA FERREIRA;FERRER FIGUERAS FRANCISCO;HENRIQUE JOSE ALVESMARTINS FRANCO;BRINGUE SALA ANTONIO MARIA;LLARENA ASCANIO BEATRIZ;NATERCIA ALICE GUIMARAES MARINHOMOREIRA DE VASCON. Datos registrales. T 44576 , F 20, S 8, H B 160105, I/A 70 (25.07.17).

07 de Junio de 2017
Revocaciones. APODERADO: MARCOS RUIZ DELFIN. Datos registrales. T 44576 , F 20, S 8, H B 160105, I/A 68 (29.05.17).

16 de Noviembre de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44576 , F 20, S 8, H B 160105, I/A 67 ( 7.11.16).

30 de Septiembre de 2016
Nombramientos. APOD.MANCOMU: NATERCIA ALICE GUIMARAES MARINHO MOREIRA DE VASCON. Datos registrales. T44576 , F 17, S 8, H B 160105, I/A 66 (22.09.16).

10 de Junio de 2016
Nombramientos. APOD.MANCOMU: LLARENA ASCANIO BEATRIZ. Datos registrales. T 44576 , F 14, S 8, H B 160105, I/A 64 (2.06.16).

Revocaciones. APOD.MANCOMU: LUIS ALBERTO SILVA FERNANDES. Datos registrales. T 44576 , F 17, S 8, H B 160105, I/A65 ( 2.06.16).

13 de Abril de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 9.940.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.000,00 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 9.940.000,00 Euros. Desembolsado: 9.940.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.000.000,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 10.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 44576 , F 13, S 8, H B 160105, I/A 63 ( 6.04.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n