Buscador CIF Logo

Actos BORME Cintra Infraestructuras España Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cintra Infraestructuras España Sl

Actos BORME Cintra Infraestructuras España Sl - B87102240

Tenemos registrados 9 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Cintra Infraestructuras España Sl con CIF B87102240

🔙 Perfil de Cintra Infraestructuras España Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Cintra Infraestructuras España Sl

16 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: ALVAREZ IGLESIAS CARLOS. Apo.Man.Soli: LOSADA HERNANDEZ PEDRO AGUSTIN;RIVAS ZURDOJOSE MARIA;DE LARA MENCIA ALVARO. Nombramientos. Apoderado: OLIVARES BARREIRO JUAN CARLOS. Datosregistrales. T 40547 , F 39, S 8, H M 588638, I/A 44 ( 9.12.21).

03 de Noviembre de 2021
Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: CINTRA AUTOPISTAS INTEGRADAS SA. Datos registrales. T 40547 , F 36, S 8, HM 588638, I/A 43 (26.10.21).

01 de Septiembre de 2021
Declaración de unipersonalidad. Socio único: FERROVIAL SA. Datos registrales. T 40547 , F 36, S 8, H M 588638, I/A 42(25.08.21).

08 de Junio de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: RUBIO DE CARDENAS NICOLAS;SACRISTAN MARTIN ANDRES;TELLEZ REBOLLO JOSE LUIS.Apo.Manc.: RUBIO DE CARDENAS NICOLAS. Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ GOMEZ RICARDO;GONZALEZ LALUEZAALBERTO. Apo.Manc.: SANCHEZ GOMEZ RICARDO;GONZALEZ LALUEZA ALBERTO;UGARTE CRUZ-COKE CARLOS;RAMIREZBELAUSTEGUI CARLOS;LOSADA HERNANDEZ PEDRO AGUSTIN;SAGAZ QUESADA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T40547 , F 31, S 8, H M 588638, I/A 41 ( 1.06.21).

17 de Febrero de 2021
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 40547 , F 31, S 8, H M 588638, I/A 40 (10.02.21).

28 de Enero de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ VALVERDE MONTSERRAT;GONZALEZ VALVERDE MONTSERRAT. Apo.Manc.: GONZALEZVALVERDE MONTSERRAT;GONZALEZ VALVERDE MONTSERRAT. Apo.Sol.: DE GONZALO MARTINEZ RODRIGO. Apo.Manc.:GONZALEZ VALVERDE MONTSERRAT. Apoderado: LOSADA HERNANDEZ PEDRO AGUSTIN;VERAMENDI BALEJANDRO;PASCUAL OLIVA LUIS ALBERTO;LOPEZ BERZAL LAURA;MORENO ESTEBAN MONICA;CHOITHRAMANI BECERRAPABLO;TEJADA BIURRUN JORGE;GIMENEZ GARCIA-COURTOY MARIA. Apo.Man.Soli: SANCHEZ GUIJO FRANCISCO-JAVIER.Apo.Manc.: LOSADA HERNANDEZ PEDRO AGUSTIN;LOPEZ BERZAL LAURA;MORENO ESTEBAN MONICA;PASCUAL OLIVALUIS ALBERTO;TEJADA BIURRUN JORGE;GIMENEZ GARCIA-COURTOY MARIA. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ BERZALLAURA;MARTINEZ PARDO ARSUAGA FRANCISCO JAVIER;MORENO ESTEBAN MONICA;PASCUAL OLIVA LUISALBERTO;TEJADA BIURRUN JORGE;GIMENEZ GARCIA-COURTOY MARIA;VERAMENDI B ALEJANDRO;SANCHEZ GUIJOFRANCISCO-JAVIER. Datos registrales. T 40547 , F 29, S 8, H M 588638, I/A 39 (21.01.21).

05 de Junio de 2020
Nombramientos. Apo.Manc.: RUBIO DE CARDENAS NICOLAS MARIA;RAMIREZ BELAUSTEGUI CARLOS. Apo.Man.Soli: LOSADAHERNANDEZ PEDRO AGUSTIN. Apo.Manc.: SAGAZ QUESADA MIGUEL ANGEL;UGARTE CRUZ-COKE CARLOS. Datosregistrales. T 34382 , F 27, S 8, H M 588638, I/A 35 (29.05.20).

03 de Abril de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CLEMENTE SANCHEZ FRANCISCO. Nombramientos. Adm. Mancom.: LOSADAHERNANDEZ PEDRO AGUSTIN. Datos registrales. T 34382 , F 25, S 8, H M 588638, I/A 32 (27.03.20).

16 de Enero de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: SAGAZ QUESADA MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: GONZALEZ GARCIA IVAN;UGARTE CRUZ-KOKECARLOS;RAMIREZ BELAUSTEGUI CARLOS. Datos registrales. T 34382 , F 21, S 8, H M 588638, I/A 31 ( 9.01.20).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información