Actos BORME de Ciriaco Sl
18 de Enero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: MORENO GOMEZ AMPARO;IZQUIERDO GOMEZ JOSE ALBERTO;CHICHARRO GARCIAFRANCISCO. Secretario: CHICHARRO GARCIA FRANCISCO. Presidente: MORENO GOMEZ AMPARO. Nombramientos. Adm.Mancom.: IZQUIERDO GOMEZ JOSE ALBERTO;CHICHARRO GARCIA FRANCISCO. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 28769 , F 34, S 8, H M 59196, I/A14 (11.01.21).
22 de Febrero de 2019Cambio de domicilio social. AVDA MENENDEZ PELAYO NUMERO 81, 1潞 A (MADRID). Datos registrales. T 28769 , F 33, S 8, HM 59196, I/A 12 (15.02.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CHICHARRO GARCIA FRANCISCO;IZQUIERDO GOMEZ JOSE ALBERTO. Datos registrales. T28769 , F 33, S 8, H M 59196, I/A 13 (15.02.19).
03 de Abril de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: CHICHARRO GARCIA GODOFREDO. Secretario: MORENO GOMEZ AMPARO. Presidente:CHICHARRO GARCIA GODOFREDO. Con.Delegado: CHICHARRO GARCIA GODOFREDO. Nombramientos. Consejero:CHICHARRO GARCIA FRANCISCO. Secretario: CHICHARRO GARCIA FRANCISCO. Presidente: MORENO GOMEZ AMPARO.Datos registrales. T 28769 , F 32, S 8, H M 59196, I/A 10 (24.03.17).
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 450.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 962.703,00 Euros. Datos registrales. T 28769 , F32, S 8, H M 59196, I/A 11 (24.03.17).
20 de Abril de 2016Nombramientos. Apo.Manc.: MORENO GOMEZ AMPARO;CHICHARRO GARCIA GODOFREDO;IZQUIERDO GOMEZ JOSEALBERTO;CHICHARRO GARCIA FRANCISCO. Datos registrales. T 28769 , F 31, S 8, H M 59196, I/A 9 (11.04.16).
25 de Septiembre de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 173.970,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.412.703,00 Euros. Datos registrales. T 28769 ,F 31, S 8, H M 59196, I/A 8 (18.09.13).
23 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: IZQUIERDO GARCIA JACINTO. Secretario: IZQUIERDO GARCIA JACINTO. Nombramientos.Secretario: MORENO GOMEZ AMPARO. Consejero: IZQUIERDO GOMEZ JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 28769 , F 30, S 8,H M 59196, I/A 7 (16.08.13).
13 de Enero de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 90.050,61 Euros. Resultante Suscrito: 1.586.673,00 Euros. Datos registrales. T 28769 , F30, S 8, H M 59196, I/A 6 ( 2.01.12).
28 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: IZQUIERDO GARCIA MARIA JUANA. Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.646.673,00 Euros.Resultante Suscrito: 1.676.723,61 Euros. Datos registrales. T 3507 , F 13, S 8, H M 59196, I/A 5 (15.04.11).
23 de Abril de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CHICHARRO GARCIA ANGEL. Nombramientos. Consejero: CHICHARRO GARCIAGODOFREDO;IZQUIERDO GARCIA JACINTO;MORENO GOMEZ AMPARO;IZQUIERDO GARCIA MARIA JUANA. Presidente:CHICHARRO GARCIA GODOFREDO. Secretario: IZQUIERDO GARCIA JACINTO. Con.Delegado: CHICHARRO GARCIAGODOFREDO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 3507 , F 12, S 8, H M 59196, I/A 4 (14.04.09).