Buscador CIF Logo

Actos BORME Cirmad Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cirmad Sa

Actos BORME Cirmad Sa - A63653075

Tenemos registrados 25 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Cirmad Sa con CIF A63653075

🔙 Perfil de Cirmad Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Cirmad Sa

28 de Septiembre de 2021
Revocaciones. CONSEJERO: SANS CASTELLS JOAN. PRESIDENTE: SANS CASTELLS JOAN. CONSEJERO: CARDETECAMPOS EMILIANO;MONTES BERNEDO MARIA ELENA. CONS. DELEG.: SANS CASTELLS JOAN. Nombramientos.CONSEJERO: PELLISA REVUELTA FERNANDO. PRESIDENTE: PELLISA REVUELTA FERNANDO. CONS.DEL.SOL: PELLISAREVUELTA FERNANDO. CONSEJERO: TALLON GUDE MANUEL;MONTES BERNEDO MARIA ELENA. Datos registrales. T 41487, F 28, S 8, H B 294794, I/A 26 (20.09.21).

17 de Junio de 2021
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: TALLON GUDE MANUEL ANTONIO. Datos registrales. T 41487 , F 26, S 8, H B 294794, I/A 25( 9.06.21).

08 de Enero de 2019
Revocaciones. APODERADO: VIVES CARPA ALICIA. DTOR.GENERAL: VIVES CARPA ALICIA. Datos registrales. T 41487 , F 26,S 8, H B 294794, I/A 24 (20.12.18).

31 de Diciembre de 2018
Revocaciones. APODERADO: MARIN PEREZ MARTA. Datos registrales. T 41487 , F 26, S 8, H B 294794, I/A 23 (20.12.18).

12 de Septiembre de 2018
Nombramientos. CONS. DELEG.: SANS CASTELLS JOAN. Datos registrales. T 41487 , F 26, S 8, H B 294794, I/A 22 ( 5.09.18).

16 de Agosto de 2018
Nombramientos. SECR.NO CONS: ADELL SANCHEZ JORGE. Datos registrales. T 41487 , F 26, S 8, H B 294794, I/A 21 (7.08.18).

27 de Abril de 2018
Revocaciones. SECR.NO CONS: BALCELLS CABANAS JOSEP MARIA. Datos registrales. T 41487 , F 26, S 8, H B 294794, I/A 20(20.04.18).

15 de Febrero de 2018
Revocaciones. CONS. DELEG.: SANS CASTELLS JOAN. Nombramientos. CONSEJERO: SANS CASTELLS JOAN;CARDETECAMPOS EMILIANO;MONTES BERNEDO MARIA ELENA. Otros conceptos: EL CONTENIDO DE LA INS.18 MODIFICA ELHECHO REFLEJADO POR LAS NOTAS DE FECHA 17/07/17 AL MARGEN DE LAS INS.8 Y 14,FOLIOS 21 Y 24,TOMO 41487,ENCUANTO A LA CADUDICAD DE LOS SRS.SANS CASTELLS,MONTES BERNEDO Y CARDETE CAMPOS COMO CONSEJEROS.Datos registrales. T 41487 , F 25, S 8, H B 294794, I/A 18 ( 8.02.18).

Revocaciones. V-SEC NO CON: MARTI SOPENA SARA. Datos registrales. T 41487 , F 25, S 8, H B 294794, I/A 19 ( 8.02.18).

27 de Julio de 2017
Cancelaciones de oficio de nombramientos. CONSEJERO: SANS CASTELLS JOAN;MONTES BERNEDO MARIA ELENA. CONS.DELEG.: SANS CASTELLS JOAN. Datos registrales. T 41487 , F 21, S 8, H B 294794, I/A 8 N (17.07.17).

Cancelaciones de oficio de nombramientos. CONSEJERO: CARDETE CAMPOS EMILIANO. Datos registrales. T 41487 , F 24, S8, H B 294794, I/A 14 N (17.07.17).

16 de Noviembre de 2016
Revocaciones. SECR.NO CONS: VAZQUEZ DE SOLA Y GALINDO FRANCISCO A. CONSEJERO: VIVES CARPA ALICIA.Nombramientos. SECR.NO CONS: BALCELLS CABANAS JOSEP MARIA. V-SEC NO CON: MARTI SOPENA SARA. Datosregistrales. T 41487 , F 25, S 8, H B 294794, I/A 17 ( 8.11.16).

11 de Diciembre de 2015
Revocaciones. APODERADO: ROJANO SANCHEZ FERNANDO. Datos registrales. T 41487 , F 25, S 8, H B 294794, I/A 16(30.11.15).

29 de Julio de 2015
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: FARRES QUERALT MANUEL. Datos registrales. T 41487 , F 24, S 8, H B 294794, I/A 15(21.07.15).

02 de Julio de 2015
Revocaciones. CONSEJERO: AGNES NICOLE DERVOGNE. Nombramientos. CONSEJERO: CARDETE CAMPOS EMILIANO.Datos registrales. T 41487 , F 24, S 8, H B 294794, I/A 14 (25.06.15).

28 de Enero de 2013
Revocaciones. CONSEJERO: BERGES FOX MARCEL. Nombramientos. CONSEJERO: AGNES NICOLE DERVOGNE. Datosregistrales. T 41487 , F 23, S 8, H B 294794, I/A 13 (17.01.13).

18 de Enero de 2013
Revocaciones. APODERADO: MARCEL BERGES FOX;ROJANO SANCHEZ FERNANDO;YLLA MONFORTE MARTA. Datosregistrales. T 41487 , F 22, S 8, H B 294794, I/A 10 ( 9.01.13).

Nombramientos. APODERADO: MONTES BERNEDO ELENA. Datos registrales. T 41487 , F 22, S 8, H B 294794, I/A 11 (9.01.13).

Nombramientos. APODERADO: ROJANO SANCHEZ FERNANDO. Datos registrales. T 41487 , F 23, S 8, H B 294794, I/A 12 (9.01.13).

18 de Octubre de 2012
Nombramientos. CONS. DELEG.: SANS CASTELLS JOAN. Otros conceptos: EL CONTENIDO DE LA INS.9 MODIFICA ELHECHO REFLEJADO POR LANOTA EXTENDIDA EL 6/09/2012,AL MARGEN DE LA INS.8,FOLIO 22,TOMO 41487, EN CUANTO ALA CANCELACION DEL CARGO DE CONSEJERO DELEGADO DE D.JOAN SANS CASTELLS. Datos registrales. T 41487 , F 22, S8, H B 294794, I/A 9 ( 5.10.12).

18 de Septiembre de 2012
Revocaciones. CONS. DELEG.: SANS CASTELLS JOAN. Nombramientos. CONSEJERO: SANS CASTELLS JOAN;BERGES FOXMARCEL;VIVES CARPA ALICIA;MONTES BERNEDO MARIA ELENA. Datos registrales. T 41487 , F 21, S 8, H B 294794, I/A 8 (6.09.12).

31 de Enero de 2011
Revocaciones. DTOR.GENERAL: BERTOLIN SERRA JOAQUIN. Datos registrales. T 41487 , F 21, S 8, H B 294794, I/A 6(20.01.11).

Revocaciones. DTOR.GEN.ADJ: VIVES CARPA ALICIA. Nombramientos. DTOR.GENERAL: VIVES CARPA ALICIA. Datosregistrales. T 41487 , F 21, S 8, H B 294794, I/A 7 (20.01.11).

14 de Enero de 2011
Revocaciones. CONSEJERO: BERTOLIN SERRA JOAQUIN. Nombramientos. CONSEJERO: MONTES BERNEDO MARIAELENA. Datos registrales. T 41487 , F 21, S 8, H B 294794, I/A 5 ( 3.01.11).

12 de Noviembre de 2009
Revocaciones. CONSEJERO: PIERRE ROGER TROCHU. PRESIDENTE: PIERRE ROGER TROCHU. APODERADO: PIERREROGER TROCHU. VICEPRESIDEN: SANS CASTELLS JOAN. APODERADO: SANS CASTELLS JOAN. Nombramientos.PRESIDENTE: SANS CASTELLS JOAN. CONS. DELEG.: SANS CASTELLS JOAN. Datos registrales. T 38358 , F 105, S 8, H B294794, I/A 4 (29.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información