Actos BORME de Ciudad De Las Artes Y De Las Ciencias Sa
27 de Diciembre de 2023Ceses/Dimisiones. Dir. General: TORRES SALVADOR ANTONIO. Consejero: GRISOLIA GARCIA SANTIAGO;COLOMERSANCHEZ FRANCESC;AMORAGA TOLEDO CARMEN;SAMPIO MORALES EMILI JOSEP;BALLESTER FAUS CARLESVICENT;GARCIA MU脩OZ MARIA TERESA;LOPEZ RAMON VERONICA;GONZALEZ SERISOLA DANIEL;COSCOLLA GRAU EVAMARIA;BERNABE GARCIA ANTONIO;ESCRIBANO BOTET MARIA FERNANDA;CLIMENT ESPI JUAN VICENTE;CUETOLOMINCHAR JOSE LUIS. Presidente: COLOMER SANCHEZ FRANCESC. Miem.Com.Ej.: COLOMER SANCHEZ FRANCESC.Pres.Com.Ej.: COLOMER SANCHEZ FRANCESC. Secretario: SAMPIO MORALES EMILI JOSEP. Miem.Com.Ej.: SAMPIO MORALESEMILI JOSEP. Sec.Com.Ej.: SAMPIO MORALES EMILI JOSEP. Vicesecret.: GONZALEZ SERISOLA DANIEL. Miem.Com.Ej.:GONZALEZ SERISOLA DANIEL. Vicsec C.E: GONZALEZ SERISOLA DANIEL. Revocaciones. Apo.D.Gral.: TORRES SALVADORANTONIO. Nombramientos. Dir. General: ORTELLS MIRALLES ANA MARIA. Apo.D.Gral.: ORTELLS MIRALLES ANA MARIA.Apo.Manc.: MOCHOLI MARTIN JORGE;VALLES MONTAGUD ELENA. Consejero: LUMBRERAS PELAEZ SANTIAGO. Secretario:VA脩O GIRONES JOAQUIN. Presidente: LUMBRERAS PELAEZ SANTIAGO. Consejero: LLOBET VILARRASA PAULA;CUESTAVALERA MARIA SALOME;TEBAR MARTINEZ PILAR;ARLANDIS LOPEZ SERGIO;TARREGA CERVERA JOSE SALVADOR;MASTABERNER ALIDA CONSUELO;GRACIA CALANDIN CARLOS PABLO;VIVES ARLANDIS MARIA EUGENIA;VA脩O GIRONESJOAQUIN. Vicesecret.: VIVES ARLANDIS MARIA EUGENIA. Miem.Com.Ej.: LUMBRERAS PELAEZ SANTIAGO;VA脩O GIRONESJOAQUIN;TEBAR MARTINEZ PILAR;LLOBET VILARRASA PAULA. Pres.Com.Ej.: LUMBRERAS PELAEZ SANTIAGO. Sec.Com.Ej.:VA脩O GIRONES JOAQUIN. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 170, S 8, H V 11548, I/A 114 (19.12.23).
26 de Julio de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: VESES DONET CRISTIAN. Nombramientos. Consejero: BALLESTER FAUS CARLES VICENT.Datos registrales. T 6721, L 4025, F 170, S 8, H V 11548, I/A 113 (19.07.23).
27 de Diciembre de 2022Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 8.312.000,00 Euros. Desembolsado: 8.312.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 378.088.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 378.088.000,00 Euros. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 169, S 8, H V 11548, I/A 112(19.12.22).
17 de Octubre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: TAMARIT IRANZO RAQUEL. Nombramientos. Consejero: COSCOLLA GRAU EVAMARIA;ESCRIBANO BOTET MARIA FERNANDA. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 169, S 8, H V 11548, I/A 111 ( 7.10.22).
14 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. Dir. General: VIDAL PEREZ ENRIQUE. Revocaciones. Apo.D.Gral.: VIDAL PEREZ ENRIQUE. Apoderado:VIDAL PEREZ ENRIQUE. Nombramientos. Dir. General: TORRES SALVADOR ANTONIO. Apo.D.Gral.: TORRES SALVADORANTONIO. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 167, S 8, H V 11548, I/A 110 ( 7.03.22).
01 de Marzo de 2022Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 14.904.000,00 Euros. Desembolsado: 14.904.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 369.776.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 369.776.000,00 Euros. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 167, S 8, H V 11548, I/A 108(22.02.22).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MORENO FERNANDEZ CRISTINA. Vicesecret.: MORENO FERNANDEZ CRISTINA. Miem.Com.Ej.:MORENO FERNANDEZ CRISTINA. Vicsec C.E: MORENO FERNANDEZ CRISTINA. Nombramientos. Consejero: GONZALEZSERISOLA DANIEL;GRISOLIA GARCIA SANTIAGO. Vicesecret.: GONZALEZ SERISOLA DANIEL. Miem.Com.Ej.: GONZALEZSERISOLA DANIEL. Vicsec C.E: GONZALEZ SERISOLA DANIEL. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 167, S 8, H V 11548, I/A 109(22.02.22).
12 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: ESTRELLA LOPEZ OLIVIA CRISTINA;ARI脩O VILLARROYA ANTONIO. Nombramientos.Consejero: LOPEZ RAMON VERONICA;CLIMENT ESPI JUAN VICENTE. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 167, S 8, H V 11548,I/A 107 ( 5.07.21).
01 de Junio de 2021Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 13.556.000,00 Euros. Desembolsado: 13.556.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 354.872.000,00
22 de Febrero de 2021Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Reelecciones. Consejero: COLOMER SANCHEZ FRANCESC;SAMPIOMORALES EMILI JOSEP;AMORAGA TOLEDO CARMEN;ARI脩O VILLARROYA ANTONIO;BERNABE GARCIA ANTONIO. Presidente:COLOMER SANCHEZ FRANCESC. Secretario: SAMPIO MORALES EMILI JOSEP. Miem.Com.Ej.: COLOMER SANCHEZFRANCESC;SAMPIO MORALES EMILI JOSEP. Pres.Com.Ej.: COLOMER SANCHEZ FRANCESC. Sec.Com.Ej.: SAMPIO MORALESEMILI JOSEP. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 166, S 8, H V 11548, I/A 105 (15.02.21).
03 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: TOLOSA LEGAL CRISTINA;TORNER ORELLANA FRANCISCO;GIL ALFONSO ASCENSION;ATIENZAFERNANDEZ MIRIAM;BARONA LEJARRAGA INES;VALLES MONTEAGUD ELENA;PORRAS PONS MARIA-AMPARO;MATALLORCA MANUEL. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 166, S 8, H V 11548, I/A 104 (26.10.20).
29 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: GIRONA ALBUIXECH ALBERT;ALVAREZ MOLINA FRANCISCO;OCHOA MONZOJOSEP;CASTELLO GARCIA ISABEL. Vicesecret.: CASTELLO GARCIA ISABEL. Miem.Com.Ej.: CASTELLO GARCIA ISABEL.Nombramientos. Consejero: GARCIA MU脩OZ MARIA TERESA;TAMARIT IRANZO RAQUEL;MORENO FERNANDEZCRISTINA;VESES DONET CRISTIAN. Vicesecret.: MORENO FERNANDEZ CRISTINA. Miem.Com.Ej.: MORENO FERNANDEZCRISTINA. Vicsec C.E: MORENO FERNANDEZ CRISTINA. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 165, S 8, H V 11548, I/A 103(22.10.20).
22 de Julio de 2020Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 3.076.000,00 Euros. Desembolsado: 3.076.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 341.316.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 341.316.000,00 Euros. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 165, S 8, H V 11548, I/A 102(15.07.20).
11 de Marzo de 2020Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Otros conceptos: LA PERSONA FISICA REPRESENTANTE DE LAMERCANTIL "AUREN AUDITORES SP, SLP" ENTIDAD AUDITORA DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA ES DONRAFAEL LLUNA VILLAR. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 165, S 8, H V 11548, I/A 101 ( 4.03.20).
21 de Noviembre de 2019Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 19.020.000,00 Euros. Desembolsado: 19.020.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 338.240.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 338.240.000,00 Euros. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 127, S 8, H V 11548, I/A 100(14.11.19).
30 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: POYATOS LEON JUAN ANGEL. Vicesecret.: POYATOS LEON JUAN ANGEL. Miem.Com.Ej.:POYATOS LEON JUAN ANGEL. Vicsec C.E: POYATOS LEON JUAN ANGEL. Nombramientos. Consejero: CASTELLO GARCIAISABEL. Vicesecret.: CASTELLO GARCIA ISABEL. Miem.Com.Ej.: CASTELLO GARCIA ISABEL. Vicsec C.E: CASTELLO GARCIAISABEL. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 127, S 8, H V 11548, I/A 99 (23.10.19).
27 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: DURA MELIS RAFAEL;LLANTADA SACRAMENTO JUAN ANTONIO. Nombramientos. Consejero:ESTRELLA LOPEZ OLIVIA CRISTINA;SENDRA MENGUAL LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 127, S 8, H V11548, I/A 98 (20.08.19).
31 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ BONAFE MARIA EMPAR. Vicesecret.: MARTINEZ BONAFE MARIA EMPAR.Miem.Com.Ej.: MARTINEZ BONAFE MARIA EMPAR. Vicsec C.E: MARTINEZ BONAFE MARIA EMPAR. Nombramientos.Consejero: POYATOS LEON JUAN ANGEL. Vicesecret.: POYATOS LEON JUAN ANGEL. Miem.Com.Ej.: POYATOS LEON JUANANGEL. Vicsec C.E: POYATOS LEON JUAN ANGEL. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 126, S 8, H V 11548, I/A 97 (24.08.18).
06 de Marzo de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 275.704.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 319.220.000,00 Euros. Datos registrales. T6721, L 4025, F 126, S 8, H V 11548, I/A 96 (27.02.18).
18 de Diciembre de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 19.000.000,00 Euros. Desembolsado: 19.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 613.924.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 613.924.000,00 Euros. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 125, S 8, H V 11548, I/A 94(11.12.17).
Nombramientos. Apoderado: VIDAL PEREZ ENRIQUE. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 126, S 8, H V 11548, I/A 95(11.12.17).
15 de Septiembre de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: BALLESTER PASCUAL CARMEN. Nombramientos. Apoderado: SILVA FRANCES LAURA. Datosregistrales. T 6721, L 4025, F 125, S 8, H V 11548, I/A 93 ( 8.09.17).
09 de Agosto de 2017Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 124, S 8, H V 11548, I/A 92 (
01 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: VIVANCOS RAMON MARIA VICTORIA. Nombramientos. Consejero: CUETO LOMINCHAR JOSELUIS. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 124, S 8, H V 11548, I/A 91 (25.07.17).
13 de Marzo de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 27.100.000,00 Euros. Desembolsado: 27.100.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 594.924.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 594.924.000,00 Euros. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 124, S 8, H V 11548, I/A 90 ( 6.03.17).
12 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: CUENCA GARCIA ANGELES. Vicesecret.: CUENCA GARCIA ANGELES. Miem.Com.Ej.: CUENCAGARCIA ANGELES. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ BONAFE MARIA EMPAR. Vicesecret.: MARTINEZ BONAFE MARIAEMPAR. Miem.Com.Ej.: MARTINEZ BONAFE MARIA EMPAR. Vicsec C.E: MARTINEZ BONAFE MARIA EMPAR. Reelecciones.Consejero: GRISOLIA GARCIA SANTIAGO. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 123, S 8, H V 11548, I/A 89 ( 4.01.17).
13 de Octubre de 2016Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 40.000.000,00 Euros. Desembolsado: 40.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 567.824.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 567.824.000,00 Euros. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 123, S 8, H V 11548, I/A 88 ( 5.10.16).
23 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: CATALA VERDET MARIA JOSE;FERNANDEZ MIRALLES SEBASTIAN. Vicepresid.: CATALAVERDET MARIA JOSE. Miem.Com.Ej.: CATALA VERDET MARIA JOSE. Consejero: BUCH TORRALVA MAXIMO;MARCO BLANESDANIEL. Presidente: BUCH TORRALVA MAXIMO. Secretario: MARCO BLANES DANIEL. Miem.Com.Ej.: BUCH TORRALVAMAXIMO;MARCO BLANES DANIEL. Consejero: MARTIN CALVO RAUL;GARCIA RIBOT PEDRO JAVIER. Miem.Com.Ej.: GARCIARIBOT PEDRO JAVIER. Consejero: POTENCIANO MORENO FRANCISCO JOSE;MORA MAS FRANCISCO. Miem.Com.Ej.:POTENCIANO MORENO FRANCISCO JOSE. Pres.Com.Ej.: BUCH TORRALVA MAXIMO. Sec.Com.Ej.: MARCO BLANES DANIEL.Vicpres C.E: CATALA VERDET MARIA JOSE. Revocaciones. Apo.D.Gral.: MOLINERO SAENZ HENAR. Nombramientos.Apo.D.Gral.: VIDAL PEREZ ENRIQUE. Apo.Manc.: MOCHOLI MARTIN JORGE. Dir. General: VIDAL PEREZ ENRIQUE. Consejero:COLOMER SANCHEZ FRANCESC;GIRONA ALBUIXECH ALBERT;SAMPIO MORALES EMILI JOSEP;ALVAREZ MOLINAFRANCISCO;AMORAGA TOLEDO CARMEN;CUENCA GARCIA ANGELES;OCHOA MONZO JOSEP;ARI脩O VILLARROYAANTONIO;VIVANCOS RAMON MARIA VICTORIA;DURA MELIS RAFAEL;BERNABE GARCIA ANTONIO;LLANTADA SACRAMENTOJUAN ANTONIO. Presidente: COLOMER SANCHEZ FRANCESC. Secretario: SAMPIO MORALES EMILI JOSEP. Vicesecret.:CUENCA GARCIA ANGELES. Miem.Com.Ej.: COLOMER SANCHEZ FRANCESC;SAMPIO MORALES EMILI JOSEP;CUENCAGARCIA ANGELES. Pres.Com.Ej.: COLOMER SANCHEZ FRANCESC. Sec.Com.Ej.: SAMPIO MORALES EMILI JOSEP. Otrosconceptos: Conforme al art铆culo 10 de los estatutos se fija en TRECE el n煤mero de miembros del Consejo de Administraci贸n. Datosregistrales. T 6721, L 4025, F 122, S 8, H V 11548, I/A 87 (16.10.15).
10 de Julio de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: DEL OLMO HOYOS MARTA. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 122, S 8, H V 11548, I/A 86 (3.07.15).
19 de Junio de 2015Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 57.956.000,00 Euros. Desembolsado: 57.956.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 527.824.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 527.824.000,00 Euros. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 121, S 8, H V 11548, I/A 85(12.06.15).
20 de Noviembre de 2014Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 48.016.000,00 Euros. Desembolsado: 48.016.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 469.868.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 469.868.000,00 Euros. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 121, S 8, H V 11548, I/A 84(13.11.14).
17 de Noviembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MONZO MARTINEZ EUSEBIO;JIMENEZ MARTINEZ VIRGINIA. Miem.Com.Ej.: MONZO MARTINEZEUSEBIO;JIMENEZ MARTINEZ VIRGINIA. Nombramientos. Consejero: GARCIA RIBOT PEDRO JAVIER. Miem.Com.Ej.: GARCIARIBOT PEDRO JAVIER. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 120, S 8, H V 11548, I/A 82 (10.11.14).
Nombramientos. Consejero: POTENCIANO MORENO FRANCISCO JOSE. Miem.Com.Ej.: POTENCIANO MORENO FRANCISCOJOSE. Datos registrales. T 6721, L 4025, F 121, S 8, H V 11548, I/A 83 (10.11.14).
14 de Julio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: BROSETA DUPRE BRUNO. Miem.Com.Ej.: BROSETA DUPRE BRUNO. Datos registrales. T 6721,L 4025, F 120, S 8, H V 11548, I/A 81 ( 7.07.14).
28 de Marzo de 2014Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES VLC SL AUREN AUDITORES ALC SL AURE. Datos registrales. T 6721, L 4025, F120, S 8, H V 11548, I/A 80 (20.03.14).
19 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: JULIA IGUAL JUAN FRANCISCO;SANCHEZ PELLEJERO RAFAEL GABRIEL. Nombramientos.Consejero: MORA MAS FRANCISCO;MARTIN CALVO RAUL. Datos registrales. T 6720, L 4024, F 104, S 8, H V 11548, I/A 79(12.02.14).
27 de Septiembre de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 32.000.000,00 Euros. Desembolsado: 32.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 903.304.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 903.304.000,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 481.452.000,00 Euros.Resultante Suscrito: 421.852.000,00 Euros. Datos registrales. T 6720, L 4024, F 104, S 8, H V 11548, I/A 78 (20.09.13).
07 de Agosto de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: DEL OLMO HOYOS MARTA. Apo.Sol.: DEL OLMO HOYOS MARTA. Nombramientos. Apoderado:PORRAS PONS MARIA-AMPARO. Datos registrales. T 6720, L 4024, F 104, S 8, H V 11548, I/A 77 (31.07.13).
04 de Julio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: LOBON MARTIN LUIS. Miem.Com.Ej.: LOBON MARTIN LUIS. Consejero: JOHNSON SASTRELOLA;VENTURA GARCIA IGNACIO;CARBONELL PERIS RAFAEL;RIPOLL NAVARRO RAFAEL. Presidente: JOHNSON SASTRELOLA. Pres.Com.Ej.: JOHNSON SASTRE LOLA. Miem.Com.Ej.: JOHNSON SASTRE LOLA. Secretario: VENTURA GARCIAIGNACIO. Miem.Com.Ej.: VENTURA GARCIA IGNACIO. Sec.Com.Ej.: VENTURA GARCIA IGNACIO. Revocaciones. Apo.Sol.:EDESA FERNANDEZ MARCO ANTONIO. Nombramientos. Consejero: BUCH TORRALVA MAXIMO;MARCO BLANESDANIEL;SANCHEZ PELLEJERO RAFAEL GABRIEL;JIMENEZ MARTINEZ VIRGINIA. Presidente: BUCH TORRALVA MAXIMO.Secretario: MARCO BLANES DANIEL. Miem.Com.Ej.: BUCH TORRALVA MAXIMO;MARCO BLANES DANIEL;JIMENEZ MARTINEZVIRGINIA. Pres.Com.Ej.: BUCH TORRALVA MAXIMO. Sec.Com.Ej.: MARCO BLANES DANIEL. Ampliacion del objeto social.
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 26.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 6720, L 4024, F 103, S 8, H V11548, I/A 76 (27.06.13).
24 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Sec.Com.Ej.: MONZO MARTINEZ EUSEBIO. Datos registrales. T 6720, L 4024, F 101, S 8, H V 11548, I/A 73(25.02.13).
06 de Marzo de 2013Reelecciones. Auditor: UTE AUREN AUDITORES MEDITERRANEO SL Y AUREN AUDITO. Datos registrales. T 6720, L 4024, F102, S 8, H V 11548, I/A 74 (27.02.13).
04 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: CISCAR BOLUFER JOSE;ESCRIG NAVARRO JOSE MIGUEL;HERNANDEZ MI脩ANA MARIAAUXILIADORA;MORATO SESE CRISTINA. Vicepresid.: CISCAR BOLUFER JOSE. Miem.Com.Ej.: CISCAR BOLUFER JOSE. VicpresC.E: CISCAR BOLUFER JOSE. Miem.Com.Ej.: ESCRIG NAVARRO JOSE MIGUEL. Secretario: MONZO MARTINEZ EUSEBIO.Nombramientos. Consejero: CATALA VERDET MARIA JOSE;CARBONELL PERIS RAFAEL;VENTURA GARCIAIGNACIO;FERNANDEZ MIRALLES SEBASTIAN. Secretario: VENTURA GARCIA IGNACIO. Vicepresid.: CATALA VERDET MARIAJOSE. Miem.Com.Ej.: CATALA VERDET MARIA JOSE;VENTURA GARCIA IGNACIO. Vicpres C.E: CATALA VERDET MARIA JOSE.Sec.Com.Ej.: VENTURA GARCIA IGNACIO. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 73.648.000,00 Euros. Desembolsado: 47.648.000,00Euros. Resultante Suscrito: 871.304.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 845.304.000,00 Euros. Datos registrales. T 6720, L4024, F 101, S 8, H V 11548, I/A 73 (25.02.13).
11 de Junio de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: DEL OLMO HOYOS MARTA;EDESA FERNANDEZ MARCO ANTONIO. Ampliacion del objeto social.Venta de entradas tanto para productos,espect谩culos y eventos organizados por terceros que tengan lugar en sus instalaciones, comoproductos,espect谩culos o eventos desarrollados por terceros y que tengan lugar fuera de las instalaciones de CACSA. La prestaci贸nde servicios de telemarketing ... Datos registrales. T 6720, L 4024, F 101, S 8, H V 11548, I/A 72 (31.05.12).
17 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: GRISOLIA GARCIA SANTIAGO;JULIA IGUAL JUAN FRANCISCO;MIRO MIRA TRINIDADMARIA;PALAU TARREGA VICTORIA;MIRO PASCUAL RAFAEL;CAMPS DEVESA GERARDO;LOBON MARTIN LUIS. Presidente:CAMPS DEVESA GERARDO. Miem.Com.Ej.: CAMPS DEVESA GERARDO;LOBON MARTIN LUIS. Consejero: MORATO SESECRISTINA. Miem.Com.Ej.: MORATO SESE CRISTINA;GARCIA RIBOT PEDRO. Secretario: GARCIA RIBOT PEDRO. Consejero:GOMEZ OCA脩A CONCEPCION;VELA BARGUES JOSE MANUEL;GARCIA RIBOT PEDRO. Vicepresid.: FONT DE MORA TURONALEJANDRO. Miem.Com.Ej.: VELA BARGUES JOSE MANUEL;FONT DE MORA TURON ALEJANDRO. Consejero: FONT DE MORATURON ALEJANDRO. Pres.Com.Ej.: CAMPS DEVESA GERARDO. Vicpres C.E: FONT DE MORA TURON ALEJANDRO.Sec.Com.Ej.: GARCIA RIBOT PEDRO. Dir. General: GARCIA RIBOT PEDRO. Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA RIBOT PEDRO.Nombramientos. Consejero: JOHNSON SASTRE LOLA;CISCAR BOLUFER JOSE;BROSETA DUPRE BRUNO;LOBON MARTINLUIS;MORATO SESE CRISTINA;ESCRIG NAVARRO JOSE MIGUEL;HERNANDEZ MI脩ANA MARIA AUXILIADORA;GRISOLIAGARCIA SANTIAGO;JULIA IGUAL JUAN FRANCISCO;RIPOLL NAVARRO RAFAEL;MONZO MARTINEZ EUSEBIO. Presidente:JOHNSON SASTRE LOLA. Miem.Com.Ej.: ESCRIG NAVARRO JOSE MIGUEL. Pres.Com.Ej.: JOHNSON SASTRE LOLA.Vicepresid.: CISCAR BOLUFER JOSE. Secretario: MONZO MARTINEZ EUSEBIO. Miem.Com.Ej.: JOHNSON SASTRE LOLA;CISCARBOLUFER JOSE;MONZO MARTINEZ EUSEBIO;LOBON MARTIN LUIS;BROSETA DUPRE BRUNO. Vicpres C.E: CISCAR BOLUFERJOSE. Sec.Com.Ej.: MONZO MARTINEZ EUSEBIO. Apo.D.Gral.: MOLINERO SAENZ HENAR. Apo.Manc.: DEL OLMO HOYOSMARTA;MOCHOLI MARTIN JORGE. Apoderado: LOBON MARTIN LUIS. Datos registrales. T 6720, L 4024, F 100, S 8, H V 11548,I/A 71 ( 5.10.11).
14 de Abril de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 73.648.000,00 Euros. Desembolsado: 73.648.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 797.656.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 797.656.000,00 Euros. Datos registrales. T 6720, L 4024, F 100, S 8, H V 11548, I/A 70 ( 5.04.11).
22 de Julio de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: MALLENT A脩ON MARIA ANGELES;MALLENT A脩ON MARIA ANGELES. Nombramientos. Apo.Manc.:
21 de Mayo de 2010Revocaciones. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Aud.C.Con.: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Nombramientos.Auditor: AUREN AUDITORES MEDITERRANEO SL Y AUREN AUDITORES. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES MEDITERRANEO SLY AUREN AUDITORES. Datos registrales. T 6720, L 4024, F 99, S 8, H V 11548, I/A 68 (12.05.10).
03 de Mayo de 2010Ceses/Dimisiones. Dir. General: VELA BARGUES JORGE. Consejero: FONT DE MORA TURON ALEJANDRO;VELA BARGUESJORGE;VELA BARGUES JOSE MANUEL;GOMEZ OCA脩A CONCEPCION. Vicepresid.: FONT DE MORA TURON ALEJANDRO.Miem.Com.Ej.: FONT DE MORA TURON ALEJANDRO;VELA BARGUES JOSE MANUEL. Secretario: VELA BARGUES JORGE.Miem.Com.Ej.: VELA BARGUES JORGE. Consejero: PEREZ BOADA ENRIQUE. Miem.Com.Ej.: PEREZ BOADA ENRIQUE.Consejero: VILLANUEVA GARCIA JOSE LUIS. Miem.Com.Ej.: VILLANUEVA GARCIA JOSE LUIS. Sec.Com.Ej.: VELA BARGUESJORGE. Revocaciones. Apoderado: VELA BARGUES JORGE. Nombramientos. Dir. General: GARCIA RIBOT PEDRO. Apo.Sol.:GARCIA RIBOT PEDRO. Consejero: MORATO SESE CRISTINA. Vicpres C.E: FONT DE MORA TURON ALEJANDRO.Miem.Com.Ej.: MORATO SESE CRISTINA;GARCIA RIBOT PEDRO. Secretario: GARCIA RIBOT PEDRO. Consejero: GOMEZOCA脩A CONCEPCION;VELA BARGUES JOSE MANUEL;GARCIA RIBOT PEDRO. Vicepresid.: FONT DE MORA TURONALEJANDRO. Miem.Com.Ej.: VELA BARGUES JOSE MANUEL;FONT DE MORA TURON ALEJANDRO. Consejero: FONT DE MORATURON ALEJANDRO. Apo.Manc.: GARCIA RIBOT PEDRO;MALLENT A脩ON MARIA ANGELES;MOCHOLI MARTIN JORGE.Sec.Com.Ej.: GARCIA RIBOT PEDRO. Datos registrales. T 6720, L 4024, F 98, S 8, H V 11548, I/A 67 (22.04.10).
04 de Febrero de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 72.768.000,00 Euros. Desembolsado: 72.768.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 724.008.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 724.008.000,00 Euros. Datos registrales. T 6720, L 4024, F 98, S 8, H V 11548, I/A 66 (26.01.10).
10 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPS DEVESA GERARDO. Presidente: CAMPS DEVESA GERARDO. Miem.Com.Ej.: CAMPSDEVESA GERARDO. Pres.Com.Ej.: CAMPS DEVESA GERARDO. Miem.Com.Ej.: LOBON MARTIN LUIS. Consejero: LOBONMARTIN LUIS. Nombramientos. Consejero: CAMPS DEVESA GERARDO;LOBON MARTIN LUIS. Presidente: CAMPS DEVESAGERARDO. Miem.Com.Ej.: CAMPS DEVESA GERARDO. Pres.Com.Ej.: CAMPS DEVESA GERARDO. Miem.Com.Ej.: LOBONMARTIN LUIS. Datos registrales. T 6720, L 4024, F 97, S 8, H V 11548, I/A 65 (27.02.09).
05 de Febrero de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 113.348.000,00 Euros. Desembolsado: 113.348.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 651.240.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 651.240.000,00 Euros. Datos registrales. T 6720, L 4024, F 97, S 8, H V 11548, I/A 64 (27.01.09).