Actos BORME de Ciudad Deportiva Montecanal Sl
02 de Septiembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ-URRUTIA ALFONSO ANA. Nombramientos. Consejero: LAGO VARELA JAVIER.Reelecciones. Consejero: ARTAL ALLOZA ROSA-MARIA;NAYA MORA FRANCISCO JAVIER;BESTUE SALINAS RAMON;JIMENEZGONZALEZ JOSE FELIX;NAVASCUES LAFUENTE TEODORO;MARTINEZ GIL JOSE RAMON;GRACIA BUISAN JOSE. Datosregistrales. T 3701 , F 74, S 8, H Z 30260, I/A 31 (29.08.22).
Nombramientos. Presidente: ARTAL ALLOZA ROSA-MARIA. Vicepresid.: NAYA MORA FRANCISCO JAVIER. Reelecciones.SecreNoConsj: AVELLANA DOMINGO JESUS. Datos registrales. T 3701 , F 74, S 8, H Z 30260, I/A 32 (29.08.22).
17 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: BLANCO LAFRAGUETA MARTA. Datos registrales. T 3701 , F 73, S 8, H Z 30260, I/A 30(10.07.19).
24 de Septiembre de 2018Fe de erratas: Que en el envío al BORME Nº 152, se hizo constar que la fecha de terminación del nombramiento como Presidente deDOÑA ROSA MARIA ARTAL ALLOZA es el 25-7-2018, cuando EN REALIDAD es el 25-7-2022. Datos registrales. T 3701 , F 73, S 8,H Z 30260, I/A 29 (12.09.18).
20 de Septiembre de 2018Nombramientos. Consejero: NAVASCUES LAFUENTE TEODORO;MARTINEZ GIL JOSE RAMON;GRACIA BUISAN JOSE.Reelecciones. Consejero: ARTAL ALLOZA ROSA-MARIA;NAYA MORA FRANCISCO JAVIER;BESTUE SALINAS RAMON;BLANCOLAFRAGUETA MARTA;FERNANDEZ-URRUTIA ALFONSO ANA;JIMENEZ GONZALEZ JOSE FELIX. SecreNoConsj: AVELLANADOMINGO JESUS. Presidente: ARTAL ALLOZA ROSA-MARIA. Vicepresid.: NAYA MORA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales.T 3701 , F 73, S 8, H Z 30260, I/A 29 (12.09.18).
04 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GARRIES CELDRAN SALVADOR;LOPEZ TENA JAVIER. Datos registrales. T 3701 , F 73, S 8, H Z30260, I/A 28 (25.02.16).
30 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: AISA GARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 3701 , F 73, S 8, H Z 30260, I/A 27 (23.07.15).
28 de Abril de 2015Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.cdmontecanal.com. Datos registrales. T 3701 , F 72, S 8,H Z 30260, I/A 26 (20.04.15).
09 de Enero de 2015Modificaciones estatutarias. ARTICULO 12º. CONVOCATORIA. La junta general será convocada mediante anuncio publicado en lapágina web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en las disposiciones legalesvigentes. Cuando la sociedad no hubiere acordado la creación de su página ARTICULO 20º. AFECCION DE LOS BENEFICIOS ALMANTENIMIENTO o MEJORA DE LA ACTIVIDAD Y PRESTACION DEPORTIVA. Lo sociedad carecerá de ánimo de lucro,entendiendo como tal que los resultados netos positivos obtenidos en cada uno de los ejercicios, no serán destinados a su distribución
05 de Noviembre de 2014Revocaciones. Apoderado: CABALLERO RAMOS DAVID. Datos registrales. T 3701 , F 72, S 8, H Z 30260, I/A 24 (27.10.14).
16 de Octubre de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: TEJEDOR JODRA ANA EVA;CUCALON MARTINEZ ALBERTO;VALENCIANO ARRANZMAXIMO;VICENTE BARRALLO JOSE ANTONIO;ARANDA GARCES ROBERTO;MONIENTE AZNAR JOSE IGNACIO;SUREDAAPARICIO EMILIO. Datos registrales. T 3701 , F 71, S 8, H Z 30260, I/A 22 ( 8.10.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARTAL ALLOZA ROSA-MARIA;NAYA MORA FRANCISCO JAVIER;BESTUE SALINAS RAMON.
17 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ SANCHEZ JOSE;MARTINEZ FORCES LUIS. Presidente: MARTINEZ FORCES LUIS.Nombramientos. Presidente: ARTAL ALLOZA ROSA-MARIA. Reelecciones. Vicepresid.: NAYA MORA FRANCISCO JAVIER.Datos registrales. T 3701 , F 71, S 8, H Z 30260, I/A 21 ( 9.09.14).
11 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: VALENCIANO ARRANZ MAXIMO;VICENTE BARRALLO JOSE ANTONIO;MONIENTE AZNARIGNACIO;SUREDA APARICIO EMILIO;SIERRA LAHOZ JOSE ANTONIO. Vicepresid.: VALENCIANO ARRANZ MAXIMO. Consejero:CUCALON MARTINEZ ALBERTO. Presidente: CUCALON MARTINEZ ALBERTO. Nombramientos. Consejero: ARTAL ALLOZAROSA-MARIA;NAYA MORA FRANCISCO JAVIER;LOPEZ TENA JAVIER;MARTINEZ FORCES LUIS;SANCHEZ SANCHEZJOSE;AISA GARCIA JOSE LUIS;GARRIES CELDRAN SALVADOR;BESTUE SALINAS RAMON;BLANCO LAFRAGUETAMARTA;FERNANDEZ-URRUTIA ALFONSO ANA. Presidente: MARTINEZ FORCES LUIS. Vicepresid.: NAYA MORA FRANCISCOJAVIER. Reelecciones. Consejero: JIMENEZ GONZALEZ JOSE FELIX. SecreNoConsj: AVELLANA DOMINGO JESUS. Datosregistrales. T 3701 , F 71, S 8, H Z 30260, I/A 20 ( 4.09.14).
25 de Marzo de 2014Ampliación de capital. Capital: 18.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 909.600,00 Euros. Datos registrales. T 3701 , F 70, S 8, H Z30260, I/A 19 (14.03.14).
11 de Septiembre de 2013Reelecciones. Consejero: CUCALON MARTINEZ ALBERTO;VALENCIANO ARRANZ MAXIMO;MONIENTE AZNARIGNACIO;VICENTE BARRALLO JOSE ANTONIO;SUREDA APARICIO EMILIO;SIERRA LAHOZ JOSE ANTONIO;JIMENEZGONZALEZ JOSE FELIX. Presidente: CUCALON MARTINEZ ALBERTO. Vicepresid.: VALENCIANO ARRANZ MAXIMO.SecreNoConsj: AVELLANA DOMINGO JESUS. Modificaciones estatutarias. Artículo 5º.- CAPITAL SOCIAL. El capital social es deOCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS EUROS, representado por 2.972 participaciones de TRESCIENTOS EUROScada una, numeradas del 1 al 2.972, las cuales no podrán incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones.. Otrosconceptos: Modificado el valor nominal de las participaciones sociales que pasa a ser de trescientos euros. Datos registrales. T3701 , F 70, S 8, H Z 30260, I/A 18 ( 4.09.13).
13 de Marzo de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: CASTILLO FERNANDEZ JOSE;TEJEDOR JODRA ANA EVA;SEVILLANO QUEROLENRIQUE;HERRERO CARRASCOSA MIGUEL ANGEL;BASANTA CUENCA JOSE LUIS;ARGON RODRIGUEZ ALFONSO.Nombramientos. Apo.Manc.: TEJEDOR JODRA ANA EVA;CUCALON MARTINEZ ALBERTO;VALENCIANO ARRANZMAXIMO;VICENTE BARRALLO JOSE ANTONIO;ARANDA GARCES ROBERTO;MONIENTE AZNAR JOSE IGNACIO;SUREDAAPARICIO EMILIO. Datos registrales. T 3701 , F 70, S 8, H Z 30260, I/A 17 ( 4.03.13).
14 de Septiembre de 2012Nombramientos. Consejero: SIERRA LAHOZ JOSE ANTONIO;JIMENEZ GONZALEZ JOSE FELIX. Datos registrales. T 3701 , F69, S 8, H Z 30260, I/A 16 ( 5.09.12).
12 de Agosto de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: TEJEDOR JODRA ANA EVA. Presidente: TEJEDOR JODRA ANA EVA. Vicepresid.: CUCALONMARTINEZ ALBERTO. Consejero: ARANDA GARCES ROBERTO. Nombramientos. Presidente: CUCALON MARTINEZ ALBERTO.Vicepresid.: VALENCIANO ARRANZ MAXIMO. Datos registrales. T 3701 , F 69, S 8, H Z 30260, I/A 15 ( 2.08.11).
12 de Julio de 2010Nombramientos. Apoderado: CABALLERO RAMOS DAVID. Datos registrales. T 3701 , F 69, S 8, H Z 30260, I/A 14 ( 1.07.10).
26 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: PINEDA CLAVAGUERA FELIPE;SEVILLANO QUEROL ENRIQUE;CASTILLO FERNANDEZ JOSE.Presidente: CASTILLO FERNANDEZ JOSE. Consejero: TEJEDOR JODRA ANA EVA;MAÑAS GASCON JAVIER;ARGONRODRIGUEZ ALFONSO;HERRERO CARRASCOSA MIGUEL ANGEL;MONIENTE AZNAR JOSE IGNACIO;GARCIA GARCIARAFAEL ALONSO;RIOJA RIOJA JESUS;BASANTA CUENCA JOSE LUIS;REVUELTA HERNANDEZ CARLOS. Secretario: TEJEDORJODRA ANA EVA. Nombramientos. SecreNoConsj: AVELLANA DOMINGO JESUS. Consejero: TEJEDOR JODRA ANA EVA.Presidente: TEJEDOR JODRA ANA EVA. Consejero: CUCALON MARTINEZ ALBERTO. Vicepresid.: CUCALON MARTINEZALBERTO. Consejero: VALENCIANO ARRANZ MAXIMO;VICENTE BARRALLO JOSE ANTONIO;ARANDA GARCESROBERTO;SUREDA APARICIO EMILIO;MONIENTE AZNAR IGNACIO. Datos registrales. T 3701 , F 69, S 8, H Z 30260, I/A 13(17.11.09).
15 de Abril de 2009Ampliación de capital. Capital: 424.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 891.600,00 Euros. Datos registrales. T 3141 , F 75, S 8, H Z30260, I/A 12 ( 1.04.09).