Actos BORME de Civesa Ingenieria Sa
04 de Agosto de 2015Otros conceptos: EXtendida con fecha 27/07/15 nota de cierre provisional a que se refiere el Articulo 231 del R.R.M. por haber sidoabsorbida la Sociedad, por la domiciliada en Madrid,denominada "ALDESA CONSTRUCIONES SA".- Datos registrales. T 5623 , F177, S 8, H SE 91233, I/A 8 B (27.07.15).
05 de Mayo de 2015Declaración de unipersonalidad. Socio único: ALDESA CONSTRUCCIONES SA. Datos registrales. T 5623 , F 177, S 8, H SE91233, I/A 8 (23.04.15).
11 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MARTINEZ DE SIMON SANTOS GUILLERMO. Nombramientos. SecreNoConsj: FERNANDEZRUIZ ISABEL. Datos registrales. T 5623 , F 176, S 8, H SE 91233, I/A 8 ( 2.04.13).
08 de Marzo de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: DUARTE I MACARRO ESTHER. Datos registrales. T 5623 , F 176, S 8, H SE 91233, I/A 7 (26.02.13).
19 de Febrero de 2013Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: ARTICULO 4º: domicilio social.-. Cambio de domicilio social. C/EXPOSICION 34 - POLIGONO INDUSTRIAL PISA (MAIRENA DEL ALJARAFE). Datos registrales. T 5623 , F 175, S 8, H SE 91233,I/A 6 ( 7.02.13).
04 de Febrero de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: REY GOMEZ GUILLERMO;MARTINEZ DUQUE GUSTAVO. Datos registrales. T 5437 , F 14, S 8, H SE91233, I/A 5 (23.01.13).
28 de Agosto de 2012Nombramientos. Apoderado: PALLARES MORAÑO MARIA LUISA. Datos registrales. T 5437 , F 14, S 8, H SE 91233, I/A 4(16.08.12).
14 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FERNANDEZ RUIZ ISABEL. Nombramientos. SecreNoConsj: MARTINEZ DE SIMON SANTOSGUILLERMO. Datos registrales. T 5437 , F 13, S 8, H SE 91233, I/A 3 (28.11.11).
14 de Noviembre de 2011Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ ARQUITECTURA 5 5& -TORRE 8, MODULO 4 (SEVILLA). Datos registrales. T 5437 , F 13, S 8, H SE 91233, I/A 2 (28.10.11).
28 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: MANZANEDO GONZALEZ FELIX FERNANDO. Nombramientos. SecreNoConsj: FERNANDEZRUIZ ISABEL. Datos registrales. T 4745, L 3653, F 124, S 8, H MA 91171, I/A 17 (15.09.11).
02 de Junio de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: POU YAÑEZ JUAN MIGUEL;CONCHILLO SAEZ JOSE. Datos registrales. T 4745, L 3653, F 123, S 8, HMA 91171, I/A 16 (23.05.11).
11 de Abril de 2011Nombramientos. Apoderado: RUIZ LOPEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 4745, L 3653, F 122, S 8, H MA 91171, I/A 14(29.03.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ HERAIZ JOSE MARIA;TORRALBA VILLARROEL OLGA. Datos registrales. T 4745, L 3653,F 123, S 8, H MA 91171, I/A 15 (29.03.11).
28 de Marzo de 2011Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ-AGESTA MORENO ANTONIO LUIS. Datos registrales. T 4745, L 3653, F 122, S 8, H MA91171, I/A 13 (11.03.11).
09 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRES PAREDES MIGUEL;FERNANDEZ RUIZ ALEJANDRO. Presidente: FERNANDEZ RUIZ
07 de Abril de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ RUIZ MATILDE;FERNANDEZ RUIZ ISABEL;FERNANDEZ RUIZ MERCEDES. Datosregistrales. T 4298, L 3208, F 15, S 8, H MA 91171, I/A 11 (22.03.10).
25 de Enero de 2010Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4298, L 3208, F 15, S 8, H MA 91171, I/A 10 ( 8.01.10).
21 de Diciembre de 2009Revocaciones. Apoderado: GOMEZ NAVARRO GONZALO. Apo.Manc.: GOMEZ NAVARRO GONZALO;DOMINGUEZ SANTOSJULIO;TORRES PAREDES MIGUEL. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL;BLANC GARCIA-VALCARCEL CARLOS. Apo.Manc.: LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL;DOMIGUEZ SANTOS JULIO;TORRES PAREDESMIGUEL;BLANC GARCIA-VALCARCEL CARLOS. Datos registrales. T 4298, L 3208, F 14, S 8, H MA 91171, I/A 9 ( 4.12.09).
04 de Febrero de 2009Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 45.076,50 Euros. Ampliación de capital. Suscrito: 39.898,00 Euros.Desembolsado: 39.898,00 Euros. Resultante Suscrito: 100.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 100.000,00 Euros. Datosregistrales. T 4298, L 3208, F 14, S 8, H MA 91171, I/A 8 (15.01.09).