Actos BORME de Clinica Perpetuo Socorro De Lerida Grupo Hla Sl
02 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1482 , F 60, S 8, H L 29524, I/A 17 (23.10.23).
18 de Agosto de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABALLERO CABALLERO MARIANO;SOLVAS MARTINEZ ANTONIA. Apo.Manc.: IVORRAMIRALLES FRANCISCO;DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE;LOPEZ JERICO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T1482 , F 22, S 8, H L 29524, I/A 16 ( 8.08.23).
30 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES;ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Apo.Manc.: ALCALDEGOMEZ MARIA DOLORES. Nombramientos. Apo.Man.Soli: TORRES FERNANDEZ VALERIANO FRANCISCO. Apo.Manc.:IVORRA MIRALLES FRANCISCO;DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE;RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO;CABALLEROCABALLERO MARIANO. Apo.Sol.: LOPEZ JERICO FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: LOPEZ JERICO FRANCISCOJAVIER;TORRES FERNANDEZ VALERIANO FRANCISCO;SANUY BESCOS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 1480 , F125, S 8, H L 29524, I/A 15 (19.05.23).
16 de Marzo de 2023Nombramientos. Consejero: MATEU SERRA ANTONIO. Datos registrales. T 1480 , F 125, S 8, H L 29524, I/A 14 ( 8.03.23).
28 de Octubre de 2022Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1480 , F 125, S 8, H L 29524, I/A 13 (19.10.22).
12 de Mayo de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL. Vicepresid.: IVORRA MIRALLES FRANCISCO.Presidente: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL. Nombramientos. Presidente: IVORRA MIRALLES FRANCISCO.Vicepresid.: FERNANDEZ MARTINEZ JOSE JUAN. Datos registrales. T 1478 , F 224, S 8, H L 29524, I/A 12 ( 2.05.22).
04 de Mayo de 2022Revocaciones. Apoderado: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL. Datosregistrales. T 1478 , F 224, S 8, H L 29524, I/A 11 (25.04.22).
30 de Noviembre de 2021Otros conceptos: Refundidos los estatutos sociales. Datos registrales. T 1472 , F 213, S 8, H L 29524, I/A 10 (18.11.21).
04 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO. Apo.Manc.: CABALLERO CABALLERO MARIANO;ALCALDEGOMEZ MARIA DOLORES. Datos registrales. T 1472 , F 211, S 8, H L 29524, I/A 9 (22.04.21).
05 de Noviembre de 2019Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1472 , F 210, S 8, H L 29524, I/A 8 (23.10.19).
12 de Agosto de 2019Nombramientos. Apoderado: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;ALCALDEGOMEZ MARIA DOLORES;CABALLERO CABALLERO MARIANO;DELGADO SORIA MARIO. Otros conceptos: Revocanparcialmente dejando sin efecto 煤nicamente las facultades de tesorer铆a a los apoderados: Don Manuel Soria Fern谩ndez de C贸rdoba,don Andr茅s Rodr铆guez-Villa Matons, do帽a Mar铆a Dolores Alcalde G贸mez y don Mariano Caballero Caballero. Datos registrales. T1472 , F 208, S 8, H L 29524, I/A 7 (30.07.19).
08 de Septiembre de 2017Revocaciones. Apoderado: TIRADO GUALLART JESUS. Datos registrales. T 1472 , F 208, S 8, H L 29524, I/A 6 (31.08.17).
23 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CABALLERO CABALLERO MARIANO;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL.Nombramientos. Consejero: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;IVORRA MIRALLES FRANCISCO;DE PORRES ORTIZDE URBINA ENRIQUE;SOLVAS MARTINEZ ANTONIA;GARCIA-LEGAZ RUIZ BENITO;MEDINA BLANCO GREGORIO;FERNANDEZMARTINEZ JOSE JUAN;ITURBE PARDOS FERNANDO;PAMPOLS GIMENEZ JOSE MARIA. Presidente: SORIA FERNANDEZ DE
27 de Marzo de 2017Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1470 , F 206, S 8, H L 29524, I/A4 (20.03.17).
20 de Septiembre de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 600.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 603.000,00 Euros. Datos registrales. T 1470 , F 156, S 8, HL 29524, I/A 3 (12.09.16).
26 de Agosto de 2016Nombramientos. Apoderado: IVORRA MIRALLES FRANCISCO;DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE;ALCALDE GOMEZMARIA DOLORES;CABALLERO CABALLERO MARIANO;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;LOPEZ JERICOFRANCISCO JAVIER;FERNANDEZ MARTINEZ JOSE JUAN;SANUY BESCOS FRANCISCO JAVIER;MATEU SERRAANTONIO;RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;TIRADO GUALLART JESUS;RIVERA GONZALEZ JOSE MARTIN;SANCHEZDAFOS MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 1466 , F 93, S 8, H L 29524, I/A 2 (18.08.16).
13 de Julio de 2016Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 17.06.16. Objeto social: a) La organizaci贸n, direcci贸n, gesti贸n e intermediaci贸n para laprestaci贸n de servicios de asistencia cl铆nica general, tratamientos m茅dico-quir煤rgicos de todo tipo de enfermedades humanas,actividades socio-sanitarias, de residencias geri谩tricas, cualquier otro servicio sanitario o relacionado con l. Domicilio: C/ OBISPOMESEGUER 3 (LLEIDA). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: HLA LAVINIA SALUD SL.Nombramientos. Adm. Mancom.: CABALLERO CABALLERO MARIANO;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL. Datosregistrales. T 1466 , F 87, S 8, H L 29524, I/A 1 ( 6.07.16).