Actos BORME de Clinicas Avetmas Sa
04 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: BRIL RUZAL MELISA. Datos registrales. T 43893 , F 169, S 8, H M 699038, I/A 35 (27.11.23).
02 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA ORTIZ ANTONIO;COSTALES ARTIEDA JUAN RAMON;BRU CASTRO CONCEPCION;CELAMARTINEZ JOSE MARIA;ARRIBAS PEREZ MARIA ELENA;GARCIA SANCHEZ IGNACIO. Datos registrales. T 43893 , F 169, S 8,H M 699038, I/A 34 (25.09.23).
15 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ PEREZ ANA MARIA. Datos registrales. T 43893 , F 169, S 8, H M 699038, I/A 33 ( 8.09.23).
18 de Agosto de 2023Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ PEREZ ANA MARIA. Datos registrales. T 43893 , F 168, S 8, H M 699038, I/A 31(10.08.23).
Nombramientos. Apoderado: HOYO MU脩OZ PEDRO GREGORIO. Datos registrales. T 43893 , F 168, S 8, H M 699038, I/A 32(10.08.23).
17 de Agosto de 2023Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: CASERVET ARGANZUELA SL. C.V. SANCHINARRO SL. Datos registrales. T43893 , F 164, S 8, H M 699038, I/A 30 ( 9.08.23).
26 de Julio de 2023Nombramientos. Apoderado: COSTALES ARTIEDA JUAN RAMON;PUCHE PAJARES DANIEL;ZORITA GONZALEZCONSUELO;MARQUEZ PRADERA JORGE;ARRIBAS PEREZ ELENA;MOLINA MORALES JUAN. Datos registrales. T 43893 , F163, S 8, H M 699038, I/A 28 (19.07.23).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA SANCHEZ IGNACIO;COSTALES ARTIEDA JUAN RAMON;BRU CASTROCONCEPCION;ARRIBAS PEREZ MARIA ELENA;CELA MARTINEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 43893 , F 164, S 8, H M699038, I/A 29 (19.07.23).
08 de Junio de 2023Revocaciones. Apoderado: BERMEJO ALVARES ILDEFONDO. Apo.Sol.: BERMEJO ALBARES ILDEFONSO. Datos registrales. T43893 , F 163, S 8, H M 699038, I/A 27 ( 1.06.23).
25 de Mayo de 2023Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 5.210.000,00 Euros. Desembolsado: 5.210.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.210.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 10.210.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datosregistrales. T 43893 , F 163, S 8, H M 699038, I/A 26 (18.05.23).
14 de Abril de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ ARCINIEGA ANTONIO. Datos registrales. T 43893 , F 162, S 8, H M 699038, I/A 25 (5.04.23).
22 de Marzo de 2023Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 2.500.000,00 Euros. Cambio de objeto social. Cl铆nica de animales decompa帽铆a y ex贸ticos, comprensivos, entre otras de las siguientes actividades: Medicina interna. Oncolog铆a, Endocrinolog铆a,Dermatologia, Nutrici贸n, Cardiolog铆a, Nefrologia, Anestesiolog铆a, Reproducci贸n, Neurolog铆a. Hospitalizaci贸n. Vacunaciones... Datosregistrales. T 43893 , F 161, S 8, H M 699038, I/A 24 (14.03.23).
21 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: RAMIREZ DEL PUERTO JOSE LUIS. Datos registrales. T 43893 , F 161, S 8, H M 699038, I/A 23(13.03.23).
26 de Enero de 2023Nombramientos. Apoderado: ESTEFANIA BIEDMA ALBERTO. Datos registrales. T 43893 , F 161, S 8, H M 699038, I/A 22(19.01.23).
28 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: REVILLA CASTRO BEATRIZ;FERNANDEZ HERRERO EMILIO. Datos registrales. T 43893 , F 161, S 8,H M 699038, I/A 21 (21.11.22).
25 de Octubre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA ORTIZ ANTONIO;NADAL DE DIOS RAMON. Datos registrales. T 39368 , F 93, S 8, H M 699038,I/A 18 (18.10.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA ORTIZ ANTONIO;NIETO ALITE JOSE MANUEL. Datos registrales. T 39368 , F 93, S 8, H M699038, I/A 19 (18.10.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ CARRASCO LORETO. Datos registrales. T 39368 , F 95, S 8, H M 699038, I/A 20(18.10.22).
11 de Octubre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: NADAL DE DIOS RAMON. Nombramientos. Adm. Mancom.: NIETO ALITE JOSE MANUEL.Datos registrales. T 39368 , F 93, S 8, H M 699038, I/A 17 ( 4.10.22).
13 de Julio de 2022Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ PISON CARLOS RAMON. Datos registrales. T 39368 , F 92, S 8, H M 699038, I/A 15 (6.07.22).
Nombramientos. Apoderado: ORTIZ CAS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 39368 , F 92, S 8, H M 699038, I/A 16 (6.07.22).
07 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ HERRERO EMILIO. Datos registrales. T 39368 , F 91, S 8, H M 699038, I/A 14(30.06.22).
01 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ HERRERO EMILIO. Datos registrales. T 39368 , F 91, S 8, H M 699038, I/A 13(24.06.22).
14 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 39368 , F 91, S 8, H M 699038, I/A 12 (7.03.22).
22 de Febrero de 2022Nombramientos. Apoderado: OLANO RUIPEREZ LETICIA. Datos registrales. T 39368 , F 90, S 8, H M 699038, I/A 11 (15.02.22).
16 de Agosto de 2021Revocaciones. Apoderado: PELAEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 39368 , F 90, S 8, H M 699038, I/A 10 (9.08.21).
19 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: BERMEJO ALBARES ILDEFONSO;GONZALEZ PEREZ ANA MARIA. Datos registrales. T 39368 , F 90,S 8, H M 699038, I/A 9 (12.04.21).
23 de Junio de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA FERNANDEZ ANGEL LUIS. Datos registrales. T 39368 , F 89, S 8, H M 699038, I/A 8(16.06.20).
12 de Mayo de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ IGNACIO. Datos registrales. T 39368 , F 89, S 8, H M 699038, I/A 7 ( 4.05.20).
14 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apoderado: DIAZ CARRERA CRISTINA. Datos registrales. T 39368 , F 89, S 8, H M 699038, I/A 6 ( 7.11.19).
21 de Octubre de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: ARRIBAS PEREZ MARIA ELENA. Datos registrales. T 39368 , F 88, S 8, H M 699038, I/A 5(14.10.19).
05 de Agosto de 2019Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 7.06.19. Objeto social: La prestaci贸n como intermediaria de servicios de asistenciafacultativa, cl铆nica y hospitalaaria a todo tipo de animales. Domicilio: AVDA DE BURGOS 109 (MADRID). Capital suscrito: 5.000.000,00Euros. Desembolsado: 2.500.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CAJA DE SEGUROS REUNIDOSCOMPA脩IA DE SEGUROS Y REA. Nombramientos. Adm. Mancom.: GARCIA ORTIZ ANTONIO;NADAL DE DIOS RAMON. Datosregistrales. T 39368 , F 81, S 8, H M 699038, I/A 1 (29.07.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA ORTIZ ANTONIO;NADAL DE DIOS RAMON. Datos registrales. T 39368 , F 83, S 8, H M699038, I/A 2 (29.07.19).
Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ DEL PUERTO JOSE LUIS. Datos registrales. T 39368 , F 85, S 8, H M 699038, I/A 3(29.07.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ORTIZ CAS JAVIER;SANCHEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL. Apoderado: DIEZ BARCENILLA JOSEMANUEL;PELAEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO;GONZALEZ PISON CARLOS RAMON;REVILLA CASTRO BEATRIZ;BERMEJOALVARES ILDEFONDO;DIAZ CARRERA CRISTINA. Apo.Manc.: GARCIA ORTIZ ANTONIO;COSTALES ARTIEDA JUANRAMON;BRU CASTRO CONCEPCION;CELA MARTINEZ JOSE MARIA;GARCIA FERNANDEZ ANGEL LUIS. Datos registrales. T39368 , F 86, S 8, H M 699038, I/A 4 (29.07.19).