Buscador CIF Logo

Actos BORME Clinicas Avetmas Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Clinicas Avetmas Sa

Actos BORME Clinicas Avetmas Sa - A88400684

Tenemos registrados 35 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Clinicas Avetmas Sa con CIF A88400684

馃敊 Perfil de Clinicas Avetmas Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Clinicas Avetmas Sa

04 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BRIL RUZAL MELISA. Datos registrales. T 43893 , F 169, S 8, H M 699038, I/A 35 (27.11.23).

02 de Octubre de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA ORTIZ ANTONIO;COSTALES ARTIEDA JUAN RAMON;BRU CASTRO CONCEPCION;CELAMARTINEZ JOSE MARIA;ARRIBAS PEREZ MARIA ELENA;GARCIA SANCHEZ IGNACIO. Datos registrales. T 43893 , F 169, S 8,H M 699038, I/A 34 (25.09.23).

15 de Septiembre de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ PEREZ ANA MARIA. Datos registrales. T 43893 , F 169, S 8, H M 699038, I/A 33 ( 8.09.23).

18 de Agosto de 2023
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ PEREZ ANA MARIA. Datos registrales. T 43893 , F 168, S 8, H M 699038, I/A 31(10.08.23).

Nombramientos. Apoderado: HOYO MU脩OZ PEDRO GREGORIO. Datos registrales. T 43893 , F 168, S 8, H M 699038, I/A 32(10.08.23).

17 de Agosto de 2023
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: CASERVET ARGANZUELA SL. C.V. SANCHINARRO SL. Datos registrales. T43893 , F 164, S 8, H M 699038, I/A 30 ( 9.08.23).

26 de Julio de 2023
Nombramientos. Apoderado: COSTALES ARTIEDA JUAN RAMON;PUCHE PAJARES DANIEL;ZORITA GONZALEZCONSUELO;MARQUEZ PRADERA JORGE;ARRIBAS PEREZ ELENA;MOLINA MORALES JUAN. Datos registrales. T 43893 , F163, S 8, H M 699038, I/A 28 (19.07.23).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA SANCHEZ IGNACIO;COSTALES ARTIEDA JUAN RAMON;BRU CASTROCONCEPCION;ARRIBAS PEREZ MARIA ELENA;CELA MARTINEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 43893 , F 164, S 8, H M699038, I/A 29 (19.07.23).

08 de Junio de 2023
Revocaciones. Apoderado: BERMEJO ALVARES ILDEFONDO. Apo.Sol.: BERMEJO ALBARES ILDEFONSO. Datos registrales. T43893 , F 163, S 8, H M 699038, I/A 27 ( 1.06.23).

25 de Mayo de 2023
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 5.210.000,00 Euros. Desembolsado: 5.210.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.210.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 10.210.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datosregistrales. T 43893 , F 163, S 8, H M 699038, I/A 26 (18.05.23).

14 de Abril de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ ARCINIEGA ANTONIO. Datos registrales. T 43893 , F 162, S 8, H M 699038, I/A 25 (5.04.23).

22 de Marzo de 2023
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 2.500.000,00 Euros. Cambio de objeto social. Cl铆nica de animales decompa帽铆a y ex贸ticos, comprensivos, entre otras de las siguientes actividades: Medicina interna. Oncolog铆a, Endocrinolog铆a,Dermatologia, Nutrici贸n, Cardiolog铆a, Nefrologia, Anestesiolog铆a, Reproducci贸n, Neurolog铆a. Hospitalizaci贸n. Vacunaciones... Datosregistrales. T 43893 , F 161, S 8, H M 699038, I/A 24 (14.03.23).

21 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: RAMIREZ DEL PUERTO JOSE LUIS. Datos registrales. T 43893 , F 161, S 8, H M 699038, I/A 23(13.03.23).

26 de Enero de 2023
Nombramientos. Apoderado: ESTEFANIA BIEDMA ALBERTO. Datos registrales. T 43893 , F 161, S 8, H M 699038, I/A 22(19.01.23).

28 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: REVILLA CASTRO BEATRIZ;FERNANDEZ HERRERO EMILIO. Datos registrales. T 43893 , F 161, S 8,H M 699038, I/A 21 (21.11.22).

25 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA ORTIZ ANTONIO;NADAL DE DIOS RAMON. Datos registrales. T 39368 , F 93, S 8, H M 699038,I/A 18 (18.10.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA ORTIZ ANTONIO;NIETO ALITE JOSE MANUEL. Datos registrales. T 39368 , F 93, S 8, H M699038, I/A 19 (18.10.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ CARRASCO LORETO. Datos registrales. T 39368 , F 95, S 8, H M 699038, I/A 20(18.10.22).

11 de Octubre de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: NADAL DE DIOS RAMON. Nombramientos. Adm. Mancom.: NIETO ALITE JOSE MANUEL.Datos registrales. T 39368 , F 93, S 8, H M 699038, I/A 17 ( 4.10.22).

13 de Julio de 2022
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ PISON CARLOS RAMON. Datos registrales. T 39368 , F 92, S 8, H M 699038, I/A 15 (6.07.22).

Nombramientos. Apoderado: ORTIZ CAS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 39368 , F 92, S 8, H M 699038, I/A 16 (6.07.22).

07 de Julio de 2022
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ HERRERO EMILIO. Datos registrales. T 39368 , F 91, S 8, H M 699038, I/A 14(30.06.22).

01 de Julio de 2022
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ HERRERO EMILIO. Datos registrales. T 39368 , F 91, S 8, H M 699038, I/A 13(24.06.22).

14 de Marzo de 2022
Revocaciones. Apoderado: DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 39368 , F 91, S 8, H M 699038, I/A 12 (7.03.22).

22 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apoderado: OLANO RUIPEREZ LETICIA. Datos registrales. T 39368 , F 90, S 8, H M 699038, I/A 11 (15.02.22).

16 de Agosto de 2021
Revocaciones. Apoderado: PELAEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 39368 , F 90, S 8, H M 699038, I/A 10 (9.08.21).

19 de Abril de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: BERMEJO ALBARES ILDEFONSO;GONZALEZ PEREZ ANA MARIA. Datos registrales. T 39368 , F 90,S 8, H M 699038, I/A 9 (12.04.21).

23 de Junio de 2020
Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA FERNANDEZ ANGEL LUIS. Datos registrales. T 39368 , F 89, S 8, H M 699038, I/A 8(16.06.20).

12 de Mayo de 2020
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ IGNACIO. Datos registrales. T 39368 , F 89, S 8, H M 699038, I/A 7 ( 4.05.20).

14 de Noviembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: DIAZ CARRERA CRISTINA. Datos registrales. T 39368 , F 89, S 8, H M 699038, I/A 6 ( 7.11.19).

21 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apo.Manc.: ARRIBAS PEREZ MARIA ELENA. Datos registrales. T 39368 , F 88, S 8, H M 699038, I/A 5(14.10.19).

05 de Agosto de 2019
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 7.06.19. Objeto social: La prestaci贸n como intermediaria de servicios de asistenciafacultativa, cl铆nica y hospitalaaria a todo tipo de animales. Domicilio: AVDA DE BURGOS 109 (MADRID). Capital suscrito: 5.000.000,00Euros. Desembolsado: 2.500.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CAJA DE SEGUROS REUNIDOSCOMPA脩IA DE SEGUROS Y REA. Nombramientos. Adm. Mancom.: GARCIA ORTIZ ANTONIO;NADAL DE DIOS RAMON. Datosregistrales. T 39368 , F 81, S 8, H M 699038, I/A 1 (29.07.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA ORTIZ ANTONIO;NADAL DE DIOS RAMON. Datos registrales. T 39368 , F 83, S 8, H M699038, I/A 2 (29.07.19).

Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ DEL PUERTO JOSE LUIS. Datos registrales. T 39368 , F 85, S 8, H M 699038, I/A 3(29.07.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: ORTIZ CAS JAVIER;SANCHEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL. Apoderado: DIEZ BARCENILLA JOSEMANUEL;PELAEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO;GONZALEZ PISON CARLOS RAMON;REVILLA CASTRO BEATRIZ;BERMEJOALVARES ILDEFONDO;DIAZ CARRERA CRISTINA. Apo.Manc.: GARCIA ORTIZ ANTONIO;COSTALES ARTIEDA JUANRAMON;BRU CASTRO CONCEPCION;CELA MARTINEZ JOSE MARIA;GARCIA FERNANDEZ ANGEL LUIS. Datos registrales. T39368 , F 86, S 8, H M 699038, I/A 4 (29.07.19).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n