Actos BORME de Club De Golf Peralada Sa
07 de Noviembre de 2019Revocaciones. APODERAD.SOL: HURTADO LOPEZ FRANCISCO;CARRASCO BRUGADA JAVIER;CRUCES ANGELFRANCISCO;CARRASCO BRUGADA JAVIER;BARZANO ABAD MARIA DOLORES. ADM.UNICO: INVERAMA SA. REPR.143 RRM:SUQUE MATEU JAVIER. APODERAD.SOL: DE SOTO SALVANS ORIOL;MARIN GOZALVEZ JAVIER. Escisi贸n total. Sociedadesbeneficiarias de la escisi贸n: INMOBILIARIA CAMO SL. HOTEL PERALADA WINE SPA Y GOLF S.L. Extinci贸n. Datosregistrales. T 45064 , F 176, S 8, H B 37455, I/A 59 (29.10.19).
18 de Julio de 2019Nombramientos. APODERAD.SOL: MARIN GOZALVEZ JAVIER. Datos registrales. T 45064 , F 175, S 8, H B 37455, I/A 58(10.07.19).
05 de Diciembre de 2018Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 45064 , F 175, S 8, H B 37455, I/A 57 (27.11.18).
21 de Mayo de 2018Nombramientos. APODERAD.SOL: DE SOTO SALVANS ORIOL. Datos registrales. T 45064 , F 174, S 8, H B 37455, I/A 56(10.05.18).
07 de Mayo de 2018Otros conceptos: DECLARACION DE CAMBIO DE ACCIONISTA UNICO, SIENDO EL NUEVO ACCIONISTA UNICO: INVERAMAS.A. Datos registrales. T 45064 , F 173, S 8, H B 37455, I/A 55 (26.04.18).
23 de Abril de 2018Revocaciones. ADM.UNICO: INVERAMA SL. REPR.143 RRM: SUQUE MATEU JAVIER. Nombramientos. ADM.UNICO:INVERAMA SA. REPR.143 RRM: SUQUE MATEU JAVIER. Datos registrales. T 45064 , F 173, S 8, H B 37455, I/A 54 (16.04.18).
28 de Septiembre de 2017Nombramientos. AUDIT.INDIV.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 45064 , F 173, S 8, H B 37455, I/A 53 (21.09.17).
20 de Febrero de 2017Nombramientos. APODERAD.SOL: CARRASCO BRUGADA JAVIER;BARZANO ABAD MARIA DOLORES. Datos registrales. T45064 , F 173, S 8, H B 37455, I/A 52 (13.02.17).
10 de Noviembre de 2016Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 45064 , F 172, S 8, H B 37455, I/A 51 (28.10.16).
21 de Septiembre de 2016Revocaciones. APODERAD.SOL: PADERN CASANOVAS JOAN. Datos registrales. T 45064 , F 171, S 8, H B 37455, I/A 49(14.09.16).
Nombramientos. APODERAD.SOL: CRUCES ANGEL FRANCISCO. Datos registrales. T 45064 , F 171, S 8, H B 37455, I/A 50(14.09.16).
02 de Junio de 2016Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 15.000.000,00 Euros. Desembolsado: 15.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 17.022.400,00Euros. Resultante Desembolsado: 17.022.400,00 Euros. Datos registrales. T 45064 , F 171, S 8, H B 37455, I/A 48 (26.05.16).
23 de Diciembre de 2015Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 45064 , F 171, S 8, H B 37455, I/A 47 (16.12.15).
05 de Noviembre de 2015Nombramientos. APODERAD.SOL: CARRASCO BRUGADA JAVIER. Datos registrales. T 22463 , F 133, S 8, H B 37455, I/A 46(29.10.15).
09 de Septiembre de 2015Nombramientos. APODERAD.SOL: HURTADO LOPEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 22463 , F 131, S 8, H B 37455, I/A 44 (2.09.15).
Nombramientos. APODERAD.SOL: PADERN CASANOVAS JOAN. Datos registrales. T 22463 , F 132, S 8, H B 37455, I/A 45 (2.09.15).
21 de Agosto de 2015Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: PADERN CASANOVAS JUAN;HURTADO LOPEZ FRANCISCO. Nombramientos. ADM.UNICO:INVERAMA SL. REPR.143 RRM: SUQUE MATEU JAVIER. Datos registrales. T 22463 , F 130, S 8, H B 37455, I/A 43 (13.08.15).
26 de Diciembre de 2014Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22463 , F 130, S 8, H B 37455, I/A 42 (17.12.14).
18 de Abril de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5.574.393,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.022.400,00 Euros. Datos registrales. T 22463, F 130, S 8, H B 37455, I/A 40 (10.04.13).
Otros conceptos: DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO LA SOCIEDAD "INVERAMA, S.L.".Datos registrales. T 22463 , F 130, S 8, H B 37455, I/A 41 (10.04.13).
12 de Abril de 2013Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22463 , F 130, S 8, H B 37455, I/A 39 ( 3.04.13).
13 de Julio de 2012Revocaciones. APODERADO: VILARDELL MARGARIT JAVIER. Datos registrales. T 22463 , F 129, S 8, H B 37455, I/A 38 (3.07.12).
02 de Julio de 2012Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: HOYO CATORCE SL. Datos registrales. T 22463 , F 127, S 8, H B 37455, I/A 37(20.06.12).
24 de Abril de 2012Revocaciones. ADM.UNICO: VILARDELL MARIN JAIME. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: PADERN CASANOVASJUAN;HURTADO LOPEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 22463 , F 126, S 8, H B 37455, I/A 35 (12.04.12).
Modificaciones estatutarias. ART.15:MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.Cambio de domicilio social. CL PERE II DE MONTCADA Num.1 (BARCELONA). Datos registrales. T 22463 , F 126, S 8, H B37455, I/A 36 (12.04.12).
02 de Abril de 2012Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDIGEST SA. Datos registrales. T 22463 , F 125, S 8, H B 37455, I/A 32 (20.03.12).
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDIGEST SA. Datos registrales. T 22463 , F 125, S 8, H B 37455, I/A 33 (20.03.12).
27 de Abril de 2011Revocaciones. APODERADO: VILARDELL MARGARIT JAUME. Datos registrales. T 22463 , F 125, S 8, H B 37455, I/A 31(12.04.11).
20 de Diciembre de 2010Cambio de domicilio social. PS DE GRACIA Num.118 P.PR (BARCELONA). Datos registrales. T 22463 , F 124, S 8, H B 37455,I/A 30 ( 7.12.10).
29 de Abril de 2010Cambio de domicilio social. CL COPERNIC, NUM.69-73 P.BJ PTA.1 (BARCELONA). Datos registrales. T 22463 , F 124, S 8, H B37455, I/A 29 (19.04.10).
25 de Agosto de 2009Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDIGEST SA. Datos registrales. T 22463 , F 124, S 8, H B 37455, I/A 28 (12.08.09).