Buscador CIF Logo

Actos BORME Club Deportivo Leganes Sociedad Anonima Deportiva

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Club Deportivo Leganes Sociedad Anonima Deportiva

Actos BORME Club Deportivo Leganes Sociedad Anonima Deportiva - A28526010

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Club Deportivo Leganes Sociedad Anonima Deportiva con CIF A28526010

馃敊 Perfil de Club Deportivo Leganes Sociedad Anonima Deportiva
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Club Deportivo Leganes Sociedad Anonima Deportiva

07 de Agosto de 2023
Nombramientos. Apoderado: ILLA FERRER ALEIX;RODRIGUEZ ALVAREZ RAQUEL. Datos registrales. T 42888 , F 175, S 8, H M182807, I/A 32 (31.07.23).

24 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apoderado: MORENO ROMERO FELIPE;SANCHEZ GARCIA ANGEL;MORENO ROMERO FELIPE;SANCHEZGARCIA ANGEL. Otros conceptos: SE DEJA CONSTANCIA DE LA ACEPTACION EN SU CARGOS DE CONSEJEROS DE DONJORGE ELIAS BAHIA SIMAN, DON WINSTON LACAYO Y DON RICHARD HOJEL, QUE FUERON DESIGNADOS EN LA JUNTAGENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022. Datos registrales. T 42888 , F 174, S 8, H M 182807, I/A30 (17.05.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BAHAIA SIMAN JORGE ELIAS. Nombramientos. Consejero: PORRAS PEDRAZA JUAN. Datosregistrales. T 42888 , F 175, S 8, H M 182807, I/A 31 (17.05.23).

04 de Mayo de 2023
Reelecciones. Consejero: BAHAIA SIMAN JORGE ELIAS;LACAYO WINSTON;HOJEL RICHARD;LUHNOW JEFFREY ALDREDGE.Presidente: LUHNOW JEFFREY ALDREDGE. SecreNoConsj: GARZON VICENTE ALFREDO. Modificaciones estatutarias. SEMODIFICAN LOS ARTICULOS 16, 17, 19, 23 , 24 Y 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 42888 , F 169, S 8, HM 182807, I/A 29 (25.04.23).

21 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: COSIN DE CARVAJAL EDUARDO. Datos registrales. T 42888 , F 167, S 8, H M 182807, I/A 28(14.11.22).

21 de Septiembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: MORENO ROMERO FELIPE;PAVON PALOMO MARIA VICTORIA;SANCHEZ GARCIA ANGEL.Presidente: PAVON PALOMO MARIA VICTORIA. Vicepresid.: MORENO ROMERO FELIPE. Secretario: SANCHEZ GARCIA ANGEL.Con.Delegado: MORENO ROMERO FELIPE. Consejero: HAUSE LA FUENTE SL. Representan: PAVON PALOMO MARIAESPERANZA. Nombramientos. Consejero: BAHAIA SIMAN JORGE ELIAS. SecreNoConsj: GARZON VICENTE ALFREDO.Consejero: LACAYO WINSTON;HOJEL RICHARD;LUHNOW JEFFREY ALDREDGE. Presidente: LUHNOW JEFFREY ALDREDGE.Apo.Sol.: LUHNOW JEFFREY ALDREDGE;GARZON VICENTE ALFREDO. Apoderado: LUHNOW JEFFREY ALDREDGE. Datosregistrales. T 42888 , F 163, S 8, H M 182807, I/A 27 (14.09.22).

16 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: KANAEVA NATALIA;COSIN DE CARVAJAL EDUARDO. Datos registrales. T 42888 , F 163, S 8, H M182807, I/A 26 ( 9.09.22).

29 de Julio de 2022
Nombramientos. Apoderado: DESAI VARUN. Datos registrales. T 42888 , F 162, S 8, H M 182807, I/A 25 (21.07.22).

08 de Julio de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: LUHNOW JEFFREY ALDREDGE;SENN GONZALEZ JULIO;GARZON VICENTE ALFREDO. Datosregistrales. T 11642 , F 225, S 8, H M 182807, I/A 24 ( 1.07.22).

11 de Febrero de 2022
Reelecciones. Auditor: MGI AUDICON & PARTNERS SLP. Datos registrales. T 11642 , F 225, S 8, H M 182807, I/A 23 ( 4.02.22).

12 de Febrero de 2021
Nombramientos. Representan: PAVON PALOMO MARIA ESPERANZA. Consejero: HAUSE LA FUENTE SL. Datos registrales. T11642 , F 225, S 8, H M 182807, I/A 22 ( 5.02.21).

01 de Diciembre de 2020
Reelecciones. Consejero: MORENO ROMERO FELIPE;PAVON PALOMO MARIA VICTORIA;SANCHEZ GARCIA ANGEL;ORTIZBERNAL JUAN ANTONIO. Presidente: PAVON PALOMO MARIA VICTORIA. Vicepresid.: MORENO ROMERO FELIPE. Secretario:SANCHEZ GARCIA ANGEL. Con.Delegado: MORENO ROMERO FELIPE. Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 30de los estatutos . Retribuci贸n de los consejeros. . Datos registrales. T 11642 , F 224, S 8, H M 182807, I/A 21 (24.11.20).

03 de Abril de 2020
P谩gina web de la sociedad. Modificaci贸n de la p谩gina web corporativa.Nueva p谩gina web: http://cdleganes.com/. Datos registrales.T 11642 , F 224, S 8, H M 182807, I/A 20 (27.03.20).

09 de Septiembre de 2019
Nombramientos. Auditor: MGI AUDICON & PARTNERS SLP. Datos registrales. T 11642 , F 224, S 8, H M 182807, I/A 19 (2.09.19).

06 de Abril de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: MORENO PAVON ALBERTO;INVERMERCADOS DE VALORES SL. Representan: MARTINEZGASCUE脩A ARANCHA. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES,RELATIVO A LA COMPOSICION Y NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 11642 , F 223, S8, H M 182807, I/A 18 (29.03.17).

03 de Diciembre de 2015
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 399.999,20 Euros. Desembolsado: 399.999,20 Euros. Resultante Suscrito: 2.400.711,30 Euros.Resultante Desembolsado: 2.400.711,30 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 681.492,24 Euros. Resultante Suscrito:1.719.219,06 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 480.142,26 Euros. Resultante Suscrito: 1.239.076,80 Euros.Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 690.400,00 Euros. Desembolsado: 690.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.929.476,80 Euros.Resultante Desembolsado: 1.929.476,80 Euros. Datos registrales. T 11642 , F 222, S 8, H M 182807, I/A 17 (24.11.15).

15 de Julio de 2015
Nombramientos. Auditor: GONZALEZ ATANES ALBERTO JAVIER. Aud.Supl.: LOPEZ FERREIRO BERTA. Datos registrales. T11642 , F 222, S 8, H M 182807, I/A 16 ( 6.07.15).

08 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Representan: ORTEGA CHACON SEBASTIAN. Consejero: MORENO ROMERO FELIPE;PAVON PALOMOMARIA VICTORIA;MORENO PAVON ALBERTO;SANCHEZ GARCIA ANGEL. Secretario: SANCHEZ GARCIA ANGEL. Consejero:INVERMERCADOS DE VALORES SL;HAUSE LA FUENTE SL. Presidente: PAVON PALOMO MARIA VICTORIA. Representan:MORENO PAVON FELIPE. Miem.Com.Ej.: GONZALEZ ZURDO VICENTE. Cancelaciones de oficio de nombramientos.Consejero: GONZALEZ ZURDO VICENTE;AYUNTAMIENTO DE LEGANES. Nombramientos. Representan: MARTINEZGASCUE脩A ARANCHA. Consejero: MORENO ROMERO FELIPE;PAVON PALOMO MARIA VICTORIA;MORENO PAVONALBERTO;SANCHEZ GARCIA ANGEL;ORTIZ BERNAL JUAN ANTONIO;INVERMERCADOS DE VALORES SL;HAUSE LA FUENTESL. Presidente: PAVON PALOMO MARIA VICTORIA. Vicepresid.: MORENO ROMERO FELIPE. Secretario: SANCHEZ GARCIAANGEL. Con.Delegado: MORENO ROMERO FELIPE. Apoderado: MORENO ROMERO FELIPE;SANCHEZ GARCIA ANGEL.Modificaciones estatutarias. 15潞. Modificaci贸n del art铆culo 15潞 de los estatutos sociales.- . P谩gina web de la sociedad. Creaci贸nde la p谩gina web corporativa: http://deportivoleganes.com/. Datos registrales. T 11642 , F 220, S 8, H M 182807, I/A 15 (29.04.15).

16 de Noviembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: MOVENS RENT SL. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.750.356,10 Euros. Desembolsado:1.750.356,10 Euros. Resultante Suscrito: 2.000.712,10 Euros. Resultante Desembolsado: 2.000.712,10 Euros. Modificacionesestatutarias. 15. Funcionamiento Junta Gral.-. Datos registrales. T 11642 , F 219, S 8, H M 182807, I/A 14 ( 5.11.12).

31 de Octubre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANTA ISABEL 246 SL;FERNANDEZ GOMEZ ANGEL RUBEN. Miem.Com.Ej.: FERNANDEZGOMEZ ANGEL RUBEN. Representan: AGUILERA FERNANDEZ EDUARDO. Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ GOMEZANGEL RUBEN;VILLALBA FERNANDEZ JULIO;CONTRERAS ROMAN FERNANDO. Datos registrales. T 11642 , F 219, S 8, H M182807, I/A 13 (22.10.12).

02 de Febrero de 2010
Ceses/Dimisiones. Presidente: FERNANDEZ GOMEZ ANGEL RUBEN. Nombramientos. Representan: PAVON PALOMO MARIAESPERANZA;MORENO PAVON FELIPE; CORDERO GUERRERO SERGIO DE BORJA;AGUILERA FERNANDEZ EDUARDO.Consejero: MOVENS RENT SL;SANTA ISABEL 246 SL;INVERMERCADOS DE VALORES SL;HAUSE LA FUENTE SL. Presidente:PAVON PALOMO MARIA VICTORIA. Representan: PAVON PALOMO MARIA ESPERANZA. Consejero: MOVENS RENT SL;SANTAISABEL 246 SL. Datos registrales. T 11642 , F 219, S 8, H M 182807, I/A 12 (19.01.10).

15 de Diciembre de 2009
Reelecciones. Auditor: AUDIT NETWORK SA. Datos registrales. T 11642 , F 218, S 8, H M 182807, I/A 11 ( 3.12.09).

03 de Julio de 2009
Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: MIRAT GOMEZ RAFAEL JUAN;DE LA SEN RUBI脩OS JESUS GONZALO. Consejero: AGUILERAFERNANDEZ EDUARDO;BERGAZ RUIZ FRANCISCO JAVIER; CORDERO GUERRERO SERGIO DE BORJA;DE ANTONIO MARTINJUAN ANTONIO;DE LA SEN RUBI脩OS JESUS GONZALO;FERNANDEZ GOMEZ JESUS;FERNANDEZ GOMEZ FRANCISCOJOSE;FERNANDEZ GOMEZ SANTIAGO;GAITAN LUACES JUAN JOSE;GARCIA PEREZ FRANCISCO JAVIER;GOMEZ DORADOGUILLERMO;MESQUIDA FRANCO FRANCISCO;MIRAT GOMEZ RAFAEL JUAN;PEINADO CUADRADO JUAN LUIS;RODRIGUEZBERGAZ MARIA JOSE. Secretario: DE LA SEN RUBI脩OS JESUS GONZALO. Nombramientos. Consejero: MORENO ROMEROFELIPE;PAVON PALOMO MARIA VICTORIA;MORENO PAVON ALBERTO;SANCHEZ GARCIA ANGEL. Secretario: SANCHEZGARCIA ANGEL. Apoderado: MORENO ROMERO FELIPE;SANCHEZ GARCIA ANGEL. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n:1.752.492,00 Euros. Resultante Suscrito: 250.356,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 750.000,05 Euros. Desembolsado:750.000,05 Euros. Resultante Suscrito: 1.000.356,05 Euros. Resultante Desembolsado: 1.000.356,05 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 11642 , F 54, S 8, H M182807, I/A 10 (23.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n