Actos BORME de Coaliment Castilla Sa
24 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1677 , F 171, S 8, H TO 1044, I/A 74 (17.11.22).
19 de Mayo de 2022Revocaciones. Apoderado: MONTES CABALLERO JOSE PABLO. Datos registrales. T 1677 , F 171, S 8, H TO 1044, I/A 73(11.05.22).
27 de Octubre de 2021Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1677 , F 171, S 8, H TO 1044, I/A 72 (20.10.21).
12 de Noviembre de 2020Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1677 , F 171, S 8, H TO 1044, I/A 71 ( 3.11.20).
20 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: MADRO脩O LLAMAS JOSE OLIVERIO. Datos registrales. T 1677 , F 170, S 8, H TO 1044, I/A 69 (9.07.20).
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: HD COVALCO SL;GRANOLLERS IMMOBLES SL. Nombramientos. Adm. Solid.: HD COVALCOSL;GRANOLLERS IMMOBLES SL. Datos registrales. T 1677 , F 171, S 8, H TO 1044, I/A 70 ( 9.07.20).
06 de Abril de 2020Revocaciones. Apoderado: OCHOA SANCHEZ HUGO. Datos registrales. T 1677 , F 170, S 8, H TO 1044, I/A 68 (26.03.20).
04 de Marzo de 2020Revocaciones. Apoderado: GARCIA ARROYO GUSTAVO;GARCIA ARROYO GUSTAVO. Datos registrales. T 1677 , F 170, S 8, HTO 1044, I/A 67 (21.02.20).
12 de Noviembre de 2019Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1677 , F 170, S 8, H TO 1044, I/A 66 ( 5.11.19).
24 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1613 , F 210, S 8, H TO 1044, I/A 65 (17.01.19).
19 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: GARCIA ARROYO GUSTAVO. Datos registrales. T 1613 , F 210, S 8, H TO 1044, I/A 64 (12.12.18).
11 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: GARCIA ARROYO GUSTAVO. Datos registrales. T 1613 , F 210, S 8, H TO 1044, I/A 63 (26.11.18).
04 de Mayo de 2018Cambio de objeto social. 1.- Distribuci贸n, comercializaci贸n y venta productos alimenticios, bebidas y art铆culos uso dom茅stico ycuantas actividades est茅n relacionadas con el objeto principal. 2.- Actividad inmobiliaria consistente en compra, venta ycomercializaci贸n fincas, arrendamiento inmuebles, reforma y rehabilitaci贸n. Datos registrales. T 1613 , F 209, S 8, H TO 1044, I/A 62(26.04.18).
30 de Abril de 2018Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1613 , F 209, S 8, H TO 1044, I/A 60 (18.04.18).
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1613 , F 209, S 8, H TO 1044, I/A 61 (18.04.18).
25 de Enero de 2016Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1613 , F 209, S 8, H TO 1044, I/A 59 (18.01.16).
04 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: MONTES CABALLERO JOSE PABLO. Datos registrales. T 1562 , F 225, S 8, H TO 1044, I/A 55(26.11.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: SAPERAS AYMAR JOSEP. Apo.Manc.: SAPERAS AYMAR JOSEP;CASTELLS GARCIAMIGUEL;TORDERA ARAUS JOAQUIM. Datos registrales. T 1613 , F 208, S 8, H TO 1044, I/A 56 (26.11.15).
Revocaciones. Apo.Manc.: CAMPAS MITJAVILA CARLES;CAMPAS MITJAVILA CARLES. Apo.Sol.: CAMPAS MITJAVILA CARLES.Apo.Manc.: CAMPAS MITJAVILA CARLES. Apo.Sol.: CAMPAS MITJAVILA CARLES. Apo.Manc.: CAMPAS MITJAVILA CARLES.Apo.Sol.: CAMPAS MITJAVILA CARLES. Apo.Manc.: CAMPAS MITJAVILA CARLES;CAMPAS MITJAVILA CARLES. Apo.Sol.: VIVESPLANELL JOAN. Apo.Manc.: VIVES PLANELL JOAN. Apoderado: FERNANDEZ SANCHEZ DANIEL. Datos registrales. T 1613 , F208, S 8, H TO 1044, I/A 57 (26.11.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: LAPUENTE GINE DAVID. Apo.Manc.: LAPUENTE GINE DAVID;SAPERAS AYMAR JOSEP;CASTELLSGARCIA MIGUEL;TORDERA ARAUS JOAQUIM. Datos registrales. T 1613 , F 208, S 8, H TO 1044, I/A 58 (26.11.15).
02 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: HD COVALCO SL;COALIMENT GRANOLLERS SA. Nombramientos. Adm. Solid.: HD COVALCOSL;GRANOLLERS IMMOBLES SL. Datos registrales. T 1562 , F 225, S 8, H TO 1044, I/A 54 (26.10.15).
11 de Noviembre de 2014Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1562 , F 225, S 8, H TO 1044, I/A 53 ( 3.11.14).
20 de Octubre de 2014Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ SANCHEZ DANIEL. Datos registrales. T 1562 , F 224, S 8, H TO 1044, I/A 51(13.10.14).
Revocaciones. Apoderado: CUESTA MARTINEZ PEDRO ANTONIO. Datos registrales. T 1562 , F 224, S 8, H TO 1044, I/A 52(13.10.14).
21 de Abril de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: RAMOS HORTA JOSE ANTONIO. Apo.Manc.: RAMOS HORTA JOSE ANTONIO. Apo.Sol.: RAMOSHORTA JOSE ANTONIO;ORTA MAGA脩A RAMON. Apo.Manc.: ORTA MAGA脩A RAMON. Apoderado: CARABALLO GOMEZANTONIO. Apo.Manc.: TALLON LUENGO HECTOR. Apo.Sol.: RUEDA QUINTERO FRANCISCO-JAVIER. Apo.Manc.: RUEDAQUINTERO FRANCISCO-JAVIER. Apoderado: FERNANDEZ SANCHEZ DANIEL. Datos registrales. T 1562 , F 223, S 8, H TO 1044,I/A 49 (10.04.14).
Nombramientos. Apoderado: CUESTA MARTINEZ PEDRO ANTONIO. Datos registrales. T 1562 , F 224, S 8, H TO 1044, I/A 50(10.04.14).
06 de Marzo de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: VIVES PLANELL JOAN. Apo.Manc.: VIVES PLANELL JOAN;CASTELLS GARCIA MIGUEL;TORDERAARAUS JOAQUIM. Datos registrales. T 1562 , F 223, S 8, H TO 1044, I/A 48 (27.02.14).
27 de Noviembre de 2013Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: HD COVALCO SL. Datos registrales. T 1562 , F 222, S 8, H TO1044, I/A 46 (18.11.13).
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1562 , F 223, S 8, H TO 1044, I/A 47 (18.11.13).
07 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apoderado: OCHOA SANCHEZ HUGO. Datos registrales. T 1562 , F 222, S 8, H TO 1044, I/A 44 (24.10.13).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ SANCHEZ DANIEL. Datos registrales. T 1562 , F 222, S 8, H TO 1044, I/A 45(24.10.13).
29 de Abril de 2013Nombramientos. Apoderado: TORDERA ARAUS JOAQUIM. Datos registrales. T 1401 , F 172, S 8, H TO 1044, I/A 43 (18.04.13).
27 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: COALIMENT GRANOLLERS SA;HD COVALCO SA. Nombramientos. Adm. Solid.: COALIMENTGRANOLLERS SA;HD COVALCO SL. Datos registrales. T 1401 , F 172, S 8, H TO 1044, I/A 42 (19.03.13).
12 de Noviembre de 2012Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1401 , F 172, S 8, H TO 1044, I/A 41 (29.10.12).
28 de Mayo de 2012Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1401 , F 171, S 8, H TO 1044, I/A 39 (17.05.12).
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: COALIMENT GRANOLLERS SA;HD COVALCO SA. Nombramientos. Adm. Solid.: COALIMENTGRANOLLERS SA;HD COVALCO SA. Datos registrales. T 1401 , F 172, S 8, H TO 1044, I/A 40 (17.05.12).
29 de Agosto de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: RUEDA QUINTERO FRANCISCO-JAVIER. Apo.Manc.: RUEDA QUINTERO FRANCISCO-JAVIER;TORDERA ARAUS JOAQUIM;TALLON LUENGO HECTOR;CAMPAS MITJAVILA CARLOS. Datos registrales. T 1401 , F171, S 8, H TO 1044, I/A 38 (18.08.11).
24 de Noviembre de 2010Reelecciones. Auditor: AUDIHISPANA GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1401 , F 171, S 8, H TO 1044, I/A 37(15.11.10).
05 de Marzo de 2010Reelecciones. Auditor: AUDIHISPANA GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1401 , F 171, S 8, H TO 1044, I/A 36(22.02.10).
16 de Febrero de 2010Reelecciones. Auditor: AUDIHISPANA GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1401 , F 170, S 8, H TO 1044, I/A 35 (4.02.10).
23 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: SAPERAS VERGARA JORDI. Apo.Manc.: TORDERA ARAUS JOAQUIM;TALLON LUENGO HECTOR.Datos registrales. T 1401 , F 170, S 8, H TO 1044, I/A 34 (12.11.09).
19 de Enero de 2009Reelecciones. Auditor: AUDIHISPANA GRANT THORNTON SL. Datos registrales. T 1401 , F 169, S 8, H TO 1044, I/A 33 (5.01.09).