Buscador CIF Logo

Actos BORME Coalsider Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Coalsider Sl

Actos BORME Coalsider Sl - B79907713

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Coalsider Sl con CIF B79907713

馃敊 Perfil de Coalsider Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Coalsider Sl

21 de Noviembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: GIL ALFONSO SA. Representan: ASENSIO MATEO DAVID. Nombramientos. Consejero: LIBRADOHIERROS SA. Representan: GARCIA DEL BURGO JESUS. Datos registrales. T 36749 , F 4, S 8, H M 20187, I/A 47 (14.11.19).

27 de Septiembre de 2019
Cambio de domicilio social. AVDA DE MENENDEZ PELAYO 67 3 - OFICINA 3 (MADRID). Datos registrales. T 36749 , F 3, S 8, HM 20187, I/A 46 (19.09.19).

25 de Octubre de 2018
Revocaciones. Apoderado: GIL RINCON VIDAL. Nombramientos. Apoderado: GARCIA ERRAZQUIN MIGUEL;GARCIAERRAZQUIN MIGUEL. Datos registrales. T 36749 , F 2, S 8, H M 20187, I/A 45 (18.10.18).

11 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Presidente: GIL ALFONSO SA. Nombramientos. Presidente: HIERROS COMERCIAL CANTABRICA SA.Datos registrales. T 36749 , F 1, S 8, H M 20187, I/A 44 (30.11.17).

07 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Consejero: HIJOS DE FRANCISCO DIAZ SL. Representan: DIAZ MANZANO FRANCISCO JOSE. Datosregistrales. T 24666 , F 128, S 8, H M 20187, I/A 42 (28.11.17).

12 de Septiembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: GIL RINCON VIDAL. Nombramientos. Representan: ASENSIO MATEO DAVID. Datosregistrales. T 24666 , F 128, S 8, H M 20187, I/A 41 ( 5.09.17).

07 de Septiembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ PORTILLA ROBERTO. Apo.Man.Soli: NIETO GONZALEZ MANUELA;SANTANAGONZALEZ JOSE IGNACIO;GOMEZ MU脩OZ FERNANDO. Nombramientos. Apoderado: NIETO GONZALEZ MANUELA;LORENTEGOMEZ JOSE MIGUEL;GIL RINCON VIDAL. Cambio de domicilio social. AVDA DE MENENDEZ PELAYO 67 (MADRID). Datosregistrales. T 24666 , F 127, S 8, H M 20187, I/A 40 (29.08.17).

09 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANTANA GONZALEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 24666 , F 126, S 8, H M 20187, I/A 39 (1.08.17).

07 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: GOMEZ MU脩OZ FERNANDO;CAMPOS AGUAR DELFIN JOSE. Consejero: HIERROS TOLEDOSA;GRANALLADOS Y TUBOS SA. Presidente: HIERROS TOLEDO SA. Nombramientos. Representan: SERRANO GARCIAI脩IGO;GARCIA ERRAZQUIN MIGUEL. Consejero: HIERROS COMERCIAL CANTABRICA SA;SINASE ALFONSO SA. Presidente: GILALFONSO SA. Datos registrales. T 24666 , F 125, S 8, H M 20187, I/A 38 (31.07.17).

06 de Abril de 2017
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 35 DE LA SOCIEDAD EL NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERODE LA SOCIEDAD HIERROS GIL ALFONSO SA SIENDO LO CORRECTO GIL ALFONSO SA. Datos registrales. T 24666 , F 124, S8, H M 20187, I/A 35 (11.09.12).

29 de Agosto de 2013
Reelecciones. Auditor: TAX CONSULTING I AUDITORIA SL. Datos registrales. T 24666 , F 125, S 8, H M 20187, I/A 37 (12.08.13).

20 de Junio de 2013
Ceses/Dimisiones. Representan: RODRIGO SOGUERO JOSE MIGUEL. Consejero: ACEROS Y TUBOS RODRIGO SA. Datosregistrales. T 24666 , F 125, S 8, H M 20187, I/A 36 (12.06.13).

21 de Septiembre de 2012
Nombramientos. Consejero: ACEROS Y TUBOS RODRIGO SA;HIERROS GIL ALFONSO SA. Representan: GIL RINCONVIDAL;RODRIGO SOGUERO JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 24666 , F 124, S 8, H M 20187, I/A 35 (11.09.12).

09 de Julio de 2012
Reelecciones. Auditor: TAX CONSULTING I AUDITORIA SL. Datos registrales. T 24666 , F 124, S 8, H M 20187, I/A 34 (27.06.12).

07 de Diciembre de 2010
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 72.123,00 Euros. Resultante Suscrito: 504.861,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importereducci贸n: 48.082,00 Euros. Resultante Suscrito: 456.779,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5.Capital.-. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.- 5. Capital.-. Datos registrales. T 24666 , F 124, S 8, H M 20187, I/A 33 (22.11.10).

22 de Noviembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: HIERROS MORA ANTON SA;HIERROS CALIBRADOS Y LAMINADOS SL. Representan: RAMONMOJICA ELISEO;HERNANDEZ SIMO AGUSTIN. Datos registrales. T 24666 , F 123, S 8, H M 20187, I/A 32 (10.11.10).

19 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ PORTILLA ROBERTO;AGUSTI ALFARA JOAN BARTOMEU;NIETO GONZALEZMANUELA;CASTILLO VILCHEZ FRANCISCO JAVIER;SANTANA GONZALEZ JOSE IGNACIO. Nombramientos. Apoderado:GONZALEZ PORTILLA ROBERTO. Apo.Man.Soli: NIETO GONZALEZ MANUELA;SANTANA GONZALEZ JOSE IGNACIO;GOMEZMU脩OZ FERNANDO. Datos registrales. T 24666 , F 122, S 8, H M 20187, I/A 31 ( 8.11.10).

17 de Noviembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: TIRSO CSA SA. Presidente: TIRSO CSA SA. Consejero: FERROS AGUSTI SL;HIERROS ALFONSOSA. Representan: GONZALEZ PORTILLA ROBERTO;BELDA MOLTO JOSE;AGUSTI ALFARA JOAN BARTOMEU;LONGASLAFUENTE FELIX. Nombramientos. Representan: RAMON MOJICA ELISEO. Consejero: HIERROS TOLEDO SA;GRANALLADOSY TUBOS SA;HIERROS CALIBRADOS Y LAMINADOS SL. Representan: GOMEZ MU脩OZ FERNANDO;CAMPOS AGUAR DELFINJOSE;HERNANDEZ SIMO AGUSTIN. Presidente: HIERROS TOLEDO SA. Datos registrales. T 24666 , F 121, S 8, H M 20187, I/A30 ( 5.11.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n