Actos BORME de Codeactivos Sa
05 de Mayo de 2023Reelecciones. Consejero: BAM PARTICIPACIONES SL. Secretario: BAM PARTICIPACIONES SL. Consejero: FIRA SARL. Datosregistrales. T 33708 , F 161, S 8, H M 448362, I/A 32 (26.04.23).
24 de Marzo de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: BORRAS RUIZ FERNANDO. Datos registrales. T 33708 , F 160, S 8, H M 448362, I/A 30 (17.03.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ BAOS MARIA SOLEDAD;AOUN GEORGES ABI. Datos registrales. T 33708 , F 160, S 8,H M 448362, I/A 31 (17.03.22).
05 de Octubre de 2021Otros conceptos: DON JORGE RIUS GARRETA HA RENUNCIADO AL PODER CONFERIDO A SU FAVOR EN LA INSRIPCION 4ªDE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 33708 , F 160, S 8, H M 448362, I/A 29 (28.09.21).
28 de Septiembre de 2021Otros conceptos: DOÑA MARIA EUGENIA RUBIO RODRIGUEZ VIGIL RENUNCIA AL PODER QUE LE FUE CONFERIDOMEDIANTE ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 4ª. Datos registrales. T 33708 , F 160, S 8, H M 448362, I/A 28 (21.09.21).
14 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: REGIMBEAU GEORGES JEAN MICHEL CHARLES. Datos registrales. T 33708 , F 159, S 8, H M448362, I/A 27 ( 7.06.21).
10 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Representan: BORRAS RUIZ FERNANDO. Consejero: DELTA GESTION ACTIVOS SL. Presidente: DELTAGESTION ACTIVOS SL. Nombramientos. Presidente: REGIMBEAU GEORGES JEAN MICHEL CHARLES. Datos registrales. T33708 , F 158, S 8, H M 448362, I/A 25 ( 3.06.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: MOLINA PEREZ PABLO;CARRANZA GONZALEZ JOAQUIN. Datos registrales. T 33708 , F 158, S 8, H M448362, I/A 26 ( 3.06.21).
24 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. Representan: BORRAS CORREO FERNANDO. Nombramientos. Representan: BORRAS RUIZ FERNANDO.Datos registrales. T 33708 , F 158, S 8, H M 448362, I/A 24 (17.05.21).
03 de Agosto de 2020Nombramientos. Consejero: REGIMBEAU GEORGES JEAN MICHEL CHARLES. Datos registrales. T 33708 , F 157, S 8, H M448362, I/A 23 (27.07.20).
21 de Julio de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: MIDYPREST SARL. Representan: MICOULEAU DIDIER. Datos registrales. T 33708 , F 157, S 8, HM 448362, I/A 22 (14.07.20).
30 de Octubre de 2018Revocaciones. Apoderado: SANFRUTOS CAÑIZARES VICTOR ANDRES. Apo.Man.Soli: MOLINA PEREZ PABLO;VALEROSVARGAS ALVARO;CARRANZA GONZALEZ JOAQUIN;BORRAS RUIZ FERNANDO. Apo.Sol.: RODRIGUEZ LLORENTE JOSEALBERTO;CARREÑO ALVAREZ IRENE. Nombramientos. Apo.Sol.: BORRAS RUIZ FERNANDO;MOLINA PEREZPABLO;CARRANZA GONZALEZ JOAQUIN;SANCHEZ RUBIO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 33708 , F 156, S 8, H M448362, I/A 21 (19.10.18).
22 de Enero de 2018Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: MANGEZ MARC. Reelecciones. Consejero: DELTA GESTION ACTIVOSSL. Presidente: DELTA GESTION ACTIVOS SL. Consejero: BAM PARTICIPACIONES SL. Secretario: BAM PARTICIPACIONES SL.Consejero: MIDYPREST SARL;FIRA SARL. Cambio de domicilio social. C/ CONDESA DE VENADITO 5A 3ª (MADRID). Datosregistrales. T 33708 , F 155, S 8, H M 448362, I/A 20 (15.01.18).
26 de Agosto de 2015Ampliación de capital. Suscrito: 200.000,00 Euros. Desembolsado: 200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 402.040,00 Euros.Resultante Desembolsado: 402.040,00 Euros. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 25 DE LOSESTATUTOS SOCIALES Y REFUNDICION Y NUEVA REDACCION DE LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Páginaweb de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.codeactivos.com. Datos registrales. T 24903 , F 216, S 8, H M448362, I/A 19 (17.08.15).
29 de Agosto de 2012Reelecciones. Consejero: DELTA GESTION ACTIVOS SL. Presidente: DELTA GESTION ACTIVOS SL. Consejero: BAMPARTICIPACIONES SL. Secretario: BAM PARTICIPACIONES SL. Consejero: MIDYPREST SARL;FIRA SARL;MANGEZ MARC.Datos registrales. T 24903 , F 216, S 8, H M 448362, I/A 18 (17.08.12).
22 de Febrero de 2012Revocaciones. Apoderado: MOLINA PEREZ PABLO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MOLINA PEREZ PABLO. Datos registrales.T 24903 , F 212, S 8, H M 448362, I/A 13 (10.02.12).
Revocaciones. Apoderado: VALEROS VARGAS ALVARO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: VALEROS VARGAS ALVARO. Datosregistrales. T 24903 , F 213, S 8, H M 448362, I/A 14 (10.02.12).
Revocaciones. Apoderado: CARRANZA GONZALEZ JOAQUIN. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CARRANZA GONZALEZJOAQUIN. Datos registrales. T 24903 , F 214, S 8, H M 448362, I/A 15 (10.02.12).
Revocaciones. Apoderado: BORRAS RUIZ FERNANDO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BORRAS RUIZ FERNANDO. Datosregistrales. T 24903 , F 214, S 8, H M 448362, I/A 16 (10.02.12).
Revocaciones. Apoderado: MUÑIZ PRIETO MARIA ANGELES;CHAULET SAMANTHA;SIERRA IZQUIERDO MARIAPILAR;GONZALEZ CASTIÑEIRA RAQUEL;ECHEVARRIA ALDAY ITZIAR. Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ LLORENTEJOSE ALBERTO;GUTIERREZ IBAÑES DAVID;CARREÑO ALVAREZ IRENE;RASILLA VALTIERRA TERESA. Datos registrales. T24903 , F 215, S 8, H M 448362, I/A 17 (10.02.12).
24 de Noviembre de 2010Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 9.170,00 Euros. Datos registrales. T 24903 , F 211, S 8, H M 448362, I/A 12(15.11.10).
24 de Marzo de 2010Ampliación de capital. Suscrito: 36.690,00 Euros. Desembolsado: 27.520,00 Euros. Resultante Suscrito: 202.040,00 Euros.Resultante Desembolsado: 192.870,00 Euros. Datos registrales. T 24903 , F 210, S 8, H M 448362, I/A 11 (10.03.10).
09 de Junio de 2009Nombramientos. Consejero: MANGEZ MARC. Datos registrales. T 24903 , F 210, S 8, H M 448362, I/A 10 (27.05.09).
28 de Enero de 2009Ampliación de capital. Suscrito: 65.350,00 Euros. Desembolsado: 65.350,00 Euros. Resultante Suscrito: 165.350,00 Euros.Resultante Desembolsado: 165.350,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital.-. Datosregistrales. T 24903 , F 210, S 8, H M 448362, I/A 9 (14.01.09).