Buscador CIF Logo

Actos BORME Codere Castilla Y Leon Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Codere Castilla Y Leon Sl

Actos BORME Codere Castilla Y Leon Sl - B47742291

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Codere Castilla Y Leon Sl con CIF B47742291

馃敊 Perfil de Codere Castilla Y Leon Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Codere Castilla Y Leon Sl

30 de Mayo de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ ZAFRA JACOBO. Apo.Sol.: LOPEZ ZAFRA JACOBO. Apo.Man.Soli: LOPEZ ZAFRA JACOBO.Datos registrales. T 39107 , F 163, S 8, H M 694841, I/A 4 (23.05.22).

25 de Marzo de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CORZO UCEDA ANGEL;IGLESIAS SANCHEZ OSCAR. Nombramientos. Adm. Solid.: MIRANDAFONTES EMILIO. Datos registrales. T 39107 , F 162, S 8, H M 694841, I/A 3 (18.03.22).

31 de Mayo de 2019
Cambio de domicilio social. AVDA DE BRUSELAS 26 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 39107 , F 162, S 8, H M 694841, I/A 2(25.05.19).

27 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: MIRANDA FONTES EMILIO. Datos registrales. T 1486 , F 122, S 8, H VA 27577, I/A 17 (19.12.18).

Nombramientos. Apoderado: MIRANDA FONTES EMILIO. Datos registrales. T 1548 , F 55, S 8, H VA 27577, I/A 18 (19.12.18).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ ZAFRA JACOBO;MIRANDA FONTES EMILIO. Datos registrales. T 1548 , F 55, S 8, H VA27577, I/A 19 (19.12.18).

04 de Diciembre de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ QUERO JESUS. Apo.Man.Soli: MARTINEZ QUERO JESUS. Datos registrales. T 1486 , F122, S 8, H VA 27577, I/A 16 (27.11.18).

13 de Junio de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: VALLEJO ORTEGA ISIDRO;MARTIN FRADEJAS MARIA PALOMA;MARCOS DIAZ MERCEDES. Datosregistrales. T 1486 , F 122, S 8, H VA 27577, I/A 14 ( 6.06.18).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: JIMENEZ MARQUEZ DAVID;DI LORETO VICENTE. Nombramientos. Adm. Solid.: CORZOUCEDA ANGEL;IGLESIAS SANCHEZ OSCAR. Datos registrales. T 1486 , F 122, S 8, H VA 27577, I/A 15 ( 6.06.18).

16 de Abril de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: PASCUAL GONZALEZ ALEJANDRO;QUEIRO AMEIJEIRAS MANUEL;OFICIALDEGUI ATIN JONAS.Datos registrales. T 1486 , F 121, S 8, H VA 27577, I/A 13 ( 9.04.18).

26 de Marzo de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ SAMPEDRO ENCARNACION. Nombramientos. Adm. Solid.: JIMENEZ MARQUEZDAVID;DI LORETO VICENTE;PASCUAL GONZALEZ ALEJANDRO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Datos registrales. T 1486 , F 121, S 8, H VA 27577, I/A 12 (19.03.18).

29 de Junio de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SERRANO JIMENEZ FRANCISCO-GABRIEL;SERRANO JIMENEZ FRANCISCO-GABRIEL. Datosregistrales. T 1486 , F 121, S 8, H VA 27577, I/A 11 (23.06.17).

02 de Diciembre de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: VECINA CABEZA SANTIAGO. Datos registrales. T 1486 , F 121, S 8, H VA 27577, I/A 10 (25.11.16).

10 de Octubre de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VALLEJO ORTEGA ISIDRO;MARCOS DIAZ MERCEDES. Datos registrales. T 1486 , F 120, S 8, HVA 27577, I/A 9 ( 3.10.16).

07 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: PASCUAL GONZALEZ ALEJANDRO;QUEIRO AMEIJEIRAS MANUEL;MARTINEZ QUEROJESUS;CABEZA DE VACA NIETO LUIS MIGUEL;PARRA CEBEIRA JUAN IGNACIO;LOPEZ ZAFRA JACOBO. Datos registrales. T1486 , F 120, S 8, H VA 27577, I/A 8 (30.08.16).

20 de Junio de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SERRANO JIMENEZ FRANCISCO-GABRIEL;MARCOS DIAZ MERCEDES. Datos registrales. T1486 , F 119, S 8, H VA 27577, I/A 7 (13.06.16).

27 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PASCUAL GONZALEZ ALEJANDRO;QUEIRO AMEIJEIRAS MANUEL;MARTINEZ QUEROJESUS;VECINA CABEZA SANTIAGO;LOPEZ ZAFRA JACOBO. Datos registrales. T 1484 , F 215, S 8, H VA 27577, I/A 5 (20.11.15).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: QUEIRO AMEIJEIRAS MANUEL;VIDAL MESA FERNANDO;ALVAREZ NICOLAS MARIA-TERESA;SERRANO JIMENEZ FRANCISCO-GABRIEL;PEREZ BORDO FELIX. Datos registrales. T 1486 , F 119, S 8, H VA 27577,I/A 6 (20.11.15).

04 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PASCUAL GONZALEZ ALEJANDRO;QUEIRO AMEIJEIRAS MANUEL;MARTINEZ QUEROJESUS;VECINA CABEZA SANTIAGO;LOPEZ ZAFRA JACOBO. Datos registrales. T 1484 , F 213, S 8, H VA 27577, I/A 2 (28.10.15).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: QUEIRO AMEIJEIRAS MANUEL;VIDAL MESA FERNANDO;ALVAREZ NICOLAS MARIA-TERESA;SERRANO JIMENEZ FRANCISCO-GABRIEL;PEREZ BORDO FELIX. Datos registrales. T 1484 , F 214, S 8, H VA 27577,I/A 3 (28.10.15).

Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ PEREZ JUAN MIGUEL;GONZALEZ REDONDO ANGEL;TABERNER BENAGES FRANCISCO.Datos registrales. T 1484 , F 215, S 8, H VA 27577, I/A 4 (28.10.15).

24 de Agosto de 2015
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 9.07.15. Objeto social: La organizaci贸n y explotaci贸n de juegos mediante la utilizaci贸n dem谩quinas recreativas y de azar. Domicilio: C/ RECONDO 11-13 (VALLADOLID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n