Actos BORME de Cofares Comercializadora Farmaceutica Sl
20 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: VICENTE PEREZ ANGEL-JAVIER. Nombramientos. Apoderado: SERRANO DEVILLE BELLECHASSEALBERTO. Datos registrales. T 40403 , F 89, S 8, H M 647318, I/A 19 (13.09.23).
07 de Junio de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ ANTON MANUEL IGNACIO. Nombramientos. Apoderado: DE MIGUEL O脩ATERICARDO;CASARES LORENZO CARLOS;PASTOR QUINTEIRO TEODORO. Datos registrales. T 40403 , F 89, S 8, H M 647318,I/A 18 (31.05.23).
01 de Junio de 2022Modificaciones estatutarias. Creado un nuevo art铆culo estatutario 17 bis.. Datos registrales. T 40403 , F 88, S 8, H M 647318, I/A17 (25.05.22).
23 de Mayo de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: GOMEZ BLANCO JESUS ANGEL. Nombramientos. Apoderado: CORTES ROBLEDO JOSE LUIS.Datos registrales. T 40403 , F 88, S 8, H M 647318, I/A 16 (13.05.22).
18 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALISES NARANJO MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ ANTON MANUELIGNACIO. Datos registrales. T 40403 , F 87, S 8, H M 647318, I/A 15 (11.11.21).
14 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: DOMINGUEZ BARBERA ANGEL BRUNO. Presidente: DOMINGUEZ BARBERA ANGEL BRUNO.Revocaciones. Apo.Man.Soli: DOMINGUEZ BARBERA ANGEL BRUNO. Nombramientos. Consejero: HERNANDEZ YUSTEALMUDENA. Presidente: POBLET GONZALEZ MIGUEL ANGEL. Apoderado: HERNANDEZ YUSTE ALMUDENA. Datos registrales.T 40403 , F 86, S 8, H M 647318, I/A 14 ( 7.04.21).
04 de Noviembre de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: SANZ LOPEZ FRANCISCO-JAVIER. Nombramientos. Apoderado: HERNAN-CARRILLO PORTOLESSANTIAGO. Datos registrales. T 40403 , F 86, S 8, H M 647318, I/A 13 (27.10.20).
05 de Junio de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANZ OTERO JOSE LUIS. Apoderado: SANZ OTERO JOSE LUIS;VICENTE PEREZ ANGELJAVIER;ALISES NARANJO MIGUEL ANGEL;ESGUEVA PEREZ LUIS;ORQUIN CASAS RUBEN;GARCIA ARIZ UNAI;POBLETGONZALEZ MIGUEL ANGEL;GOMEZ-AROSTEGUI GONZALEZ JOSE MARIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DOMINGUEZBARBERA ANGEL BRUNO;ORQUIN CASAS RUBEN;POBLET GONZALEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 40403 , F 85, S 8,H M 647318, I/A 12 (29.05.20).
27 de Mayo de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: COSMEN FERNANDEZ ALVARO;VALDEOLMOS GONZALEZ LUIS. Nombramientos.Consejero: DOMINGUEZ BARBERA ANGEL BRUNO. Presidente: DOMINGUEZ BARBERA ANGEL BRUNO. Consejero: POBLETGONZALEZ MIGUEL ANGEL;ORQUIN CASAS RUBEN. SecreNoConsj: COSMEN FERNANDEZ ALVARO. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 36026 , F64, S 8, H M 647318, I/A 11 (20.05.20).
02 de Marzo de 2020Ampliaci贸n de capital. Capital: 70.658.785,00 Euros. Resultante Suscrito: 70.718.785,00 Euros. Datos registrales. T 36026 , F 61,S 8, H M 647318, I/A 10 (24.02.20).
28 de Enero de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: PASTOR FERNANDEZ EDUARDO;LINARES BERTOLIN GASPAR;GASTEARENAGORROCHATEGUI MIKEL;MARTINEZ IMAZ EMILIO;MARTINEZ VICENTE ROSA MARIA. Nombramientos. Apoderado: SANZOTERO JOSE LUIS;VICENTE PEREZ ANGEL JAVIER;ALISES NARANJO MIGUEL ANGEL;ESGUEVA PEREZ LUIS;ORQUINCASAS RUBEN;GARCIA ARIZ UNAI;POBLET GONZALEZ MIGUEL ANGEL;GOMEZ-AROSTEGUI GONZALEZ JOSE MARIA. Datosregistrales. T 36026 , F 61, S 8, H M 647318, I/A 9 (21.01.20).
06 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: GASTEARENA GORROCHATEGUI MIKEL;MARTINEZ IMAZ EMILIO;MARTINEZ VICENTE ROSAMARIA. Datos registrales. T 36026 , F 60, S 8, H M 647318, I/A 8 (29.10.19).
20 de Junio de 2019Fe de erratas: Se public贸 por error el n煤mero de inscripci贸n del cambio de duraci贸n de cargos como Inscripci贸n 7陋, siendo lo corercto6陋. Datos registrales. T 36026 , F 34, S 8, H M 647318, I/A 6 (10.05.19).
Cambio de objeto social. La realizaci贸n de cualquier actividad directa o indirectamente relacionada con los servicios en el 谩mbito delsector de distribuci贸n farmac茅utica. El desarrollo de actividades de almacenamiento, dep贸sito, distribuci贸n, comercializaci贸n,fabricaci贸n, de especialidades farmaceuticas y medicamentos. Datos registrales. T 36026 , F 37, S 8, H M 647318, I/A 7 (13.06.19).