Buscador CIF Logo

Actos BORME Cofares Diversificacion Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cofares Diversificacion Sl

Actos BORME Cofares Diversificacion Sl - B83056598

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Cofares Diversificacion Sl con CIF B83056598

🔙 Perfil de Cofares Diversificacion Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Cofares Diversificacion Sl

18 de Octubre de 2023
Ampliación de capital. Capital: 7.980.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 12.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 30324 , F 106,S 8, H M 289312, I/A 37 (10.10.23).

18 de Septiembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: VICENTE PEREZ ANGEL JAVIER. Presidente: VICENTE PEREZ ANGEL JAVIER. Revocaciones.Apo.Sol.: VICENTE PEREZ ANGEL JAVIER. Apo.Man.Soli: VICENTE PEREZ ANGEL JAVIER. Nombramientos. Consejero:ORQUIN CASAS RUBEN. Presidente: ORQUIN CASAS RUBEN. Apoderado: SERRANO DEVILLE BELLECHASSE ALBERTO.Datos registrales. T 30324 , F 105, S 8, H M 289312, I/A 36 (11.09.23).

07 de Junio de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ ANTON MANUEL IGNACIO. Nombramientos. Apoderado: PASTOR QUINTEIROTEODORO;DE MIGUEL OÑATE RICARDO;CASARES LORENZO CARLOS. Datos registrales. T 30324 , F 104, S 8, H M 289312,I/A 35 (31.05.23).

27 de Mayo de 2022
Modificaciones estatutarias. INTRODUCCION DEL ARTICULO 22.BIS DE LOS ESTATUTOS.. Datos registrales. T 30324 , F 104,S 8, H M 289312, I/A 34 (20.05.22).

23 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: ALISES NARANJO MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ ANTON MANUELIGNACIO. Datos registrales. T 30324 , F 103, S 8, H M 289312, I/A 33 (16.11.21).

13 de Abril de 2021
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-. Cambio de objeto social. la realización de cualquieractividad directa o indirectamente relacionada con los servicios en el ámbito del sector de distribución farmacéutica, por tanto laSociedad podrá realizar para sí o para otras personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras,. Datosregistrales. T 30324 , F 102, S 8, H M 289312, I/A 32 ( 6.04.21).

03 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: SANZ LOPEZ FRANCISCO-JAVIER. Nombramientos. Apo.Sol.: HERNAN-CARRILLO PORTOLESSANTIAGO. Datos registrales. T 30324 , F 102, S 8, H M 289312, I/A 31 (26.10.20).

12 de Mayo de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: COFARES CORPORACION SL;MARCELLES RAMIREZ JOSE LUIS. Presidente: COFARESCORPORACION SL. Secretario: MARCELLES RAMIREZ JOSE LUIS. Consejero: ALISES NARANJO MIGUEL ANGEL. Representan:RODRIGUEZ BERMUDEZ AQUILINO. Nombramientos. Consejero: VICENTE PEREZ ANGEL JAVIER;LEWIN OROZCO LUZLOURDES;COSMEN FERNANDEZ ALVARO. Presidente: VICENTE PEREZ ANGEL JAVIER. Secretario: COSMEN FERNANDEZALVARO. Ampliación de capital. Capital: 4.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.020.000,00 Euros. Datos registrales. T 30324, F 100, S 8, H M 289312, I/A 29 ( 4.05.20).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: GOMEZ BLANCO JESUS ANGEL;PASTOR FERNANDEZ EDUARDO;LINARES BERTOLIN GASPAR.Apo.Manc.: PASTOR FERNANDEZ EDUARDO;VICENTE PEREZ ANGEL JAVIER. Apoderado: VALDEOLMOS GONZALEZ

21 de Febrero de 2020
Declaración de unipersonalidad. Socio único: COFARES CORPORACION SL. Datos registrales. T 30324 , F 100, S 8, H M289312, I/A 28 (14.02.20).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información