Buscador CIF Logo

Actos BORME Cofem Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cofem Sa

Actos BORME Cofem Sa - A08537144

Tenemos registrados 13 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Cofem Sa con CIF A08537144

馃敊 Perfil de Cofem Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Cofem Sa

17 de Mayo de 2021
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: SAURA MARGARIT LLORENC. AUDITOR SUP.: MONCUNILL AUDITORS SL. Datosregistrales. T 44896 , F 23, S 8, H B 26861, I/A 31 ( 7.05.21).

09 de Abril de 2021
Cambio de domicilio social. CL COMPOSITOR WAGNER NUM.8-10 P.I.CAN JARDI (RUBI). Datos registrales. T 44896 , F 22, S8, H B 26861, I/A 30 (31.03.21).

16 de Junio de 2020
Nombramientos. ADM.UNICO: FERNANDEZ MORENO MARIA MAGNOLIA. Datos registrales. T 44896 , F 22, S 8, H B 26861, I/A29 ( 5.06.20).

28 de Diciembre de 2018
Nombramientos. AUDITOR TIT.: SAURA MARGARIT LLORENC. AUDITOR SUP.: MONCUNILL AUDITORS SL. Datos registrales.T 44896 , F 22, S 8, H B 26861, I/A 28 (20.12.18).

13 de Noviembre de 2017
Revocaciones. APODERADO: FERNANDEZ MORENO DANIEL JOSE. Datos registrales. T 44896 , F 22, S 8, H B 26861, I/A 27 (2.11.17).

06 de Septiembre de 2016
Nombramientos. APODERAD.SOL: FERNANDEZ LOPEZ DANIEL. Datos registrales. T 44896 , F 21, S 8, H B 26861, I/A 24(29.08.16).

Nombramientos. APODERAD.SOL: RUBIO FERNANDEZ ANDREA. Datos registrales. T 44896 , F 21, S 8, H B 26861, I/A 25(29.08.16).

Nombramientos. APODERAD.SOL: PEREZ PERDIGUERO VICENTE. Datos registrales. T 44896 , F 22, S 8, H B 26861, I/A 26(29.08.16).

16 de Julio de 2015
Revocaciones. CONSEJERO: FERNANDEZ LOPEZ DANIEL. PRESIDENTE: FERNANDEZ LOPEZ DANIEL. CONSEJERO:FERNANDEZ MORENO MARIA MAGNOLIA. SECRETARIO: FERNANDEZ MORENO MARIA MAGNOLIA. CONS. DELEG.:FERNANDEZ MORENO MARIA MAGNOLIA. CONSEJERO: FERNANDEZ MORENO DANIEL JOSE. Nombramientos. ADM.UNICO:FERNANDEZ MORENO MARIA MAGNOLIA. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 13,18,25 Y 28 DELOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL. Datosregistrales. T 34097 , F 181, S 8, H B 26861, I/A 23 ( 8.07.15).

26 de Abril de 2013
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 120.240,00 Euros. Desembolsado: 120.240,00 Euros. Resultante Suscrito: 237.173,40 Euros.Resultante Desembolsado: 237.173,40 Euros. Datos registrales. T 34097 , F 181, S 8, H B 26861, I/A 22 (19.04.13).

02 de Abril de 2013
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 56.031,84 Euros. Desembolsado: 56.031,84 Euros. Resultante Suscrito: 116.933,40 Euros.Resultante Desembolsado: 116.933,40 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ANION PRODUCTOS Y SISTEMASELECTRONICOS SA. Datos registrales. T 34097 , F 177, S 8, H B 26861, I/A 21 (19.03.13).

07 de Diciembre de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDIT NETWORKS SA. Datos registrales. T 34097 , F 177, S 8, H B 26861, I/A 20 (24.11.11).

22 de Junio de 2010
Nombramientos. CONSEJERO: FERNANDEZ LOPEZ DANIEL. PRESIDENTE: FERNANDEZ LOPEZ DANIEL. CONSEJERO:FERNANDEZ MORENO MARIA MAGNOLIA. SECRETARIO: FERNANDEZ MORENO MARIA MAGNOLIA. CONS. DELEG.:FERNANDEZ MORENO MARIA MAGNOLIA. CONSEJERO: FERNANDEZ MORENO DANIEL JOSE. Datos registrales. T 34097 , F176, S 8, H B 26861, I/A 19 ( 9.06.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n