Buscador CIF Logo

Actos BORME Cofra Service Office Madrid Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cofra Service Office Madrid Sociedad Limitada

Actos BORME Cofra Service Office Madrid Sociedad Limitada - B79081493

Tenemos registrados 36 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Cofra Service Office Madrid Sociedad Limitada con CIF B79081493

馃敊 Perfil de Cofra Service Office Madrid Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Cofra Service Office Madrid Sociedad Limitada

12 de Diciembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Representan: YBERN SALCEDO JULIO. Nombramientos. Representan: ASCHE MICHAEL. Datosregistrales. T 41568 , F 201, S 8, H M 167664, I/A 61 ( 1.12.22).

22 de Julio de 2022
Extinci贸n. Datos registrales. T 41568 , F 200, S 8, H M 167664, I/A 60 (15.07.22).

29 de Diciembre de 2020
Cambio de domicilio social. C/ VALPORTILLO I 13 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 27622 , F 80, S 8, H M 167664, I/A 58(21.12.20).

14 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BRENNINKMEIJER CHARLOTTE MARGARETHA BEATRIX MARIE;ARANA PARRAHEDONE;ALVAREZ CONTINENTE SONIA;CABELLO DE LOS COBOS FERNANDEZ DE SOLIS MARIA DEL. Datos registrales. T27622 , F 77, S 8, H M 167664, I/A 56 ( 7.11.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: YBERN SALCEDO JULIO. Datos registrales. T 27622 , F 79, S 8, H M 167664, I/A 57 ( 7.11.19).

13 de Noviembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: YBERN SALCEDO JULIO. Datos registrales. T 27622 , F 77, S 8, H M 167664, I/A 55 ( 6.11.19).

31 de Agosto de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: BRENNINKMEIJER ALPHONS PAULUS MARIA;HAMMER CHRISTOPH. Presidente:BRENNINKMEIJER ALPHONS PAULUS MARIA. Nombramientos. Consejero: ASCHE MICHAEL;BRENNINKMEIJER CHARLOTTEMARGARETHA BEATRIX MARIE. Presidente: BRENNINKMEIJER CHARLOTTE MARGARETHA BEATRIX MARIE. Modificacionesestatutarias. MODIIFCACION DEL ARTICULO 15潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 27622 , F 76, S 8, H M167664, I/A 54 (17.08.18).

23 de Mayo de 2018
Revocaciones. Apoderado: MORALES-ARCE SERRANO ALVARO. Datos registrales. T 27622 , F 76, S 8, H M 167664, I/A 53(16.05.18).

18 de Mayo de 2018
Revocaciones. Apoderado: BODEGO BENEITEZ MARIA JOSE;COELLO DE PORTUGAL FATIMA. Datos registrales. T 27622 , F76, S 8, H M 167664, I/A 52 (10.05.18).

11 de Agosto de 2017
Nombramientos. Apoderado: YBERN SALCEDO JULIO;MORALES-ARCE SERRANO ALVARO;ARANA PARRAHEDONE;ALVAREZ CONTINENTE SONIA;CABELLO DE LOS COBOS FERNANDEZ DE SOLIS MARIA DEL;BODEGO BENEITEZMARIA JOSE;COELLO DE PORTUGAL FATIMA. Datos registrales. T 27622 , F 74, S 8, H M 167664, I/A 51 ( 3.08.17).

01 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: SMEELE ROBERT HENRI ANTONIUS MARIE. Nombramientos. Consejero: DRURY JOHN. Datosregistrales. T 27622 , F 74, S 8, H M 167664, I/A 50 (19.05.17).

25 de Mayo de 2017
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ANTHOS MADRID SERVICE OFFICE SL. Datos registrales. T 27622 , F 72, S 8, HM 167664, I/A 49 (17.05.17).

25 de Octubre de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: TEIXEIRA MARTINS JARDIM LURDES MENDES. Datos registrales. T 27622 , F 72, S 8, H M167664, I/A 48 (14.10.16).

22 de Junio de 2016
Modificaciones estatutarias. Modificado el articulo 17 bis y refundici贸n de la totalidad de los estatutos sociales. Datos registrales. T27622 , F 70, S 8, H M 167664, I/A 47 (14.06.16).

03 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: BRENNINKMEIJER ROLAND HUGO MARIA. Presidente: BRENNINKMEIJER ROLAND HUGOMARIA. Nombramientos. Consejero: SMEELE ROBERT HENRI ANTONIUS MARIE. Presidente: BRENNINKMEIJER ALPHONSPAULUS MARIA. Datos registrales. T 27622 , F 70, S 8, H M 167664, I/A 46 (22.07.15).

24 de Julio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: GEILENKIRCHEN ERIK. Nombramientos. Consejero: HAMMER CHRISTOPH. Modificacionesestatutarias. MODIIFCACION DEL ARTICULO 15潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 27622 , F 69, S 8, H M167664, I/A 45 (17.07.15).

03 de Diciembre de 2014
Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27622 , F 69, S 8, H M 167664, I/A 44 (25.11.14).

24 de Noviembre de 2014
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 15, 16 Y 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EINCORPORACION DE NUEVO ARTICULO 17 BIS A LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 27622 , F 67, S 8, H M167664, I/A 42 (17.11.14).

Nombramientos. Apoderado: BRENNINKMEIJER ALPHONS PAULUS MARIA. Datos registrales. T 27622 , F 68, S 8, H M 167664,I/A 43 (17.11.14).

11 de Julio de 2014
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27622 , F 67, S 8, H M 167664, I/A 41 ( 2.07.14).

28 de Enero de 2014
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 18. Cierre del Ejercicio.-. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-. Cambio deobjeto social. LA REALIZACION, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,CONTABLES Y DE APOYO A LA GESTION.- Datos registrales. T 27622 , F 66, S 8, H M 167664, I/A 40 (21.01.14).

05 de Diciembre de 2013
Revocaciones. Apoderado: MENDES T MARTINS JARDIM LURDES;MORALEDA MENENDEZ JOSE LUIS;YBERN SALCEDOJULIO;MENDES T MARTINS JARDIM LURDES;MORALES ARCE SERRANO ALVARO;YBERN SALCEDO JULIO;PASAMON NAVIOAGUSTINA;MENDES T MARTINS JARDIM LURDES;MORALES ARCE SERRANO ALVARO. Datos registrales. T 27622 , F 66, S 8,H M 167664, I/A 39 (27.11.13).

19 de Junio de 2013
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27622 , F 66, S 8, H M 167664, I/A 38 (12.06.13).

31 de Octubre de 2012
Revocaciones. Apoderado: YBERN SALCEDO JULIO;MORALES ARCE SERRANO ALVARO;TEIXEIRA MARTINS JARDIMLURDES MENDES;ARANA PARRA HEDONE;ALVAREZ CONTINENTE SONIA;BODEGO BENEITEZ MARIA JOSE;COELLO DEPORTUGAL MARTIN DE LOS RIOS FATIMA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: YBERN SALCEDO JULIO;MORALES ARCESERRANO ALVARO;TEIXEIRA MARTINS JARDIM LURDES MENDES;ARANA PARRA HEDONE;ALVAREZ CONTINENTESONIA;BODEGO BENEITEZ MARIA JOSE;COELLO DE PORTUGAL FATIMA. Datos registrales. T 27622 , F 64, S 8, H M 167664,I/A 37 (19.10.12).

25 de Mayo de 2012
Revocaciones. Apoderado: PASAMON NAVIO AGUSTINA;MARTIN VALLEJO MYRIAN;PASAMON NAVIO AGUSTINA;YBERNSALCEDO JULIO;MORALES ARCE SERRANO ALVARO;TEIXEIRA MARTINS JARDIM LURDES MENDES;ARANA PARRAHEDONE;PASAMON NAVIO AGUSTINA;BODEGO BENEITEZ MARIA JOSE;ALVAREZ CONTINENTE SONIA. Datos registrales. T27622 , F 63, S 8, H M 167664, I/A 36 (11.05.12).

27 de Abril de 2012
Nombramientos. Apoderado: YBERN SALCEDO JULIO;MORALES ARCE SERRANO ALVARO;TEIXEIRA MARTINS JARDIMLURDES MENDES;ARANA PARRA HEDONE;ALVAREZ CONTINENTE SONIA;BODEGO BENEITEZ MARIA JOSE;COELLO DEPORTUGAL MARTIN DE LOS RIOS FATIMA. Datos registrales. T 27622 , F 62, S 8, H M 167664, I/A 35 (17.04.12).

10 de Noviembre de 2011
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27622 , F 62, S 8, H M 167664, I/A 34 (27.10.11).

08 de Noviembre de 2011
Cambio de domicilio social. C/ SEPULVEDA 17 - 1& PLANTA (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 27622 , F 62, S 8, H M167664, I/A 33 (26.10.11).

21 de Marzo de 2011
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: COFRA HOLDING AG. Datos registrales. T 27622 , F 61, S 8, H M 167664, I/A 31 (9.03.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: VELLANI ANDREW. Nombramientos. Consejero: GEILENKIRCHEN ERIK. Datos registrales. T27622 , F 61, S 8, H M 167664, I/A 32 ( 9.03.11).

08 de Octubre de 2010
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27622 , F 61, S 8, H M 167664, I/A 30 (28.09.10).

26 de Mayo de 2010
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: YBERN SALCEDO JULIO;VELLANI HASSANALI ANDREW S. Nombramientos. Consejero:BRENNINKMEIJER ROLAND HUGO MARIA;BRENNINKMEIJER ALPHONS PAULUS MARIA;VELLANI ANDREW. Presidente:BRENNINKMEIJER ROLAND HUGO MARIA. SecreNoConsj: YBERN SALCEDO JULIO. Modificaciones estatutarias. Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 10570 , F 224, S 8, H M167664, I/A 28 (14.05.10).

Revocaciones. Apoderado: SAENZ AGUT ANA. Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ CONTINENTE SONIA. Datosregistrales. T 10570 , F 225, S 8, H M 167664, I/A 29 (14.05.10).

14 de Octubre de 2009
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 10570 , F 224, S 8, H M 167664, I/A 27 (30.09.09).

24 de Septiembre de 2009
Otros conceptos: SUBSANADA LA FORMA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL APARTADO B, QUE DIOORIGEN A LA INSCRIPCION 25& DE ESTA HOJA SOCIAL. Datos registrales. T 10570 , F 224, S 8, H M 167664, I/A 26 (14.09.09).

21 de Mayo de 2009
Nombramientos. Apoderado: YBERN SALCEDO JULIO;MORALES ARCE SERRANO ALVARO;TEIXEIRA MARTINS JARDIMLURDES MENDES;ARANA PARRA HEDONE;SAENZ AGUT ANA;PASAMON NAVIO AGUSTINA;BODEGO BENEITEZ MARIA JOSE.Datos registrales. T 10570 , F 223, S 8, H M 167664, I/A 25 ( 8.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n