Actos BORME de Cogeneradora Burgalesa Sl
15 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 753, L 544, F 222, S 8, H BU 5365, I/A 31 ( 9.12.22).
12 de Septiembre de 2022Ceses/Dimisiones. Presidente: SAMPOL MASSANET MARIA DEL CARMEN. Vicepresid.: TAPIADOR FARELO BENITO. Consejero:CAMPOFRIO FOOD GROUP SA;SAMPOL MASSANET MARIA DEL CARMEN;SAMPOL MASSANET FERNANDO;TAPIADORFARELO BENITO. Secretario: SAMPOL MASSANET FERNANDO. Nombramientos. Consejero: SAMPOL MASSANET MARIA DELCARMEN;SAMPOL MASSANET FERNANDO;TAPIADOR FARELO BENITO;CAMPOFRIO FOOD GROUP SA. Datos registrales. T753, L 544, F 221, S 8, H BU 5365, I/A 29 ( 6.09.22).
Nombramientos. Presidente: SAMPOL MASSANET MARIA DEL CARMEN. Secretario: SAMPOL MASSANET FERNANDO. Datosregistrales. T 753, L 544, F 221, S 8, H BU 5365, I/A 30 ( 6.09.22).
05 de Enero de 2022Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 753, L 544, F 220, S 8, H BU 5365, I/A 28 (30.12.21).
11 de Marzo de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 753, L 544, F 220, S 8, H BU 5365, I/A 26 ( 5.03.21).
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 753, L 544, F 220, S 8, H BU 5365, I/A 27 ( 5.03.21).
14 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: SAMPOL MASSANET JUAN CARLOS. Datos registrales. T 753, L 544, F 219, S 8, H BU 5365, I/A 25( 7.08.20).
16 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ARRU脩ADA PARDO MARIA. Nombramientos. Secretario: SAMPOL MASSANET FERNANDO.Datos registrales. T 753, L 544, F 219, S 8, H BU 5365, I/A 24 ( 9.10.19).
02 de Abril de 2019Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 753, L 544, F 219, S 8, H BU 5365, I/A 22 (27.03.19).
29 de Enero de 2019Nombramientos. Apoderado: VICENS MARQUEZ JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 744, L 535, F 151, S 8, H BU 5365, I/A 21(23.01.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: SAMPOL MASSANET JUAN CARLOS;SAMPOL MASSANET MARIA DEL CARMEN. Datos registrales.T 744, L 535, F 153, S 8, H BU 5365, I/A 22 (23.01.19).
22 de Mayo de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.949,39 Euros. Resultante Suscrito: 35.000,00 Euros. Datos registrales. T 744, L 535, F 151, S 8,H BU 5365, I/A 20 (16.05.18).
14 de Febrero de 2018Reelecciones. Consejero: SAMPOL MASSANET MARIA DEL CARMEN;SAMPOL MASSANET FERNANDO;TAPIADOR FARELOBENITO Datos registrales. T 663, L 454, F 100, S 8, H BU 5365, I/A 18 ( 7.02.18).
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 663, L 454, F 100, S 8, H BU 5365, I/A 19 ( 7.02.18).
19 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: DE LA ROSA MU脩OZ FRANCISCO MANUEL. Datos registrales. T 663, L 454, F 100, S 8, H BU 5365, I/A17 (13.12.16).
28 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PINEDO GARCIA ALBERTO. Nombramientos. SecreNoConsj: ARRU脩ADA PARDO MARIA.Datos registrales. T 663, L 454, F 99, S 8, H BU 5365, I/A 15 (21.07.16).
Reelecciones. Consejero: CAMPOFRIO FOOD GROUP SA. Datos registrales. T 663, L 454, F 99, S 8, H BU 5365, I/A 16(21.07.16).
02 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BELY EMMANUELLE. Nombramientos. SecreNoConsj: PINEDO GARCIA ALBERTO. Datosregistrales. T 663, L 454, F 98, S 8, H BU 5365, I/A 11 (27.10.15).
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 663, L 454, F 98, S 8, H BU 5365, I/A 12 (27.10.15).
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 663, L 454, F 99, S 8, H BU 5365, I/A 13 (27.10.15).
11 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Secretario: SANFELIZ MEZQUITA ALFREDO. Nombramientos. SecreNoConsj: BELY EMMANUELLE. Datosregistrales. T 663, L 454, F 98, S 8, H BU 5365, I/A 10 ( 5.06.14).
22 de Abril de 2013Reelecciones. Consejero: SAMPOL MASSANET MARIA DEL CARMEN;SAMPOL MASSANET FERNANDO;TAPIADOR FARELOBENITO Datos registrales. T 362, L 153, F 127, S 8, H BU 5365, I/A 9 (16.04.13).
17 de Septiembre de 2010Reelecciones. Consejero: CAMPOFRIO FOOD GROUP SA. Secretario: SANFELIZ MEZQUITA ALFREDO. Datos registrales. T362, L 153, F 127, S 8, H BU 5365, I/A 8 ( 8.09.10).