Buscador CIF Logo

Actos BORME Cointasados Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cointasados Sl

Actos BORME Cointasados Sl - B08196073

Tenemos registrados 50 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Cointasados Sl con CIF B08196073

馃敊 Perfil de Cointasados Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Cointasados Sl

30 de Noviembre de 2022
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 45385 , F 17, S 8, H B 75554, I/A 97 (22.11.22).

04 de Febrero de 2020
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 45385 , F 17, S 8, H B 75554, I/A 96 (27.01.20).

05 de Agosto de 2019
Nombramientos. APODERAD.SOL: PUIG ROIG MIQUEL. Datos registrales. T 45385 , F 16, S 8, H B 75554, I/A 95 (29.07.19).

31 de Julio de 2019
Revocaciones. APODERADO: GOMEZ CABRERA NAYLA. APODERAD.SOL: GOMEZ CABRERA NAYLA. Datos registrales. T45385 , F 16, S 8, H B 75554, I/A 94 (23.07.19).

19 de Febrero de 2019
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 45385 , F16, S 8, H B 75554, I/A 93 (12.02.19).

28 de Noviembre de 2018
Nombramientos. AUDIT.INDIV.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 45385 , F 15, S 8, H B 75554, I/A 92 (20.11.18).

14 de Diciembre de 2017
Nombramientos. AUDIT.INDIV.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 45385 , F 15, S 8, H B 75554, I/A 91 ( 1.12.17).

15 de Noviembre de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: JOVAL PALACIN ANNA;FERNANDEZ VALVERDE MONTSERRAT;GOMEZ CABRERANAYLA;GRANADOS PEREZ ICIAR;ARCONADA PUERTAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 45385 , F 15, S 8, H B 75554, I/A 90 (6.11.17).

03 de Julio de 2017
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: ARROYO LUCENA ANA MARIA. Datos registrales. T 45385 , F 13, S 8, H B 75554, I/A 89(26.06.17).

17 de Mayo de 2017
Otros conceptos: RECTIFICADO EL DNI DEL APODERADO DON SERGIO PARRA VEGA EN LAINSCRIPCION 87. Datosregistrales. T 45385 , F 12, S 8, H B 75554, I/A 87 ( 8.05.17).

Revocaciones. APODERADO: JARDI ORTOLA JAVIER;CUADRADO GARRETA ANGELES;FERRERUELA MONTES VICTORMANUEL. Datos registrales. T 45385 , F 13, S 8, H B 75554, I/A 88 ( 8.05.17).

29 de Diciembre de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 45385 , F 12, S 8, H B 75554, I/A 86 (21.12.16).

02 de Agosto de 2016
Revocaciones. APOD.SOL/MAN: MARQUEZ GOMEZ JUAN MANUEL;RODRIGUEZ SANTA CRUZ BENITO. Datos registrales. T45385 , F 11, S 8, H B 75554, I/A 83 (22.07.16).

Revocaciones. APODERADO: MAJO FERNANDEZ DANIEL;SANCHEZ GARCIA ROBERTO. Datos registrales. T 45385 , F 11, S8, H B 75554, I/A 84 (22.07.16).

Nombramientos. APOD.SOL/MAN: TRILLA MOYA XAVIER. Datos registrales. T 45385 , F 11, S 8, H B 75554, I/A 85 (22.07.16).

08 de Junio de 2016
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: PARRA VEGA SERGIO. Datos registrales. T 42553 , F 189, S 8, H B 75554, I/A 82 (31.05.16).

03 de Febrero de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 42553 , F 189, S 8, H B 75554, I/A 81 (27.01.16).

23 de Septiembre de 2015
Revocaciones. APODERADO: CARBONELL MARCET BENITO. Datos registrales. T 42553 , F 188, S 8, H B 75554, I/A 80(15.09.15).

20 de Febrero de 2015
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 114.093.729,23 Euros. Resultante Suscrito: 700.028,82 Euros. Otros conceptos:DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SIENDO EL SOCIO UNICO "COPCISA PROMO SL". Datos registrales. T 42553 , F 188,S 8, H B 75554, I/A 79 (13.02.15).

23 de Diciembre de 2014
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 42553 , F 188, S 8, H B 75554, I/A 78 (16.12.14).

12 de Diciembre de 2014
Revocaciones. REPR.143 RRM: CARBONELL SANTACANA RAMON. Nombramientos. REPR.143 RRM: CARBONELLSANTACANA ELOI. Datos registrales. T 42553 , F 187, S 8, H B 75554, I/A 76 ( 3.12.14).

Revocaciones. APODERADO: CARBONELL SANTACANA RAMON. Datos registrales. T 42553 , F 187, S 8, H B 75554, I/A 77 (3.12.14).

01 de Agosto de 2014
Revocaciones. APODERADO: MARQUEZ GOMEZ JUAN MANUEL;GALOPA VILARET JOSEP MARIA. Datos registrales. T 42553, F 187, S 8, H B 75554, I/A 75 (25.07.14).

24 de Abril de 2014
Revocaciones. APODERADO: BADRENAS JUNYENT JOSE;CASAJUANA MIRAS ALBERT;SANCHEZ RUIZ ANTONIO. Datosregistrales. T 42553 , F 184, S 8, H B 75554, I/A 72 (15.04.14).

Nombramientos. APOD.SOL/MAN: GALOPA VILARET JOSEP MARIA;MARQUEZ GOMEZ JUAN MANUEL;RODRIGUEZ SANTACRUZ BENITO Datos registrales. T 42553 , F 184, S 8, H B 75554, I/A 73 (15.04.14).

Nombramientos. APOD.SOL/MAN: CULLELL VILARO MARC. Datos registrales. T 42553 , F 186, S 8, H B 75554, I/A 74(15.04.14).

07 de Enero de 2014
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 42553 , F 184, S 8, H B 75554, I/A 71 (24.12.13).

30 de Enero de 2013
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 42553 , F 183, S 8, H B 75554, I/A 70 (22.01.13).

27 de Junio de 2012
Otros conceptos: SE RECTIFICA LA INSCRIPCION 48 EN CUANTO AL DNI DEL APODERADO DON JUAN MANUEL MARQUEZGOMEZ. Datos registrales. T 42553 , F 183, S 8, H B 75554, I/A 69 (13.06.12).

19 de Abril de 2012
Revocaciones. APODERADO: HUGO PUGLISI;PALOUZIE SARRAT JOSE FELIX;ABASCAL ROVIRA LORENZO;PERETOCARMONA DANIEL;ALFONSO LAZARO JOSE ANTONIO;MAIXENCHS CORBILLO AGATA. Datos registrales. T 42553 , F 183, S 8,H B 75554, I/A 68 ( 2.04.12).

02 de Abril de 2012
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 42553 , F 181, S 8, H B 75554, I/A 66 (19.03.12).

Nombramientos. APODERADO: SANCHEZ GARCIA ROBERTO. Datos registrales. T 42553 , F 182, S 8, H B 75554, I/A 67(19.03.12).

09 de Mayo de 2011
Revocaciones. REPR.143 RRM: CARBONELL MARCET BENITO. Nombramientos. REPR.143 RRM: CARBONELL SANTACANARAMON. Datos registrales. T 41975 , F 120, S 8, H B 75554, I/A 63 (20.04.11).

Revocaciones. APODERADO: GARCIA BERZOSA MANUEL. Datos registrales. T 41975 , F 120, S 8, H B 75554, I/A 64 (20.04.11).

Nombramientos. APODERADO: FERRERUELA MONTES VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 41975 , F 120, S 8, H B 75554,I/A 65 (20.04.11).

28 de Marzo de 2011
Nombramientos. APODERADO: MAJO FERNANDEZ DANIEL;GOMEZ CABRERA NAYLA. Datos registrales. T 41975 , F 118, S 8,H B 75554, I/A 62 (16.03.11).

17 de Marzo de 2011
Nombramientos. APODERADO: JARDI ORTOLA JAVIER;CUADRADO GARRETA ANGELES. Datos registrales. T 41975 , F 118,S 8, H B 75554, I/A 61 ( 4.03.11).

17 de Febrero de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 41975 , F 118, S 8, H B 75554, I/A 60 ( 1.02.11).

12 de Enero de 2011
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: CUPLUNG SL. CERDANYA GOLF RESORT SA. TRANSTERRA SL.EXPLOTACIONES TERRITORIALES Y URBANAS SL. INMOBILIARIA BELLOTS SA. SARRIA PARC SL. COPCISA GEST SL.LLARCA SL. LARIG SL. INMOFISA SL. COPCISA BITUSI SL. COPCISA EXPRESS SL. GESTINMO EXPRESS SL. JUNQUET SA.INFINAN EXPRESS SL. ENEX TELECOM SL. Datos registrales. T 41843 , F 189, S 8, H B 75554, I/A 59 (29.12.10).

18 de Noviembre de 2010
Revocaciones. APODERADO: BELLAFONT ALVARO LUIS. Datos registrales. T 41843 , F 189, S 8, H B 75554, I/A 58 ( 5.11.10).

11 de Noviembre de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 28.207.540,36 Euros. Resultante Suscrito: 114.793.758,05 Euros. Datos registrales. T 41843 , F188, S 8, H B 75554, I/A 57 (28.10.10).

02 de Noviembre de 2010
Nombramientos. APODERADO: SANCHEZ RUIZ ANTONIO. Datos registrales. T 41843 , F 185, S 8, H B 75554, I/A 56 (20.10.10).

13 de Julio de 2010
Revocaciones. APODERADO: CARBONELL TARRES JOSE;LLENA NICOLAU JUAN CARLOS. Datos registrales. T 41843 , F 185,S 8, H B 75554, I/A 55 ( 1.07.10).

25 de Junio de 2010
Nombramientos. APODERADO: CASAJUANA MIRAS ALBERT. Datos registrales. T 41843 , F 182, S 8, H B 75554, I/A 54(14.06.10).

10 de Mayo de 2010
Nombramientos. APODERADO: CARBONELL SANTACANA RAMON;CARBONELL SANTACANA ELOI. Datos registrales. T39056 , F 78, S 8, H B 75554, I/A 52 (27.04.10).

Revocaciones. APODERADO: CARBONELL TARRES JOSE. Datos registrales. T 41843 , F 182, S 8, H B 75554, I/A 53 (27.04.10).

28 de Abril de 2010
Revocaciones. REPR.143 RRM: CARBONELL TARRES JOSEP. Nombramientos. REPR.143 RRM: CARBONELL MARCETBENITO. Datos registrales. T 39056 , F 78, S 8, H B 75554, I/A 51 (15.04.10).

Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39056 , F 77, S 8, H B 75554, I/A 50 (15.04.10).

08 de Febrero de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 625.653,58 Euros. Resultante Suscrito: 86.586.217,69 Euros. Datos registrales. T 39056 , F 76, S 8,H B 75554, I/A 49 (27.01.10).

31 de Diciembre de 2009
Nombramientos. APODERADO: MARQUEZ GOMEZ JUAN MANUEL;GALOPA VILARET JOSEP MARIA. Datos registrales. T39056 , F 74, S 8, H B 75554, I/A 48 (17.12.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n