Buscador CIF Logo

Actos BORME Colegio Antamira Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Colegio Antamira Sl

Actos BORME Colegio Antamira Sl - B85696391

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Colegio Antamira Sl con CIF B85696391

馃敊 Perfil de Colegio Antamira Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Colegio Antamira Sl

08 de Mayo de 2023
Reelecciones. Auditor: EUDITA PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL. Datos registrales. T 42956 , F 218, S 8, H M 480819,I/A 22 (27.04.23).

20 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: MAESTROS Y EDUCADORES ANTAMIRA SL;ABARCA CIDON ALEJANDRO;MADRUGA RAELCARLOS;ALMA TERRA MATER SL;BELTRAN GAMIR RAFAEL BJORN. Presidente: ABARCA CIDON ALEJANDRO. Secretario:MADRUGA RAEL CARLOS. Co.De.Ma.So: ABARCA CIDON ALEJANDRO;MADRUGA RAEL CARLOS. Consejero: GESTION DECENTROS EDUCATIVOS SL. Representan: LOPEZ VELASCO LUIS;ABARCA CIDON ELENA;MADRUGA RAEL CARLOS.Nombramientos. Adm. Mancom.: ABARCA CIDON ALEJANDRO;MADRUGA RAEL CARLOS. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 26680 , F 218, S 8, HM 480819, I/A 20 (11.04.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: ABARCA CIDON ALEJANDRO;MADRUGA RAEL CARLOS. Datos registrales. T 26680 , F 219, S 8, HM 480819, I/A 21 (11.04.22).

06 de Abril de 2022
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: EDUCARE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS SL. Datos registrales. T26680 , F 218, S 8, H M 480819, I/A 19 (30.03.22).

07 de Julio de 2021
Otros conceptos: Se ampl铆an las facultades solidarias de los Consejeros Delegados DON CARLOS MADRUGA RAEL y DONALEJANDRO ABARCA CIDON otorgadas en la inscripci贸n 12陋 de la hoja de la sociedad. Datos registrales. T 26680 , F 217, S 8, HM 480819, I/A 18 (30.06.21).

22 de Junio de 2021
Nombramientos. Auditor: EUDITA PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL. Datos registrales. T 26680 , F 216, S 8, H M480819, I/A 17 (15.06.21).

24 de Junio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: PARTICIPACIONES PROYECTOS INMOBILIARIOS SL. Representan: MADRUGA RAEL CARLOS.Nombramientos. Consejero: GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS SL. Representan: MADRUGA RAEL CARLOS. Datosregistrales. T 26680 , F 216, S 8, H M 480819, I/A 16 (17.06.20).

30 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA CORDERO CELIS GERMAN LUIS. Revocaciones. Apoderado: GARCIA CORDEROCELIS GERMAN LUIS. Nombramientos. Representan: MADRUGA RAEL CARLOS. Consejero: PARTICIPACIONES EDUCATIVASSL. Datos registrales. T 26680 , F 215, S 8, H M 480819, I/A 14 (20.12.19).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GUTIERREZ ANGEL. Datos registrales. T 26680 , F 215, S 8, H M 480819, I/A 15(20.12.19).

18 de Noviembre de 2019
Ampliaci贸n de capital. Capital: 60.008,00 Euros. Resultante Suscrito: 75.010,00 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedadesabsorbidas: ANTAMIRA PATRIMONIO SL. Datos registrales. T 26680 , F 212, S 8, H M 480819, I/A 13 (11.11.19).

08 de Agosto de 2018
Otros conceptos: MODIFICACION DE LAS CONDICIONES DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DELEGADAS EN LOSCONSEJEROS DELEGADOS DON ALEJANDRO ABARCA CIDON Y DON CARLOS MADRUGA RAEL. Datos registrales. T 26680 ,F 211, S 8, H M 480819, I/A 12 (31.07.18).

04 de Junio de 2018
Revocaciones. Apoderado: GARCIA CORDERO CELIS GERMAN LUIS;LAGO CASTRILLON BRUNO. Nombramientos.Apoderado: GARCIA CORDERO CELIS GERMAN LUIS. Datos registrales. T 26680 , F 210, S 8, H M 480819, I/A 11 (28.05.18).

31 de Mayo de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: LAGO CASTRILLON BRUNO;ESPINAR GALLEGO RAMON. Cons.Del.Man: LAGO CASTRILLONBRUNO;GARCIA CORDERO CELIS GERMAN. Consejero: GERVAS HIERRO ANA. Presidente: GERVAS HIERRO ANA. Secretario:ESPINAR GALLEGO RAMON. Nombramientos. Representan: ABARCA CIDON ELENA. Consejero: ABARCA CIDONALEJANDRO;MADRUGA RAEL CARLOS;ALMA TERRA MATER SL;BELTRAN GAMIR RAFAEL BJORN. Presidente: ABARCACIDON ALEJANDRO. Secretario: MADRUGA RAEL CARLOS. Co.De.Ma.So: ABARCA CIDON ALEJANDRO;MADRUGA RAELCARLOS. Cambio de domicilio social. C/ PIAMONTE 19 - URBANIZACION PARQUELAGOS LA NAVAT (GALAPAGAR). Datosregistrales. T 26680 , F 209, S 8, H M 480819, I/A 10 (24.05.18).

22 de Marzo de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: PARRA ALVAREZ MARIA DEL PUY. Nombramientos. Consejero: MAESTROS Y EDUCADORESANTAMIRA SL. Representan: LOPEZ VELASCO LUIS. Datos registrales. T 26680 , F 101, S 8, H M 480819, I/A 9 (14.03.13).

22 de Agosto de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ ANTON MARIA BEGO脩A. Nombramientos. Consejero: PARRA ALVAREZ MARIA DELPUY. Datos registrales. T 26680 , F 101, S 8, H M 480819, I/A 8 ( 9.08.11).

21 de Julio de 2011
Ceses/Dimisiones. Presidente: ESPINAR GALLEGO RAMON. Secretario: GARCIA CORDERO CELIS GERMAN LUIS.Nombramientos. Presidente: GERVAS HIERRO ANA. Secretario: ESPINAR GALLEGO RAMON. Datos registrales. T 26680 , F101, S 8, H M 480819, I/A 7 (12.07.11).

24 de Diciembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA-CORDERO CELIS JUAN CARLOS. Nombramientos. Consejero: GERVAS HIERRO ANA.Datos registrales. T 26680 , F 100, S 8, H M 480819, I/A 6 (11.12.09).

06 de Noviembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GARCIA CORDERO CELIS GERMAN LUIS. Nombramientos. Consejero: LAGO CASTRILLONBRUNO;ESPINAR GALLEGO RAMON;GARCIA-CORDERO CELIS JUAN CARLOS;GARCIA CORDERO CELIS GERMANLUIS;GONZALEZ ANTON MARIA BEGO脩A. Presidente: ESPINAR GALLEGO RAMON. Secretario: GARCIA CORDERO CELISGERMAN LUIS. Apoderado: GARCIA CORDERO CELIS GERMAN LUIS;LAGO CASTRILLON BRUNO. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n.Modificados y refundidos losestatutos sociales como consecuencia del cambio de Organo de Administraci贸n.. Datos registrales. T 26680 , F 98, S 8, H M 480819,I/A 4 (26.10.09).

Nombramientos. Cons.Del.Man: LAGO CASTRILLON BRUNO;GARCIA CORDERO CELIS GERMAN. Datos registrales. T 26680 ,F 100, S 8, H M 480819, I/A 5 (27.10.09).

18 de Septiembre de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 8.990,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.996,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.006,00Euros. Resultante Suscrito: 15.002,00 Euros. Datos registrales. T 26680 , F 96, S 8, H M 480819, I/A 3 ( 9.09.09).

16 de Septiembre de 2009
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 1&, EL COMIENZO DE OPERACIONES DE LA SOCIEDAD,SIENDO EL CORRECTO EL 8 DE MAYO DE 2009. Datos registrales. T 26680 , F 95, S 8, H M 480819, I/A 1 (21.05.09).

05 de Junio de 2009
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 8.03.09. Objeto social: Promoci贸n y gesti贸n de centros docentes p煤blicos y privados.Domicilio: C/ FORTUNY 37 2潞 - DERECHA (MADRID). Capital: 3.006,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: GARCIA CORDEROCELIS GERMAN LUIS. Datos registrales. T 26680 , F 95, S 8, H M 480819, I/A 1 (21.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n