Actos BORME de Colegio Bilingue Vallmont Sl
18 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ MARTIN OSCAR JACOBO. Cons.Del.Man: GONZALEZ MARTIN OSCAR JACOBO.Presidente: GONZALEZ MARTIN OSCAR JACOBO. Consejero: GARCIA GUERRA JUAN MANUEL. Secretario: GARCIA GUERRAJUAN MANUEL. Consejero: DOMINGUEZ VEGA YOLANDA. Cons.Del.Man: DOMINGUEZ VEGA YOLANDA;GARCIA GUERRA JUANMANUEL. Nombramientos. Consejero: JURADO DELGADO ANDRES GERMAN. Presidente: BOTIJA MINGUEZ JULIO. Secretario:JURADO DELGADO ANDRES GERMAN. Cons.Del.Man: PRIETO ARROYO JOSE LUIS;JURADO DELGADO ANDRES GERMAN.Reelecciones. Cons.Del.Man: BOTIJA MINGUEZ JULIO. Datos registrales. T 36625 , F 23, S 8, H M 320419, I/A 26 (10.10.23).
14 de Abril de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: IDURIAGA CARBONERO RUBEN. Presidente: IDURIAGA CARBONERO RUBEN. Cons.Del.Man:IDURIAGA CARBONERO RUBEN. Nombramientos. Consejero: PRIETO ARROYO JOSE LUIS. Presidente: GONZALEZ MARTINOSCAR JACOBO. Datos registrales. T 36625 , F 22, S 8, H M 320419, I/A 25 ( 5.04.23).
06 de Abril de 2022Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 8潞 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 36625 , F 21, S 8, H M 320419,I/A 24 (30.03.22).
26 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: PRADOS DIAZ ALEJANDRO JESUS. Cons.Del.Man: PRADOS DIAZ ALEJANDRO JESUS.Nombramientos. Consejero: DOMINGUEZ VEGA YOLANDA. Cons.Del.Man: DOMINGUEZ VEGA YOLANDA. Reelecciones.
31 de Marzo de 2021Reelecciones. Auditor: EUDITA PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL. Datos registrales. T 36625 , F 20, S 8, H M 320419, I/A22 (24.03.21).
20 de Diciembre de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.209,24 Euros. Resultante Suscrito: 99.415,80 Euros. Datos registrales. T 36625 , F 20,S 8, H M 320419, I/A 21 (13.12.19).
28 de Noviembre de 2017Reelecciones. Auditor: EUDITA PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL. Datos registrales. T 32074 , F 87, S 8, H M 320419, I/A20 (20.11.17).
26 de Junio de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ PALACIO JOSE LUIS. Cons.Del.Man: MARTINEZ PALACIO JOSE LUIS.Nombramientos. Consejero: BOTIJA MINGUEZ JULIO. Apoderado: MARTINEZ PALACIO JOSE LUIS. Cons.Del.Man: PRADOSDIAZ ALEJANDRO JESUS;BOTIJA MINGUEZ JULIO;GARCIA GUERRA JUAN MANUEL. Reelecciones. Cons.Del.Man: IDURIAGACARBONERO RUBEN;GONZALEZ MARTIN OSCAR JACOBO. Datos registrales. T 32074 , F 86, S 8, H M 320419, I/A 19(15.06.17).
03 de Marzo de 2017Modificaciones estatutarias. MODIFICACION ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES por modificaci贸n del valor nominal delas participaciones sociales y, consecuentemente, el n煤mero de participaciones que representan el capital social, que pasa a estarconstituido por 46 participaciones, de 2.209, 24 euros de valor nominal cada una. Datos registrales. T 32074 , F 85, S 8, H M 320419,I/A 18 (22.02.17).
19 de Febrero de 2015Reelecciones. Auditor: EUDITA PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL. Datos registrales. T 32074 , F 85, S 8, H M 320419, I/A17 (10.02.15).
12 de Febrero de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.208.034,96 Euros. Resultante Suscrito: 101.625,04 Euros. Datos registrales. T 32074 ,F 83, S 8, H M 320419, I/A 16 ( 4.02.15).
11 de Diciembre de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 230.966,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.309.660,00 Euros. Datos registrales. T 32074 ,F 81, S 8, H M 320419, I/A 15 ( 2.12.14).
16 de Abril de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 230.966,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.540.626,00 Euros. Datos registrales. T 21291 ,F 224, S 8, H M 320419, I/A 14 ( 8.04.14).
15 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MINGUEZ TOBA PABLO. Secretario: MINGUEZ TOBA PABLO. Nombramientos. Consejero:GARCIA GUERRA JUAN MANUEL. Secretario: GARCIA GUERRA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 21291 , F 224, S 8, H M320419, I/A 13 ( 7.04.14).
19 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: VEGA GONZALEZ TERESA. Cons.Del.Man: VEGA GONZALEZ TERESA. Nombramientos.Consejero: GONZALEZ MARTIN OSCAR JACOBO. Cons.Del.Man: GONZALEZ MARTIN OSCAR JACOBO. Datos registrales. T21291 , F 223, S 8, H M 320419, I/A 12 (10.06.13).
11 de Octubre de 2011Nombramientos. Auditor: PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL. Datos registrales. T 21291 , F 223, S 8, H M 320419, I/A 11(27.09.11).
24 de Diciembre de 2010Otros conceptos: SUBSANACION DE LOS ACUERDOS SEGUNDO Y TERCERO ADOPTADOS PORLA JUNTA DE 2 DEDICIEMBRE DE 2006 ELEVADOS A PUBLICO MEDIANTE ESCRITURA AUTORIZADA POR EL NOTARIO DE NAVALCARNERO,DONJOSE ANTONIO GARCIA-NOBLEJAS SANTA OLALLA,EL DIA 24 DE ENERO DE 2007, NUM 277 DE PROTOCOLO, QUECAUSO LA INSCRIPCION 7&. Datos registrales. T 21291 , F 222, S 8, H M 320419, I/A 10 (14.12.10).
08 de Mayo de 2009Nombramientos. Auditor: PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL. Datos registrales. T 21291 , F 222, S 8, H M 320419, I/A 9(27.04.09).