Buscador CIF Logo

Actos BORME Colegio Guadalaviar Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Colegio Guadalaviar Sa

Actos BORME Colegio Guadalaviar Sa - A46079653

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Colegio Guadalaviar Sa con CIF A46079653

馃敊 Perfil de Colegio Guadalaviar Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Colegio Guadalaviar Sa

01 de Marzo de 2021
Reelecciones. Consejero: CARRE脩O FERNANDEZ IGNACIO. Vicepresid.: CARRE脩O FERNANDEZ IGNACIO. Datos registrales.T 7097, L 4400, F 184, S 8, H V 20879, I/A 43 (22.02.21).

14 de Mayo de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEYRO GREGORI LORETO. Nombramientos. Consejero: PERIS SIRVENT ROSA MARIA.Reelecciones. Consejero: PARRA CAMPOS I脩IGO DOMINGO. Presidente: PARRA CAMPOS I脩IGO DOMINGO. Consejero:BOLINCHES DE LA PE脩A MARIA JESUS. Datos registrales. T 7097, L 4400, F 184, S 8, H V 20879, I/A 42 ( 6.05.20).

26 de Febrero de 2019
Nombramientos. Vicepresid.: CARRE脩O FERNANDEZ IGNACIO. Datos registrales. T 7097, L 4400, F 183, S 8, H V 20879, I/A 40(19.02.19).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GALDON SALVADOR PAULA. Secretario: GALDON SALVADOR PAULA. Nombramientos.Consejero: CALVO HERNAN PILAR. Secretario: CALVO HERNAN PILAR. Datos registrales. T 7097, L 4400, F 183, S 8, H V 20879,I/A 41 (19.02.19).

20 de Abril de 2018
Nombramientos. Consejero: CARRE脩O FERNANDEZ IGNACIO. Fe de erratas: Por error no se public贸 en el Bolet铆n 214 de fecha10/11/16 y referencia 04512502016 el nombramiento de D. Ignacio Carre帽o Fern谩ndez como Consejero. Datos registrales. T 7097, L4400, F 183, S 8, H V 20879, I/A 38 ( 2.11.16).

Revocaciones. Apo.Manc.: VALDES MAS CARMEN MARIA. Nombramientos. Apo.Manc.: COZAR SANTIAGO SONSOLES.Datos registrales. T 7097, L 4400, F 183, S 8, H V 20879, I/A 39 (13.04.18).

10 de Noviembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: CONESA GARCIA MARIA PILAR. Vicepresid.: CONESA GARCIA MARIA PILAR. Datos registrales.T 7097, L 4400, F 183, S 8, H V 20879, I/A 38 ( 2.11.16).

14 de Octubre de 2016
Fe de erratas: Por error en el BORME 113 de 14/06/2001, ref.02423052001 se omiti贸 la publicaci贸n de la revocaci贸n de los poderesde DO脩A BEGO脩A MOMPARLER PECHUAN, objeto de la inscrip. 18陋. Datos registrales. T 4239, L 1551, F 11, S 8, H V 20879, I/A21 ( 1.06.01).

Revocaciones. Apo.Manc.: ALAMO RAMIREZ FERNANDO;ALONSO STUICK RAFAELA;SERNA FORTEA MARIA PILAR. Apo.Sol.:SERNA FORTEA MARIA PILAR. Apoderado: VALDES MAS CARMEN MARIA. Apo.Manc.: BOLINCHES DE LA PE脩A MARIAJESUS;GONZALEZ GARGALLO DESAMPARADOS;CARVAJAL VALCARCEL MARIA JOSE. Apoderado: CARVAJAL VALCARCELMARIA JOSE. Apo.Manc.: VALDES MAS CARMEN MARIA. Apo.Sol.: BOLINCHES DE LA PE脩A MARIA JESUS;GONZALEZGARGALLO DESAMPARADOS. Nombramientos. Apo.Manc.: BOLINCHES DE LA PE脩A MARIA JESUS;GONZALEZ GARGALLODESAMPARADOS;CARVAJAL VALCARCEL MARIA JOSE;VALDES MAS CARMEN MARIA. Datos registrales. T 4239, L 1551, F17, S 8, H V 20879, I/A 37 ( 6.10.16).

22 de Enero de 2016
Cambio de domicilio social. AVDA BLASCO IBA脩EZ 56 (VALENCIA). Fe de erratas: El domicilio correcto de la mercantil es:Avenida Blasco Iba帽ez N潞 56 46021 (Valencia), que por error no se public贸 en el Bolet铆n 166 de fecha 01/09/15 y referencia03580502015. Datos registrales. T 4239, L 1551, F 16, S 8, H V 20879, I/A 36 (25.08.15).

01 de Septiembre de 2015
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/8. Otros conceptos: Se ha procedido a la refundici贸n de losestatutos sociales. Datos registrales. T 4239, L 1551, F 16, S 8, H V 20879, I/A 36 (25.08.15).

04 de Marzo de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALAMO RAMIREZ FERNANDO;MARTINEZ LOZANO JOSE ENRIQUE. Presidente: ALAMORAMIREZ FERNANDO. Vicepresid.: MARTINEZ LOZANO JOSE ENRIQUE. Secretario: GALDON SALVADOR PAULA.Nombramientos. Consejero: PARRA CAMPOS I脩IGO DOMINGO;PEYRO GREGORI LORETO. Presidente: PARRA CAMPOS I脩IGODOMINGO. Vicepresid.: CONESA GARCIA MARIA PILAR. Secretario: GALDON SALVADOR PAULA. Reelecciones. Consejero:CONESA GARCIA MARIA PILAR;BOLINCHES DE LA PE脩A MARIA JESUS;GALDON SALVADOR PAULA Datos registrales. T4239, L 1551, F 16, S 8, H V 20879, I/A 35 (25.02.15).

02 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Consejero: ALAMO RAMIREZ FERNANDO. Presidente: ALAMO RAMIREZ FERNANDO. Consejero: CONESAGARCIA MARIA PILAR;MARTINEZ LOZANO JOSE ENRIQUE. Vicepresid.: MARTINEZ LOZANO JOSE ENRIQUE. Reelecciones.Consejero: BOLINCHES DE LA PE脩A MARIA JESUS;GALDON SALVADOR PAULA. Secretario: GALDON SALVADOR PAULA.Datos registrales. T 4239, L 1551, F 15, S 8, H V 20879, I/A 33 (23.10.12).

Revocaciones. Apo.Manc.: CORREA BALLESTER MARIA DEL CARMEN. Apo.Sol.: CORREA BALLESTER MARIA DEL CARMEN.Nombramientos. Apo.Manc.: CARVAJAL VALCARCEL MARIA JOSE. Apoderado: CARVAJAL VALCARCEL MARIA JOSE. Datosregistrales. T 4239, L 1551, F 15, S 8, H V 20879, I/A 34 (23.10.12).

12 de Junio de 2012
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ALAMO RAMIREZ FERNANDO. Presidente: ALAMO RAMIREZFERNANDO. Consejero: MARTINEZ LOZANO JOSE ENRIQUE. Vicepresid.: MARTINEZ LOZANO JOSE ENRIQUE. Consejero:CONESA GARCIA MARIA PILAR. Datos registrales. T 4239, L 1551, F 13, S 8, H V 20879, I/A 27 M (31.05.12).

19 de Octubre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO STUYCK RAFAELA. Secretario: ALONSO STUYCK RAFAELA. Consejero: PITARCH TENAMARIA LUZ. Nombramientos. Consejero: BOLINCHES DE LA PE脩A MARIA JESUS. Secretario: GALDON SALVADOR PAULA.Datos registrales. T 4239, L 1551, F 15, S 8, H V 20879, I/A 32 ( 7.10.11).

27 de Julio de 2011
Otros conceptos: A los efectos de lo dispuesto en el Art铆culo 173 LSC, se hace constar que la Sede Electr贸nica de la Sociedad deesta Hoja es la siguiente: www.colegioguadalaviar.es.- Datos registrales. T 4239, L 1551, F 15, S 8, H V 20879, I/A 31 (15.07.11).

15 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: PITARCH TENA MARIA LUZ;BLANCO FERNANDEZ TERESA. Nombramientos. Apo.Manc.:BOLINCHES DE LA PE脩A MARIA JESUS;GONZALEZ GARGALLO DESAMPARADOS. Apo.Sol.: BOLINCHES DE LA PE脩A MARIAJESUS;GONZALEZ GARGALLO DESAMPARADOS. Datos registrales. T 4239, L 1551, F 14, S 8, H V 20879, I/A 30 ( 3.11.10).

13 de Agosto de 2009
Nombramientos. Consejero: GALDON SALVADOR PAULA. Otros conceptos: Determinar que el Organo de Administraci贸n estecompuesto por SEIS CONSEJEROS. Datos registrales. T 4239, L 1551, F 14, S 8, H V 20879, I/A 29 ( 4.08.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n