Actos BORME de Colegio Guadalaviar Sa
01 de Marzo de 2021Reelecciones. Consejero: CARRE脩O FERNANDEZ IGNACIO. Vicepresid.: CARRE脩O FERNANDEZ IGNACIO. Datos registrales.T 7097, L 4400, F 184, S 8, H V 20879, I/A 43 (22.02.21).
14 de Mayo de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: PEYRO GREGORI LORETO. Nombramientos. Consejero: PERIS SIRVENT ROSA MARIA.Reelecciones. Consejero: PARRA CAMPOS I脩IGO DOMINGO. Presidente: PARRA CAMPOS I脩IGO DOMINGO. Consejero:BOLINCHES DE LA PE脩A MARIA JESUS. Datos registrales. T 7097, L 4400, F 184, S 8, H V 20879, I/A 42 ( 6.05.20).
26 de Febrero de 2019Nombramientos. Vicepresid.: CARRE脩O FERNANDEZ IGNACIO. Datos registrales. T 7097, L 4400, F 183, S 8, H V 20879, I/A 40(19.02.19).
Ceses/Dimisiones. Consejero: GALDON SALVADOR PAULA. Secretario: GALDON SALVADOR PAULA. Nombramientos.Consejero: CALVO HERNAN PILAR. Secretario: CALVO HERNAN PILAR. Datos registrales. T 7097, L 4400, F 183, S 8, H V 20879,I/A 41 (19.02.19).
20 de Abril de 2018Nombramientos. Consejero: CARRE脩O FERNANDEZ IGNACIO. Fe de erratas: Por error no se public贸 en el Bolet铆n 214 de fecha10/11/16 y referencia 04512502016 el nombramiento de D. Ignacio Carre帽o Fern谩ndez como Consejero. Datos registrales. T 7097, L4400, F 183, S 8, H V 20879, I/A 38 ( 2.11.16).
Revocaciones. Apo.Manc.: VALDES MAS CARMEN MARIA. Nombramientos. Apo.Manc.: COZAR SANTIAGO SONSOLES.Datos registrales. T 7097, L 4400, F 183, S 8, H V 20879, I/A 39 (13.04.18).
10 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: CONESA GARCIA MARIA PILAR. Vicepresid.: CONESA GARCIA MARIA PILAR. Datos registrales.T 7097, L 4400, F 183, S 8, H V 20879, I/A 38 ( 2.11.16).
14 de Octubre de 2016Fe de erratas: Por error en el BORME 113 de 14/06/2001, ref.02423052001 se omiti贸 la publicaci贸n de la revocaci贸n de los poderesde DO脩A BEGO脩A MOMPARLER PECHUAN, objeto de la inscrip. 18陋. Datos registrales. T 4239, L 1551, F 11, S 8, H V 20879, I/A21 ( 1.06.01).
Revocaciones. Apo.Manc.: ALAMO RAMIREZ FERNANDO;ALONSO STUICK RAFAELA;SERNA FORTEA MARIA PILAR. Apo.Sol.:SERNA FORTEA MARIA PILAR. Apoderado: VALDES MAS CARMEN MARIA. Apo.Manc.: BOLINCHES DE LA PE脩A MARIAJESUS;GONZALEZ GARGALLO DESAMPARADOS;CARVAJAL VALCARCEL MARIA JOSE. Apoderado: CARVAJAL VALCARCELMARIA JOSE. Apo.Manc.: VALDES MAS CARMEN MARIA. Apo.Sol.: BOLINCHES DE LA PE脩A MARIA JESUS;GONZALEZGARGALLO DESAMPARADOS. Nombramientos. Apo.Manc.: BOLINCHES DE LA PE脩A MARIA JESUS;GONZALEZ GARGALLODESAMPARADOS;CARVAJAL VALCARCEL MARIA JOSE;VALDES MAS CARMEN MARIA. Datos registrales. T 4239, L 1551, F17, S 8, H V 20879, I/A 37 ( 6.10.16).
22 de Enero de 2016Cambio de domicilio social. AVDA BLASCO IBA脩EZ 56 (VALENCIA). Fe de erratas: El domicilio correcto de la mercantil es:Avenida Blasco Iba帽ez N潞 56 46021 (Valencia), que por error no se public贸 en el Bolet铆n 166 de fecha 01/09/15 y referencia03580502015. Datos registrales. T 4239, L 1551, F 16, S 8, H V 20879, I/A 36 (25.08.15).
01 de Septiembre de 2015Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/8. Otros conceptos: Se ha procedido a la refundici贸n de losestatutos sociales. Datos registrales. T 4239, L 1551, F 16, S 8, H V 20879, I/A 36 (25.08.15).
04 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ALAMO RAMIREZ FERNANDO;MARTINEZ LOZANO JOSE ENRIQUE. Presidente: ALAMORAMIREZ FERNANDO. Vicepresid.: MARTINEZ LOZANO JOSE ENRIQUE. Secretario: GALDON SALVADOR PAULA.Nombramientos. Consejero: PARRA CAMPOS I脩IGO DOMINGO;PEYRO GREGORI LORETO. Presidente: PARRA CAMPOS I脩IGODOMINGO. Vicepresid.: CONESA GARCIA MARIA PILAR. Secretario: GALDON SALVADOR PAULA. Reelecciones. Consejero:CONESA GARCIA MARIA PILAR;BOLINCHES DE LA PE脩A MARIA JESUS;GALDON SALVADOR PAULA Datos registrales. T4239, L 1551, F 16, S 8, H V 20879, I/A 35 (25.02.15).
02 de Noviembre de 2012Nombramientos. Consejero: ALAMO RAMIREZ FERNANDO. Presidente: ALAMO RAMIREZ FERNANDO. Consejero: CONESAGARCIA MARIA PILAR;MARTINEZ LOZANO JOSE ENRIQUE. Vicepresid.: MARTINEZ LOZANO JOSE ENRIQUE. Reelecciones.Consejero: BOLINCHES DE LA PE脩A MARIA JESUS;GALDON SALVADOR PAULA. Secretario: GALDON SALVADOR PAULA.Datos registrales. T 4239, L 1551, F 15, S 8, H V 20879, I/A 33 (23.10.12).
Revocaciones. Apo.Manc.: CORREA BALLESTER MARIA DEL CARMEN. Apo.Sol.: CORREA BALLESTER MARIA DEL CARMEN.Nombramientos. Apo.Manc.: CARVAJAL VALCARCEL MARIA JOSE. Apoderado: CARVAJAL VALCARCEL MARIA JOSE. Datosregistrales. T 4239, L 1551, F 15, S 8, H V 20879, I/A 34 (23.10.12).
12 de Junio de 2012Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ALAMO RAMIREZ FERNANDO. Presidente: ALAMO RAMIREZFERNANDO. Consejero: MARTINEZ LOZANO JOSE ENRIQUE. Vicepresid.: MARTINEZ LOZANO JOSE ENRIQUE. Consejero:CONESA GARCIA MARIA PILAR. Datos registrales. T 4239, L 1551, F 13, S 8, H V 20879, I/A 27 M (31.05.12).
19 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO STUYCK RAFAELA. Secretario: ALONSO STUYCK RAFAELA. Consejero: PITARCH TENAMARIA LUZ. Nombramientos. Consejero: BOLINCHES DE LA PE脩A MARIA JESUS. Secretario: GALDON SALVADOR PAULA.Datos registrales. T 4239, L 1551, F 15, S 8, H V 20879, I/A 32 ( 7.10.11).
27 de Julio de 2011Otros conceptos: A los efectos de lo dispuesto en el Art铆culo 173 LSC, se hace constar que la Sede Electr贸nica de la Sociedad deesta Hoja es la siguiente: www.colegioguadalaviar.es.- Datos registrales. T 4239, L 1551, F 15, S 8, H V 20879, I/A 31 (15.07.11).
15 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: PITARCH TENA MARIA LUZ;BLANCO FERNANDEZ TERESA. Nombramientos. Apo.Manc.:BOLINCHES DE LA PE脩A MARIA JESUS;GONZALEZ GARGALLO DESAMPARADOS. Apo.Sol.: BOLINCHES DE LA PE脩A MARIAJESUS;GONZALEZ GARGALLO DESAMPARADOS. Datos registrales. T 4239, L 1551, F 14, S 8, H V 20879, I/A 30 ( 3.11.10).
13 de Agosto de 2009Nombramientos. Consejero: GALDON SALVADOR PAULA. Otros conceptos: Determinar que el Organo de Administraci贸n estecompuesto por SEIS CONSEJEROS. Datos registrales. T 4239, L 1551, F 14, S 8, H V 20879, I/A 29 ( 4.08.09).