Actos BORME de Coleman Cbx Branding Sl
01 de Julio de 2022Cambio de domicilio social. CL BADAJOZ NUM.127 NAVES 3 Y 4 (BARCELONA). Datos registrales. T 36103 , F 37, S 8, H B2867, I/A 29 (22.06.22).
02 de Junio de 2021Revocaciones. REPR.143 RRM: MIRABET JULIACHS VICTOR. Nombramientos. REPR.143 RRM: LLORENS LAJARA CONRAD.Datos registrales. T 36103 , F 36, S 8, H B 2867, I/A 27 (25.05.21).
Revocaciones. DTOR.GENERAL: MIRABET JULIACHS VICTOR. Datos registrales. T 36103 , F 36, S 8, H B 2867, I/A 28(25.05.21).
16 de Febrero de 2017Nombramientos. APODERAD.SOL: MATEU NEGRE JORDI. Datos registrales. T 36103 , F 36, S 8, H B 2867, I/A 26 ( 7.02.17).
06 de Febrero de 2017Revocaciones. ADM.UNICO: MIRABET JULIACHS VICTOR. Nombramientos. ADM.UNICO: THE BRAND PARTNERS SL.REPR.143 RRM: MIRABET JULIACHS VICTOR. Cambio de domicilio social. CL ROGER DE LLURIA Num.124 P.8 (BARCELONA).Datos registrales. T 36103 , F 35, S 8, H B 2867, I/A 24 (27.01.17).
Otros conceptos: CAMBIO DE SOCIO UNICO,SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: THE BRAND PARTNERS SL. Datosregistrales. T 36103 , F 36, S 8, H B 2867, I/A 25 (27.01.17).